VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED

VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02939633
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3175 Century Way
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SHAFTON ENGINEERING SERVICES LIMITED11 lug 199411 lug 1994
    SOUNDTEST LIMITED16 giu 199416 giu 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    5 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    resolution

    Risoluzione di capitalizzazione o emissione di azioni bonus

    The sum of £24604 be capitalised 13/07/2023
    RES14

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    resolution

    Risoluzione di capitalizzazione o emissione di azioni bonus

    Capitalise sum of £31564 12/07/2023
    RES14
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Stato del capitale al 14 lug 2023

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 13 lug 2023

    • Capitale: GBP 24,605
    3 pagineSH01

    Stato del capitale al 13 lug 2023

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 12 lug 2023

    • Capitale: GBP 31,565
    3 pagineSH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2022

    5 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Renew Corporate Director Limited il 01 ott 2019

    1 pagineCH02

    Dettagli del segretario cambiati per Renew Nominees Limited il 01 ott 2019

    1 pagineCH04

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2021

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2020

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RENEW NOMINEES LIMITED
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175 Century Way
    England
    Segretario
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175 Century Way
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione02939633
    41291250014
    SCOTT, Paul
    Century Way
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175
    England
    Amministratore
    Century Way
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175
    England
    EnglandBritish63708460003
    WILSON, Gordon Ian
    Century Way
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175
    England
    Amministratore
    Century Way
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175
    England
    United KingdomBritish263424170001
    RENEW CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175 Century Way
    England
    Amministratore
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175 Century Way
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione4843611
    91993060004
    BARKER, Roger Winston
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    British59419910001
    GREASLEY, Antony Frederick
    Padside Hall
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    Padside Hall
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    North Yorkshire
    British69165360001
    LITTLEHALES, Richard
    10 Oaklands Avenue
    Adel
    LS16 8NR Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    10 Oaklands Avenue
    Adel
    LS16 8NR Leeds
    West Yorkshire
    British57288230001
    PARKINSON, John
    Pinewoods Larchwood
    Scarcroft
    LS14 3BN Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Pinewoods Larchwood
    Scarcroft
    LS14 3BN Leeds
    West Yorkshire
    British10307790002
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Segretario nominato
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    BARKER, Roger Winston
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    24 Burn Bridge Oval
    HG3 1LP Harrogate
    North Yorkshire
    British59419910001
    FEAST, Roger
    43 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    Amministratore
    43 Merchant Court
    61 Wapping Wall
    E1W 3SJ London
    British66800550001
    GREASLEY, Antony Frederick
    Padside Hall
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Padside Hall
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish69165360001
    LITTLEHALES, Richard
    Aisling Cottage
    Back Church Lane
    LS16 8DW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Aisling Cottage
    Back Church Lane
    LS16 8DW Leeds
    West Yorkshire
    British57288230002
    MCARTHUR, Alexander Nigel
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Amministratore
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    British1571200002
    PARKINSON, John
    Pinewoods Larchwood
    Scarcroft
    LS14 3BN Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Pinewoods Larchwood
    Scarcroft
    LS14 3BN Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish10307790002
    PEARSON, Valerie
    Phoenix House
    Hawthorn Park
    LS14 1PQ Leeds
    Amministratore
    Phoenix House
    Hawthorn Park
    LS14 1PQ Leeds
    British82999480006
    SAMUEL, John William Young Strachan
    Charnwood Easby Drive
    LS29 9AZ Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Charnwood Easby Drive
    LS29 9AZ Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish3909060002
    STIFF, Stephen
    Century Way
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175
    England
    Amministratore
    Century Way
    Thorpe Park
    LS15 8ZB Leeds
    3175
    England
    United KingdomBritish111161720001
    THOMSON, Brian Malcolm
    Amber Manor Farm
    Alice Head Road Stonedge
    S45 0DQ Ashover
    Derbyshire
    Amministratore
    Amber Manor Farm
    Alice Head Road Stonedge
    S45 0DQ Ashover
    Derbyshire
    British5774340006
    UNDERWOOD, Philip John
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    British59420330011
    WALDRON, Brian Geoffrey
    Fir Tree Cottage 4 Chapel Lane
    Billingley
    S72 0HZ Barnsley
    South Yorkshire
    Amministratore
    Fir Tree Cottage 4 Chapel Lane
    Billingley
    S72 0HZ Barnsley
    South Yorkshire
    GibraltarBritish4324630001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    Chi sono le persone con controllo significativo di VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    Yew Trees
    West Yorkshire
    United Kingdom
    01 ago 2016
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    Yew Trees
    West Yorkshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione1457182
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    VHE EQUIPMENT SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 03 ott 2007
    Consegnato il 19 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 05 gen 2005
    Consegnato il 20 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 02 lug 1996
    Consegnato il 09 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £237,222 and all other sums due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The items set out in the schedule to form 395 together with all accessories spare parts component parts and all improvements and renewals thereof and all books manuals and handbooks.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 09 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 giu 1996
    Consegnato il 13 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land on the east side of engine lane shafton near barnsley south yorks and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 21 set 1995
    Consegnato il 27 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the plant machinery chattels or other equipment listed in the scedule to the form 395 inclusive of kue ken 114 serial no. M819, kue ken 114 serial no. M4820 and kue ken 120 serial no. M4839 together with any parts thereof and all additions and alterations etc. thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 27 set 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 06 lug 1995
    Consegnato il 11 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £584,676 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Various goods including all books manuals handbooks technical date drawings etc belonging to the goods as set out in the schedule to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 11 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 set 1994
    Consegnato il 06 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 set 1994
    Consegnato il 06 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/as shafton workshops, shafton, barnsley, south yorkshire t/no SYK44893.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0