HOME CARE SERVICES (KENT) LIMITED

HOME CARE SERVICES (KENT) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHOME CARE SERVICES (KENT) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02941943
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HOME CARE SERVICES (KENT) LIMITED?

    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova HOME CARE SERVICES (KENT) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di HOME CARE SERVICES (KENT) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per HOME CARE SERVICES (KENT) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 23 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 lug 2012

    Stato del capitale al 03 lug 2012

    • Capitale: GBP 987.5
    SH01

    Cessazione della carica di Angela Culhane come amministratore in data 25 giu 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 set 2011

    17 pagineAA

    Nomina di Jonathan David Calow come segretario in data 08 dic 2011

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Care Uk Services Limited come segretario in data 08 dic 2011

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 23 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    18 pagineAA

    Nomina di Paul John Watson come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Michael Robert Parish il 10 ago 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 23 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Paul Justin Humphreys il 01 giu 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Michael Robert Parish il 01 giu 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Care Uk Services Limited il 01 giu 2010

    2 pagineCH04

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica del Memorandum di Associazione

    RES01

    legacy

    28 pagineMG01

    Bilancio redatto al 30 set 2009

    17 pagineAA

    Nomina di Deborah Jane Marriott-Boam come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Geoffrey Benn come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Douglas Umbers come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Angela Hector Culhane come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di HOME CARE SERVICES (KENT) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CALOW, Jonathan David
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    Segretario
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    165497840001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    Amministratore
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    United KingdomBritish33223550003
    MARRIOTT-BOAM, Deborah Jane
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    Amministratore
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    United KingdomBritish151689670001
    PARISH, Michael Robert
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    Amministratore
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    EnglandBritish78828750003
    WATSON, Paul John
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    Amministratore
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    United KingdomBritish82460360003
    BYARD, Michael Edwin
    33 Preston Parade
    Seasalter
    CT5 4AD Whitstable
    Kent
    Segretario
    33 Preston Parade
    Seasalter
    CT5 4AD Whitstable
    Kent
    British27785530003
    HUMPHREYS, Paul Justin
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    Segretario
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    British33223550003
    TAYLOR, Ann
    27 Maple Avenue
    ME16 0DB Maidstone
    Kent
    Segretario
    27 Maple Avenue
    ME16 0DB Maidstone
    Kent
    British63482920002
    CARE UK SERVICES LIMITED
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Segretario
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2482660
    125332040002
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Segretario nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BENN, Geoffrey Richard
    15 Mimosa Close
    CM1 6NW Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    15 Mimosa Close
    CM1 6NW Chelmsford
    Essex
    EnglandBritish73786580001
    BOOKER, Roger Ian
    Fairview
    17a Queens Road
    WA15 9HF Hale
    Cheshire
    Amministratore
    Fairview
    17a Queens Road
    WA15 9HF Hale
    Cheshire
    United KingdomBritish14044530003
    BYARD, Lesley Ann Elizabeth
    33 Preston Parade
    Seasalter
    CT5 4AD Whitstable
    Kent
    Amministratore
    33 Preston Parade
    Seasalter
    CT5 4AD Whitstable
    Kent
    British95062480001
    BYARD, Michael Edwin
    33 Preston Parade
    Seasalter
    CT5 4AD Whitstable
    Kent
    Amministratore
    33 Preston Parade
    Seasalter
    CT5 4AD Whitstable
    Kent
    British27785530003
    CRIPPS, Nigel John
    Culverlands
    48 Ham Shades Lane
    CT5 1NX Whitstable
    Kent
    Amministratore
    Culverlands
    48 Ham Shades Lane
    CT5 1NX Whitstable
    Kent
    United KingdomBritish69102100001
    CULHANE, Angela
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    Amministratore
    Connaught House
    The Crescent Colchester
    CO4 9QB Business Park Colchester
    Essex
    EnglandBritish68602910001
    HASTINGS, Roy
    Wallis Road
    RG21 3DN Basingstoke
    20
    Hampshire
    Amministratore
    Wallis Road
    RG21 3DN Basingstoke
    20
    Hampshire
    United KingdomBritish130098430001
    KING, John Stewart
    136b Ashford Road
    Bearsted
    ME14 4NA Maidstone
    Kent
    Amministratore
    136b Ashford Road
    Bearsted
    ME14 4NA Maidstone
    Kent
    British67938600002
    QUINN, David Laurence, Mr.
    6 Whitecross Road
    HP17 8BA Haddenham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    6 Whitecross Road
    HP17 8BA Haddenham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish123356660001
    RICHARDSON, Mark John
    7 Ruskins View
    CT6 7AE Herne Bay
    Kent
    Amministratore
    7 Ruskins View
    CT6 7AE Herne Bay
    Kent
    United KingdomBritish95705320001
    SCUTT, Susan Ann
    39 Woodlea
    Leybourne
    ME19 5QY West Malling
    Kent
    Amministratore
    39 Woodlea
    Leybourne
    ME19 5QY West Malling
    Kent
    British39682480001
    TAYLOR, Ann
    27 Maple Avenue
    ME16 0DB Maidstone
    Kent
    Amministratore
    27 Maple Avenue
    ME16 0DB Maidstone
    Kent
    EnglandBritish63482920002
    TEMPLE, Norman Edward
    The Dingle North Foreland Avenue
    CT10 3QR Broadstairs
    Kent
    Amministratore
    The Dingle North Foreland Avenue
    CT10 3QR Broadstairs
    Kent
    EnglandBritish30220700001
    UMBERS, Douglas
    SO53
    Amministratore
    SO53
    United KingdomBritish90541690001
    VOCKINS, Anthony Frederick
    4 Main Street
    Croxton Kerrial
    NG32 1QF Grantham
    The Old Post Office
    Lincolnshire
    Amministratore
    4 Main Street
    Croxton Kerrial
    NG32 1QF Grantham
    The Old Post Office
    Lincolnshire
    EnglandBritish130512090002
    WAITT, Laurence John
    The Winters Oast 21 Chantry Park
    Sarre
    CT7 0LG Birchington
    Kent
    Amministratore
    The Winters Oast 21 Chantry Park
    Sarre
    CT7 0LG Birchington
    Kent
    EnglandBritish97725530002
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    HOME CARE SERVICES (KENT) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 21 lug 2010
    Consegnato il 26 lug 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank Nv, London Branch (As Security Agent)
    Transazioni
    • 26 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 10 dic 2009
    Consegnato il 23 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 28 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 12 mar 2009
    Consegnato il 13 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 17 mag 2002
    Consegnato il 27 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 19 set 1994
    Consegnato il 21 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 21 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0