DEFIANCE CONTRACTOR TOOLS LIMITED

DEFIANCE CONTRACTOR TOOLS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDEFIANCE CONTRACTOR TOOLS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02948404
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DEFIANCE CONTRACTOR TOOLS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova DEFIANCE CONTRACTOR TOOLS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Two Snowhill
    B4 6GA Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DEFIANCE CONTRACTOR TOOLS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AUTOBAND COMPANY LIMITED14 lug 199414 lug 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di DEFIANCE CONTRACTOR TOOLS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per DEFIANCE CONTRACTOR TOOLS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per DEFIANCE CONTRACTOR TOOLS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da 125 Colmore Row Birmingham B3 3SD a Two Snowhill Birmingham B4 6GA in data 03 gen 2016

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 5th Floor Maple House Mutton Lane Potters Bar Hertfordshire EN6 5BS a 125 Colmore Row Birmingham B3 3SD in data 08 mag 2015

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    4 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 13 apr 2015

    LRESSP

    Cessazione della carica di John Hogan come amministratore in data 28 apr 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Toby Train come amministratore in data 28 apr 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Henri-Paul Laschkar come amministratore in data 28 apr 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Neil Michael Croxson come amministratore in data 28 apr 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr John Hogan come amministratore in data 28 apr 2015

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 ago 2014

    Stato del capitale al 07 ago 2014

    • Capitale: GBP 45,500,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 lug 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 23 lug 2013

    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Neil Michael Croxson il 22 mar 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Henri-Paul Laschkar il 22 mar 2013

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 14 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    5 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * Yardley Court 11/12 Frederick Rd Edgbaston Birmingham West Midlands B15 1JD* in data 21 feb 2011

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Neil Michael Croxson il 05 mag 2010

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di DEFIANCE CONTRACTOR TOOLS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TRAIN, Toby
    Maple House
    EN6 5BS Potters Bar
    Maple House
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Maple House
    EN6 5BS Potters Bar
    Maple House
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish124023220002
    EVETTS, John Graham
    72 Sycamore Avenue
    RM14 2HS Upminster
    Essex
    Segretario
    72 Sycamore Avenue
    RM14 2HS Upminster
    Essex
    Pollish/British56188860003
    HAYWOOD, Timothy Paul
    The Yeoman House
    Acton
    DY13 9TF Stourport On Severn
    Worcestershire
    Segretario
    The Yeoman House
    Acton
    DY13 9TF Stourport On Severn
    Worcestershire
    British62962370002
    JAMES, Simon Michael
    37 Brand Hill Drive
    Crofton
    WF4 1PF Wakefield
    Yorkshire
    Segretario
    37 Brand Hill Drive
    Crofton
    WF4 1PF Wakefield
    Yorkshire
    British111338120001
    SMITH, Stephen Anthony
    12 Chestnut Avenue
    HA6 1HR Northwood
    Middlesex
    Segretario
    12 Chestnut Avenue
    HA6 1HR Northwood
    Middlesex
    British6780200001
    TALLIS, Aleksandra Jadwiga
    6 St Chads Grove
    LS6 3PN Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    6 St Chads Grove
    LS6 3PN Leeds
    West Yorkshire
    Polish34638000004
    BLAW DUCTS LIMITED
    Unit 2b The Carr Office Village
    White Rose Way
    DN4 5JH Doncaster
    South Yorkshire
    Segretario
    Unit 2b The Carr Office Village
    White Rose Way
    DN4 5JH Doncaster
    South Yorkshire
    50754710002
    CARADON SERVICES LIMITED
    Caradon House
    24 Queens Road
    KT13 9UX Weybridge
    Surrey
    Segretario
    Caradon House
    24 Queens Road
    KT13 9UX Weybridge
    Surrey
    5096460003
    RALLIP HOLDINGS LIMITED
    Novar House
    24 Queens Road
    KT13 9UX Weybridge
    Surrey
    Segretario
    Novar House
    24 Queens Road
    KT13 9UX Weybridge
    Surrey
    35130970001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CROXSON, Neil Michael
    Maple House
    Mutton Lane
    EN6 5BS Potters Bar
    5th Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Maple House
    Mutton Lane
    EN6 5BS Potters Bar
    5th Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    UkBritish96469690005
    FISCHER, Andrew Olaf
    The Chestnuts
    Chestnut Close, Peakirk
    PE6 7NW Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    The Chestnuts
    Chestnut Close, Peakirk
    PE6 7NW Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandGerman70312740001
    FISHER, Ian
    145 King Henrys Road
    NW3 3RD London
    Amministratore
    145 King Henrys Road
    NW3 3RD London
    United KingdomIsraeli51776160003
    FLETCHER, Alan Thomas
    26 Loudoun Road
    NW8 0LT London
    Amministratore
    26 Loudoun Road
    NW8 0LT London
    British14669590001
    FRASER, Angus Maclean
    3 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    3 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    Irish70451130001
    HOGAN, John Christopher James
    Mutton Lane
    EN6 5BS Potters Bar
    Maple House
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Mutton Lane
    EN6 5BS Potters Bar
    Maple House
    Hertfordshire
    England
    United KingdomIrish197357940001
    LASCHKAR, Henri-Paul
    Floor Maple House
    Mutton Lane
    Potters Bar
    5th
    Herts
    Amministratore
    Floor Maple House
    Mutton Lane
    Potters Bar
    5th
    Herts
    UkFrench139160640005
    MULLEN, Kenneth John
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Amministratore
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    United KingdomScottish146642810001
    NICHOLS, Matt Ward, Mr.
    18 Sweetpool Lane
    Hagley
    DY8 2XH Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    18 Sweetpool Lane
    Hagley
    DY8 2XH Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritish177829370001
    PASSMAN, Jonathan Richard
    Stonefield Close
    Wigston Park Walsgrave
    CV2 2PZ Coventry
    6
    Amministratore
    Stonefield Close
    Wigston Park Walsgrave
    CV2 2PZ Coventry
    6
    British122460330002
    SMITH, Stephen Anthony
    12 Chestnut Avenue
    HA6 1HR Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    12 Chestnut Avenue
    HA6 1HR Northwood
    Middlesex
    British6780200001
    CARADON NOMINEES LIMITED
    Caradon House 24 Queens Road
    KT13 9UX Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Caradon House 24 Queens Road
    KT13 9UX Weybridge
    Surrey
    43553300002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    RALLIP HOLDINGS LIMITED
    Novar House
    24 Queens Road
    KT13 9UX Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Novar House
    24 Queens Road
    KT13 9UX Weybridge
    Surrey
    35130970001

    DEFIANCE CONTRACTOR TOOLS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and debenture
    Creato il 10 dic 1996
    Consegnato il 13 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee as security trustee for itself and the secured parties (as therein defined) or any of them under the financing documents (as therein defined)
    Brevi particolari
    All right, title and interest present and future in and to:- the right to receive payment under the acquisition documents and the keyman policies (both as defined on form 395 and within the deed). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    DEFIANCE CONTRACTOR TOOLS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 lug 2016Data di scioglimento
    13 apr 2015Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Praticante
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0