CAREWATCH CARE SERVICES LIMITED

CAREWATCH CARE SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCAREWATCH CARE SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02949558
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CAREWATCH CARE SERVICES LIMITED?

    • Attività di assistenza sociale senza alloggio per anziani e disabili (88100) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova CAREWATCH CARE SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    11th Floor Landmark St Peter's Square
    1 Oxford St
    M1 4PB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CAREWATCH CARE SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per CAREWATCH CARE SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    22 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 lug 2023

    23 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 lug 2022

    14 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Grant Thornton Uk Llp 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB a 11th Floor Landmark St Peter's Square 1 Oxford St Manchester M1 4PB in data 16 nov 2021

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 lug 2021

    38 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 lug 2020

    57 pagineLIQ03

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    5 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    5 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    5 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    5 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    5 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    5 pagineNDISC

    Indirizzo della sede legale modificato da Libra House Sunrise Parkway Linford Wood Milton Keynes MK14 6PH England a C/O Grant Thornton Uk Llp 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB in data 14 ago 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività

    7 pagineLIQ02

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 23 lug 2019

    LRESEX

    Cessazione della carica di Mark Rogerson come amministratore in data 24 apr 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Philip Jackson come amministratore in data 24 apr 2019

    2 pagineAP01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 mar 2018 al 29 mar 2018

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Scott Sommervaille Christie come amministratore in data 07 feb 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Kevin Richard Nutt come amministratore in data 28 gen 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Craig Hendry come segretario in data 28 gen 2019

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Craig Archibald Macdonald Hendry come amministratore in data 28 gen 2019

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di CAREWATCH CARE SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JACKSON, Philip
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    Amministratore
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    EnglandBritish258380500001
    COLLISON, David
    44 Lowther Road
    SW13 9NU London
    England
    Segretario
    44 Lowther Road
    SW13 9NU London
    England
    British34835160001
    HENDRY, Craig
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    Segretario
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    188958710001
    LEWIS, Karen Deborah
    16 Tongdean Avenue
    BN3 6TL Hove
    East Sussex
    Segretario
    16 Tongdean Avenue
    BN3 6TL Hove
    East Sussex
    British43199080002
    LYON, David Oliver
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    British51084280003
    LYON, David Oliver
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    British51084280003
    PALMER, Lorna Catherine
    Cedar House
    78 Portsmouth Road
    KT11 1PP Cobham
    Surrey
    Segretario
    Cedar House
    78 Portsmouth Road
    KT11 1PP Cobham
    Surrey
    British118836500001
    ROBERTS THOMAS, Caroline Emma
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    Segretario
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    British76032450005
    STEADMAN, Paul James
    Silbury Court
    Silbury Boulevard
    MK9 2AF Milton Keynes
    Building 420
    United Kingdom
    Segretario
    Silbury Court
    Silbury Boulevard
    MK9 2AF Milton Keynes
    Building 420
    United Kingdom
    149308370001
    STEADMAN, Paul James
    Queen Square
    BN1 3FD Brighton
    1
    East Sussex
    Segretario
    Queen Square
    BN1 3FD Brighton
    1
    East Sussex
    149308090001
    STEVENS, Andrew Guy Melville
    Silbury Court
    Silbury Boulevard
    MK9 2AF Milton Keynes
    Building 420
    United Kingdom
    Segretario
    Silbury Court
    Silbury Boulevard
    MK9 2AF Milton Keynes
    Building 420
    United Kingdom
    176884990001
    BOOTY, Stephen Martin
    South Lodge
    Guildford Road
    KT24 5QE Effingham
    Surrey
    Amministratore
    South Lodge
    Guildford Road
    KT24 5QE Effingham
    Surrey
    EnglandBritish147928010001
    CHRISTIE, Scott Sommervaille
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    Amministratore
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    ScotlandBritish104262520001
    DENNY, Nigel John
    Silbury Court
    Silbury Boulevard
    MK9 2AF Milton Keynes
    Building 420
    United Kingdom
    Amministratore
    Silbury Court
    Silbury Boulevard
    MK9 2AF Milton Keynes
    Building 420
    United Kingdom
    EnglandBritish176860610001
    ELLIS, Martyn Anthony
    83 Boss House
    Boss Street
    SE1 2PT London
    Amministratore
    83 Boss House
    Boss Street
    SE1 2PT London
    EnglandBritish95749550002
    HARLAND, David William Romanis
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    Amministratore
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    United KingdomBritish136594420001
    HENDRY, Craig Archibald Macdonald
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    Amministratore
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    ScotlandUnited Kingdom104826820002
    HORGAN, Michael David
    Moreton Lane
    Bishopstone
    HP17 8SQ Aylesbury
    Moreton Barn
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    Moreton Lane
    Bishopstone
    HP17 8SQ Aylesbury
    Moreton Barn
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish107985980001
    HORGAN, Michael David
    7 Lady Yorke Park
    Seven Hills Road
    SL0 0PD Iver
    Buckinghamshire
    Amministratore
    7 Lady Yorke Park
    Seven Hills Road
    SL0 0PD Iver
    Buckinghamshire
    EnglandBritish107985980001
    JEWITT, Justin Allan Spaven, Professor
    The Stables
    89 Aston End Road Aston
    SG2 7EY Stevenage
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Stables
    89 Aston End Road Aston
    SG2 7EY Stevenage
    Hertfordshire
    EnglandBritish39701670001
    LEWIS, Kevin James
    Knutsford House
    Blackgate Lane
    BN5 9HA Henfield
    West Sussex
    Amministratore
    Knutsford House
    Blackgate Lane
    BN5 9HA Henfield
    West Sussex
    British121067560001
    LYON, David Oliver
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish51084280003
    LYON, David Oliver
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    41 Park Avenue North
    AL5 2EE Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish51084280003
    MATTHEWS, Christine
    61 Palin Wood Road
    OL3 5UW Oldham
    Lancashire
    Amministratore
    61 Palin Wood Road
    OL3 5UW Oldham
    Lancashire
    British79885850001
    NEILL, Deborah Ann
    Silbury Court
    Silbury Boulevard
    MK9 2AF Milton Keynes
    Building 420
    Amministratore
    Silbury Court
    Silbury Boulevard
    MK9 2AF Milton Keynes
    Building 420
    United KingdomBritish190155350001
    NUTT, Kevin Richard
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    Amministratore
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    EnglandEnglish243106190001
    OVERGAGE, Simon
    19 Icknield Street
    Beoley
    B98 9AD Redditch
    Amministratore
    19 Icknield Street
    Beoley
    B98 9AD Redditch
    EnglandBritish50370120003
    PEGLER, Philip Michael
    Silbury Court
    Silbury Boulevard
    MK9 2AF Milton Keynes
    Building 420
    United Kingdom
    Amministratore
    Silbury Court
    Silbury Boulevard
    MK9 2AF Milton Keynes
    Building 420
    United Kingdom
    United KingdomBritish163278630001
    RICHARDS, Paul William
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    Amministratore
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    EnglandBritish171470760003
    ROGERSON, Mark
    Frith End Road
    GU35 0RA Bordon
    Calenzana
    England
    Amministratore
    Frith End Road
    GU35 0RA Bordon
    Calenzana
    England
    EnglandBritish168247970003
    STEADMAN, Paul James
    The Glades
    HP1 2TH Hemel Hempstead
    7
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The Glades
    HP1 2TH Hemel Hempstead
    7
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141046340001
    STEVENS, Andrew Guy Melville
    Silbury Court
    Silbury Boulevard
    MK9 2AF Milton Keynes
    Building 420
    United Kingdom
    Amministratore
    Silbury Court
    Silbury Boulevard
    MK9 2AF Milton Keynes
    Building 420
    United Kingdom
    EnglandBritish88041330002
    UNSWORTH, Stephen
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    Amministratore
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    EnglandBritish199259970001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CAREWATCH CARE SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Carewatch Acquisitions Limited
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    06 apr 2016
    Sunrise Parkway
    Linford Wood
    MK14 6PH Milton Keynes
    Libra House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompany Law & Companies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House - England
    Numero di registrazione06662713
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    CAREWATCH CARE SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 13 feb 2017
    Consegnato il 20 feb 2017
    In corso
    Breve descrizione
    N/A.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (as Security Agent)
    Transazioni
    • 20 feb 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 24 gen 2019Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 24 gen 2019Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 24 gen 2019Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 24 gen 2019Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 28 gen 2019Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    Keyman insurance assignment
    Creato il 27 set 2012
    Consegnato il 03 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The security assets being the policy - policy no 016728283-9 date of policy 25 may 2012 name of life assured mr andrew guy neville stevens and the policy benefits see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 03 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Keyman insurance assignment
    Creato il 06 mar 2012
    Consegnato il 09 mar 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Security assets means each policy and its related policy benefits. Legal & general assurance society p/no 016729425-5 mr philip michael pegler £500,000.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 09 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental security and confirmation deed
    Creato il 25 nov 2011
    Consegnato il 07 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 07 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 05 set 2011
    Consegnato il 16 set 2011
    In corso
    Importo garantito
    £4,020.75 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The initial deposit being the sum off £4,020.75 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Foxhall Business Centre Limited
    Transazioni
    • 16 set 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Rent deposit deed
    Creato il 09 nov 2010
    Consegnato il 27 nov 2010
    In corso
    Importo garantito
    £11,825.49 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The deposit.
    Persone aventi diritto
    • Max Office 2 LLP
    Transazioni
    • 27 nov 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Insurance assignment of keyman policies
    Creato il 04 nov 2010
    Consegnato il 06 nov 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its present and future right title and interest in and to the keyman policies being axa sun life PLC paul steadman policy no 33759468 sum assured £250,000 term 5 years, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 nov 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Accession to composite debenture
    Creato il 06 ott 2008
    Consegnato il 10 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 10 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 gen 1998
    Consegnato il 06 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 15 mag 1995
    Consegnato il 23 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CAREWATCH CARE SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 lug 2019Inizio della liquidazione
    29 feb 2024Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Daniel Robert Whiteley Smith
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Oliver Haunch
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0