RO BRIGHTON LIMITED

RO BRIGHTON LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRO BRIGHTON LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02951289
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RO BRIGHTON LIMITED?

    • (7012) /

    Dove si trova RO BRIGHTON LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Graham House
    7 Wyllyotts Place
    EN6 2JD Potters Bar
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RO BRIGHTON LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NELSON BRIGHTON LIMITED14 apr 200314 apr 2003
    CNC (BRIGHTON) LIMITED18 ago 199418 ago 1994
    LOOKGRAND LIMITED21 lug 199421 lug 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di RO BRIGHTON LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per RO BRIGHTON LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 16 set 2011

    • Capitale: GBP 100
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 06 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Richard Graham St John Rowlandson il 06 lug 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Susan Margaret Younghusband il 06 lug 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per The Finance & Industrial Trust Ltd il 06 lug 2010

    2 pagineCH04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    14 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    15 pagineAA

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine403b

    legacy

    7 pagine395

    Bilancio redatto al 31 mar 2006

    15 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Chi sono gli amministratori di RO BRIGHTON LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    THE FINANCE & INDUSTRIAL TRUST LTD
    7 Wyllyotts Place
    EN6 2JD Potters Bar
    Graham House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    7 Wyllyotts Place
    EN6 2JD Potters Bar
    Graham House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione79331
    44732500001
    ROWLANDSON, Richard Graham St John
    Graham House
    7 Wyllyotts Place
    EN6 2JD Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    Graham House
    7 Wyllyotts Place
    EN6 2JD Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant3609230001
    YOUNGHUSBAND, Susan Margaret
    Graham House
    7 Wyllyotts Place
    EN6 2JD Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    Graham House
    7 Wyllyotts Place
    EN6 2JD Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant104413240002
    BLACKETT, Kathleen
    Sanderling Cottage
    8 Llanvair Close
    SL5 9HX South Ascot
    Berkshire
    Segretario
    Sanderling Cottage
    8 Llanvair Close
    SL5 9HX South Ascot
    Berkshire
    British1501820001
    WALKER-ROBSON, Colin Laird
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    Segretario
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    BritishFinance Director2667400002
    WESTON, Carole Linda
    44 Stratford Road
    WD17 4NZ Watford
    Segretario
    44 Stratford Road
    WD17 4NZ Watford
    British62673550003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    TKB REGISTRARS LIMITED
    100 Fetter Lane
    EC4A 1DD London
    Segretario
    100 Fetter Lane
    EC4A 1DD London
    38897180001
    BUDD, Nicholas Peter
    Glynridge
    27 The Avenue
    KT20 5AY Tadworth
    Surrey
    Amministratore
    Glynridge
    27 The Avenue
    KT20 5AY Tadworth
    Surrey
    EnglandBritishProperty Developer43335810002
    BUDD, Tony William Peter
    Chestnuts 31 The Avenue
    KT20 5AY Tadworth
    Surrey
    Amministratore
    Chestnuts 31 The Avenue
    KT20 5AY Tadworth
    Surrey
    United KingdomBritishProperty Developer5718200001
    HAMBIDGE, Roger Alan
    Vicarage Farm House
    Churchway Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Vicarage Farm House
    Churchway Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishChartered Surveyor82434210001
    LEVER, Gary Thomas
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    Amministratore
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    United KingdomBritishDirector83224530001
    LOCKER, Robert John
    Beukenhof
    Tite Hill
    TW20 0NJ Englefield Green
    Surrey
    Amministratore
    Beukenhof
    Tite Hill
    TW20 0NJ Englefield Green
    Surrey
    EnglandBritishProperty Manager155603490001
    MAIS, Richard Jeremy Ian
    79 Seal Hollow Road
    TN13 3RY Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    79 Seal Hollow Road
    TN13 3RY Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishCompany Director1464610001
    NEDHAM, Andrew James
    8 Furzedown Close
    TW20 9PY Egham
    Surrey
    Amministratore
    8 Furzedown Close
    TW20 9PY Egham
    Surrey
    BritishDirector66426700001
    ROPER, Mervyn Edward Patrick
    19 Criffel Avenue
    SW2 4AY London
    Amministratore
    19 Criffel Avenue
    SW2 4AY London
    BritishManager38737920001
    UPTON, Richard
    Le Grouet
    La Rue Du Grouet
    JE3 8HL St Brelade
    Jersey
    Channel Islands
    Amministratore
    Le Grouet
    La Rue Du Grouet
    JE3 8HL St Brelade
    Jersey
    Channel Islands
    United KingdomBritishCompany Director46440870005
    WALKER-ROBSON, Colin Laird
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritishFinance Director2667400002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    RO BRIGHTON LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage
    Creato il 29 set 2006
    Consegnato il 11 ott 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H phoenix house 32 west street brighton t/no ESX152347 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures). Fixed plant and machinery thereon. By way of assignment the goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences and all guarantees. By way of fixed charge the shares and all rights, benefits and advantages arising in respect thereof. By way of assignment the intellectual property rights.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 04 apr 2003
    Consegnato il 17 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as cnc brighton limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Phoenix house 32 west street brighton BN1 2RT f/h t/n ESX152347. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 19 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 lug 2000
    Consegnato il 26 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein and each of the other obligors under the senior finance documents (or any of them) to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Agent)
    Transazioni
    • 26 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of legal charge and mortgage
    Creato il 09 set 1994
    Consegnato il 29 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1900000 and other monies due from clarke nickoll and coombs PLC and/or the company to the chargee under the terms of the deed (as defined therein)
    Brevi particolari
    F/H property k/a pheonix house 32 west street brighton t/n ESX152347 floating charge over all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 29 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0