VICTORY PARK HOLDINGS LIMITED

VICTORY PARK HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVICTORY PARK HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02953427
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VICTORY PARK HOLDINGS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova VICTORY PARK HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Lynton House
    Ackhurst Park
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di VICTORY PARK HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per VICTORY PARK HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 029534270007 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 029534270008 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 mar 2018

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 lug 2018 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2017

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 lug 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 029534270000 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 029534270006 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 029534270007, creata il 31 mag 2017

    20 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 029534270008, creata il 20 giu 2017

    77 pagineMR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Lorimer Widders il 05 giu 2017

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 lug 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    13 pagineAA

    Nomina di Mrs Anne Kelleher come segretario in data 26 ago 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Joanne Patel come segretario in data 26 ago 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 22 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 ago 2015

    Stato del capitale al 04 ago 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Cessazione della carica di John Clement Kay come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Joanne Patel come segretario in data 05 feb 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di John David Holden come segretario in data 05 feb 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    13 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di VICTORY PARK HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KELLEHER, Anne
    Lynton House
    Ackhurst Park
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    Segretario
    Lynton House
    Ackhurst Park
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    200495850001
    HEMMINGS, Patrick Lee
    Lynton House
    Ackhurst Park
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    Lynton House
    Ackhurst Park
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    United KingdomBritish70478960002
    WIDDERS, Mark Lorimer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Dower House
    Lancashire
    England
    Amministratore
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Dower House
    Lancashire
    England
    EnglandBritish2272770002
    HOLDEN, John David
    Lynton House
    Ackhurst Park
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    Segretario
    Lynton House
    Ackhurst Park
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    British137210330001
    LIVESEY, Frederick Joseph
    Wal Mar
    Dawbers Lane, Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Lancashire
    Segretario
    Wal Mar
    Dawbers Lane, Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Lancashire
    British32145610004
    O'LOUGHLIN-PATEL, Joanne
    41 Stonehaven
    Knutshaw Bridge
    BL3 4UW Bolton
    Lancashire
    Segretario
    41 Stonehaven
    Knutshaw Bridge
    BL3 4UW Bolton
    Lancashire
    British52964940002
    PATEL, Joanne
    Lynton House
    Ackhurst Park
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    Segretario
    Lynton House
    Ackhurst Park
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    194750770001
    PENROSE, Ian Richard
    17 Chaucer Close
    Eccleston
    PR7 5UJ Chorley
    Lancashire
    Segretario
    17 Chaucer Close
    Eccleston
    PR7 5UJ Chorley
    Lancashire
    British32311080001
    WILLIAMS, Elisabeth
    50 Hawkhurst Road
    Penwortham
    PR1 9QS Preston
    Lancashire
    Segretario
    50 Hawkhurst Road
    Penwortham
    PR1 9QS Preston
    Lancashire
    British39676870001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    EDWARDS, George Albert
    12 Gronant Road
    LL19 9DS Prestatyn
    Clwyd
    Amministratore
    12 Gronant Road
    LL19 9DS Prestatyn
    Clwyd
    United KingdomBritish52691650002
    KAY, John Clement
    Lynton House
    Ackhurst Park
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    Lynton House
    Ackhurst Park
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish27891540001
    KIRKLAND, John Marshall
    19 Park Road
    Leyland
    PR5 2AP Preston
    Lancashire
    Amministratore
    19 Park Road
    Leyland
    PR5 2AP Preston
    Lancashire
    British3315880001
    LIVESEY, Frederick Joseph
    Wal Mar
    Dawbers Lane, Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    Wal Mar
    Dawbers Lane, Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Lancashire
    British32145610004
    PENROSE, Antony John
    1 Hollinhurst Avenue
    Penwortham
    PR1 0AE Preston
    Lancashire
    Amministratore
    1 Hollinhurst Avenue
    Penwortham
    PR1 0AE Preston
    Lancashire
    EnglandBritish4999270001
    PENROSE, Ian Richard
    17 Chaucer Close
    Eccleston
    PR7 5UJ Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    17 Chaucer Close
    Eccleston
    PR7 5UJ Chorley
    Lancashire
    British32311080001

    Chi sono le persone con controllo significativo di VICTORY PARK HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Northern Trust Group Limited
    Ackhurst Business Park
    Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lynton House
    Lancashire
    England
    06 apr 2016
    Ackhurst Business Park
    Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lynton House
    Lancashire
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Autorità legaleEngland
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    VICTORY PARK HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 giu 2017
    Consegnato il 20 giu 2017
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Situs Asset Management Limited (And Its Successors in Title and Permitted Transferees)
    Transazioni
    • 20 giu 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 gen 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 31 mag 2017
    Consegnato il 20 giu 2017
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Situs Asset Management Limited
    Transazioni
    • 20 giu 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 gen 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 19 giu 2014
    Consegnato il 24 giu 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    T/No's LA553119,LA554295,LA698916 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Situs Asset Management Limited (And All Its Sucessors in Title,Permitted Assigns and Permitted Tranferees)
    Transazioni
    • 24 giu 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 26 giu 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 19 giu 2014
    Consegnato il 21 giu 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Situs Asset Management Limited (As Security Trustee and Securtiy Agent)
    Transazioni
    • 21 giu 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 26 giu 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 27 feb 2009
    Consegnato il 11 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land on the east side of pilling lane and on the south side of duke street t/no. LA553119, f/h 38 ashby street chorley t/no. LA554295, f/h farington lodge and land adjoining at leyland t/no. LA698916 for details of further property please see form 395 charged with full title guarantee in favour of the security trustee with the payment and discharge of the secured obligations, by way of first legal mortgage see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties or Any Person Appointed as Security Trustee from Time to Time in Accordance with the Terms of the Facility
    Transazioni
    • 11 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 27 feb 2009
    Consegnato il 09 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties or Any Person Appointed as Security Trustee from Time to Time in Accordance Withe the Terms of the Facility Agreement
    Transazioni
    • 09 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee and debenture
    Creato il 20 dic 2002
    Consegnato il 08 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties (the "security trustee") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 set 1994
    Consegnato il 10 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property situate at victory park, duke street, chorley lancashire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Northern Trust Company Limited
    Transazioni
    • 10 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0