VEHICLE LEASING (2) LIMITED

VEHICLE LEASING (2) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVEHICLE LEASING (2) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02954065
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VEHICLE LEASING (2) LIMITED?

    • Noleggio e leasing di automobili e veicoli a motore leggeri (77110) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova VEHICLE LEASING (2) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VEHICLE LEASING (2) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LEX VEHICLE LEASING (2) LIMITED 12 dic 199412 dic 1994
    PALMSHORE LIMITED29 lug 199429 lug 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di VEHICLE LEASING (2) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per VEHICLE LEASING (2) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da Charterhall House Charterhall Drive Chester Cheshire CH88 3AN a 1 More London Place London SE1 2AF in data 02 giu 2017

    2 pagineAD01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN

    2 pagineAD02

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 apr 2017

    LRESSP

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 30 giu 2016

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Paul Gittins come segretario in data 28 giu 2016

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr David Dermot Hennessey come segretario in data 28 giu 2016

    2 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 21 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 giu 2016

    Stato del capitale al 21 giu 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2015

    9 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Damian Charles Stansfield il 19 ago 2015

    2 pagineCH01

    Nomina di Damian Charles Stansfield come amministratore in data 07 ago 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard Gareth Charles Hanrahan come amministratore in data 06 ago 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 29 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 lug 2015

    Stato del capitale al 30 lug 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2014

    16 pagineAA

    Nomina di Mr Richard Geoffrey Warnes come amministratore in data 16 dic 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Carol Ann Parkes come amministratore in data 16 dic 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Richard Gareth Charles Hanrahan come amministratore in data 16 dic 2014

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di VEHICLE LEASING (2) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HENNESSEY, David Dermot
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower House
    United Kingdom
    Segretario
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower House
    United Kingdom
    210084740001
    STANSFIELD, Damian Charles
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritish158010850002
    WARNES, Richard Geoffrey
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritish193543370001
    COLES, Pamela Mary
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Segretario
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British70326980001
    GITTINS, Paul
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Segretario
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    British45660860003
    IVES, Deborah Ann
    Chukwani The Friary
    Old Windsor
    SL4 2NS Windsor
    Berkshire
    Segretario
    Chukwani The Friary
    Old Windsor
    SL4 2NS Windsor
    Berkshire
    British61720060001
    RICHARDSON, Elaine
    The Willows Willowside
    London Colney
    AL2 1DP St Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    The Willows Willowside
    London Colney
    AL2 1DP St Albans
    Hertfordshire
    British36633090001
    YOUNG, Mark Lees
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    Segretario
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    British32782910002
    YOUNG, Mark Lees
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    Segretario
    68 Wycherley Crescent
    EN5 1AP New Barnet
    Hertfordshire
    British32782910002
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    Segretario
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    1278390004
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BALLINGALL, Stuart James
    39 Craigleith Drive
    EH4 3JU Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    39 Craigleith Drive
    EH4 3JU Edinburgh
    Midlothian
    British118506820001
    CHESSMAN, Mark Francis
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Blake House
    United Kingdom
    Amministratore
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Blake House
    United Kingdom
    EnglandBritish196385070001
    COLES, Pamela Mary
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    41 Baring Road
    HP9 2NB Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British70326980001
    CORMICK, Charles Bruce Arthur
    Flat 2
    11 Pembridge Crescent
    W11 3DT London
    Amministratore
    Flat 2
    11 Pembridge Crescent
    W11 3DT London
    United KingdomBritish17946190001
    DOREHILL, Andrew John
    West Lodge Chapel Green
    RG40 3EP Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    West Lodge Chapel Green
    RG40 3EP Wokingham
    Berkshire
    British50182040001
    EASTER, Philip Charles
    Arlington House
    Arlington Lane
    NR2 2DB Norwich
    Amministratore
    Arlington House
    Arlington Lane
    NR2 2DB Norwich
    EnglandBritish105999210001
    FEWSTER, Roy Robson
    Woodend
    Rosedale Abbey
    YO18 8SE Pickering
    North Yorkshire
    Amministratore
    Woodend
    Rosedale Abbey
    YO18 8SE Pickering
    North Yorkshire
    British50065350001
    FOULDS, David Michael
    8 Upper Hollis
    HP16 9HP Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    8 Upper Hollis
    HP16 9HP Great Missenden
    Buckinghamshire
    EnglandBritish122016350001
    FRANCIS, Rick
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Blake House
    United Kingdom
    Amministratore
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Blake House
    United Kingdom
    EnglandBritish180380320001
    FRANCIS, Rick
    Ravenswood House
    Coventry Road
    CV47 1BG Southam
    Warwickshire
    Amministratore
    Ravenswood House
    Coventry Road
    CV47 1BG Southam
    Warwickshire
    EnglandBritish180380320001
    GALLOWAY, David Allistair
    Gyldernscroft 1 Henley Road
    SL7 2BZ Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Gyldernscroft 1 Henley Road
    SL7 2BZ Marlow
    Buckinghamshire
    British305790001
    GALLOWAY, David Allistair
    Gyldernscroft 1 Henley Road
    SL7 2BZ Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Gyldernscroft 1 Henley Road
    SL7 2BZ Marlow
    Buckinghamshire
    British305790001
    HANRAHAN, Richard Gareth Charles
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritish193543450001
    HARRIS, Peter Robert
    Four Winds
    Fireball Hill
    SL5 9PJ Sunningdale
    Berkshire
    Amministratore
    Four Winds
    Fireball Hill
    SL5 9PJ Sunningdale
    Berkshire
    United KingdomBritish50619920001
    HAY, Andrew John
    Highcroft
    Northfield Place
    KT13 0RF Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Highcroft
    Northfield Place
    KT13 0RF Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish124994940001
    IVES, Deborah Ann
    Chukwani The Friary
    Old Windsor
    SL4 2NS Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    Chukwani The Friary
    Old Windsor
    SL4 2NS Windsor
    Berkshire
    British61720060001
    KOSTER, Richard Peter Timothy, Dr
    71 Humbolt Road
    W6 8QQ London
    Amministratore
    71 Humbolt Road
    W6 8QQ London
    British68975920001
    MACHELL, Simon Christopher
    Gooch's Farm
    Rushall
    IP21 4QB Diss
    Norfolk
    Amministratore
    Gooch's Farm
    Rushall
    IP21 4QB Diss
    Norfolk
    British145338560001
    MARCHINGTON, Andrew Philip
    Lydden House
    Southlands Road
    RG40 2HS Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    Lydden House
    Southlands Road
    RG40 2HS Wokingham
    Berkshire
    British68450340002
    PARKES, Carol Ann
    Heathside Park Road
    SK3 0RB Stockport
    Heathside
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Heathside Park Road
    SK3 0RB Stockport
    Heathside
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish139996590027
    RENNIE, Thomas Fleming Thomson
    Hoddlesden Hall
    Johnson New Road, Hoddlesden
    BB3 3NN Darwen
    Lancashire
    Amministratore
    Hoddlesden Hall
    Johnson New Road, Hoddlesden
    BB3 3NN Darwen
    Lancashire
    EnglandBritish49999050002
    SNOWBALL, Patrick Joseph Robert
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    Amministratore
    St Helen's
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    British38351740003
    STEAD, Nigel Cleator
    Blake House
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Lex Autolease
    England
    England
    Amministratore
    Blake House
    Hatchford Way
    B26 3RZ Birmingham
    Lex Autolease
    England
    England
    EnglandBritish47582470001
    TOWN, Lindsay John
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish64287260001

    VEHICLE LEASING (2) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A fixed and floating security document
    Creato il 26 ott 2005
    Consegnato il 03 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the charging group companies to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC
    Transazioni
    • 03 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 16 lug 2004
    Consegnato il 27 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the other initial charging companies to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC as Security Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 27 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A fixed and floating security document (the "debenture")
    Creato il 07 dic 2001
    Consegnato il 14 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys,liabilities and obligations due or to become due from the charging group companies (as defined) to the chargee (the "hedging bank") under or pursuant to the swap documents (as defined) or otherwise
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC
    Transazioni
    • 14 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture between the company and halifax PLC as agent and trustee for the finance parties (the security trustee)
    Creato il 31 dic 1998
    Consegnato il 06 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys liabilities and obligations due or to become due by the charging group companies (as defined) to the finance parties (as defined) under or pursuant to the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Halifax PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 06 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 28 ago 1998
    Consegnato il 09 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 09 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    VEHICLE LEASING (2) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 apr 2017Inizio della liquidazione
    28 feb 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0