GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED
Panoramica
| Nome della società | GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02955426 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?
- (7011) /
- (7020) /
Dove si trova GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Citygate Saint James Boulevard NE1 4JE Newcastle Upon Tyne |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CROSSCO (NO.115) LIMITED | 03 ago 1994 | 03 ago 1994 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nicholas Mark Fletcher Jopling come amministratore in data 28 set 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nicholas Peter On come amministratore in data 28 set 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Quentin Patrick Couch come amministratore in data 28 set 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Nicholas Peter On il 17 mag 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2010 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mark Greenwood come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Nicholas Mark Fletcher Jopling come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Peter Quentin Patrick Couch come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 set 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Nick On il 16 set 2010 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2009 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Rupert Dickinson come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 set 2009 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2008 | 13 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2007 | 13 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDLE, Michael Patrick | Segretario | Stanton Townhead NE65 8PR Morpeth High Priar Northumberland | British | 135308530001 | ||||||
| CUNNINGHAM, Andrew Rolland | Amministratore | Montagu Avenue NE3 4JH Newcastle Upon Tyne 35 Tyne And Wear | England | British | 74581390003 | |||||
| GREENWOOD, Mark | Amministratore | Slayley NE47 0AA Hexham Winter House Northumberland | United Kingdom | British | 154194730002 | |||||
| DAVIS, Geoffrey Joseph | Segretario | 9 The Copse Burnopfield NE16 6HA Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 65421150001 | ||||||
| GLANVILLE, Marie Louise | Segretario | 28 Bramhall Drive High Generals Wood Rickleton NE38 9DB Washington Tyne & Wear | English | 86483290001 | ||||||
| MILBURN, Peter Michael | Segretario | Derwent Lodge DH8 0TG Shotley Bridge County Durham | British | 36406380001 | ||||||
| DICKINSON DEES | Segretario nominato | St Anns Wharf 112 Quayside NE99 1SB Newcastle Upon Tyne | 900005460001 | |||||||
| CARE, Timothy James | Amministratore delegato nominato | West House Whorlton Hall Farm Westerhope NE5 1NP Newcastle Upon Tyne | British | 900005450001 | ||||||
| COUCH, Peter Quentin Patrick | Amministratore | Amberley GL5 5AG Gloucestershire Follifoot House | Uk | British | 156117090001 | |||||
| DAVIS, Geoffrey Joseph | Amministratore | 17 Lintzford Road Hamsterley Mill Rowlands Gill NE39 1HA Newcastle Upon Tyne | England | British | 65421150003 | |||||
| DICKINSON, Rupert Jerome | Amministratore | 59 Albert Bridge Road SW11 4AQ London | United Kingdom | British | 60267600001 | |||||
| DICKINSON, Stephen | Amministratore | Crow Hall NE47 7BJ Bardon Mill Northumberland | United Kingdom | British | 8256950001 | |||||
| FIELDER, James | Amministratore | 10 Bishops Road SW8 7AB London | United Kingdom | British | 72574940002 | |||||
| JOPLING, Nicholas Mark Fletcher | Amministratore | Chipstead Street SW6 3SS London 28 | England | British | 60099210003 | |||||
| ON, Nicholas Peter | Amministratore | The Links NE26 1RS Whitley Bay 31 Tyne And Wear | United Kingdom | British | 135860930002 | |||||
| SLADE, Sean Anthony | Amministratore | Idlewood Maidenhead Road SL6 9DF Cookham Berkshire | British | 94640230001 |
GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 23 ott 2001 Consegnato il 08 nov 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The total principle sum of £1,575,000 together with all monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the legal charge | |
Brevi particolari F/H land and buildings at 179 high street lincoln t/no: LL27733. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge | Creato il 22 giu 2001 Consegnato il 28 giu 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £12,501,016 and all other monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the provisions of the principal deeds (including for the avoidance of doubt the termination payment) and this charge | |
Brevi particolari By way of assignment to the lender the benefit f the deposit and subject to the reassignment of the deposit (or such of it is still subsisting and vested in the lender) on repayment to the lender of the loan in full. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental deed of charge | Creato il 30 set 1999 Consegnato il 06 ott 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal sum of £5,607,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the legal charge dated 3RD april 1987 and further advances (the "loan") and £1,300,000 due or to become due from the company to the chargee (the "further advance") | |
Brevi particolari L/H property k/a 1-4 jubilee way winsford cheshire t/no: CH380718. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge | Creato il 26 mag 1998 Consegnato il 28 mag 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal sum of £5,607,000 together with any further advances made by the chargee pursuant to the provisions of the 1987 deed (as defined) | |
Brevi particolari L/Hold property known as queens parade,fountain court and dingle walk,winsford,cheshire; t/nos:CH287801,CH356569,CH384588 and CH402094; the benefit of all rights and/or buildings and all insurances thereto; see form 395 for full details. Undertaking and all property and assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of release and substitution | Creato il 30 gen 1998 Consegnato il 17 feb 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal of and interest on the £3,000,000 11 3/4 per cent. First mortgage debenture stock 2024 and on the £15,000,000 10.5 per cent. First mortgage debenture stock 2024 of grainger trust P.L.C. due or to become due from the company to the chargee and all other monies intended to be secured by the above deed and existing deeds (as defined in the above deed) to which it is supplemental | |
Brevi particolari F/H property k/a 55 station road clacton. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of release and substitution | Creato il 19 dic 1997 Consegnato il 05 gen 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito In favour of the chargee the principal of and interest on the £3,000,000 11 3/4 per cent. First mortgage debenture stock 2024 and on the £15,000,000 10.5 per cent. First mortgage debenture stock 2024 of grainger trust P.L.C. and all other moneys intended to be secured by the above deed and deeds dated 24TH february 1984, 23 december 1985, 26TH june 1986, 27TH november 1987, 27TH november 1987, 31ST march 1989, 30TH june 1994, 31ST march 1995, 29TH september 1995 and 13TH june 1997 to which it is supplemental | |
Brevi particolari By way of first legal mortgage f/h property on the south east side of hinckley road coventry t/n-WK352152 together with all buildings and erections and fixtures (including tenants' and trade fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon belonging to it and all improvements and additions thereto. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of release and substitution | Creato il 13 giu 1997 Consegnato il 17 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal of and interest on the £3,000,000 11 3/4 per cent. First mortgage debenture stock 2024 and on the £15,000,000 10.5 per cent. First mortgage debenture stock 2024 of grainger trust PLC and all other monies intended to be secured by the deed of release and substitution and the deeds dated 24/2/84, 23/12/85, 26/6/86, 27/11/87, 27/11/87 ,31/3/89, 30/6/94, 31/3/95 and 29/9/95 to which it is supplemental | |
Brevi particolari The f/h properties k/a 179 high street lincoln and lancaster house 36 orchard street lincoln together with all buildings and fixtures fixed plant and machinery thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 30 set 1996 Consegnato il 10 ott 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of legal mortgage the l/h land comprising the shopping centre winsford cheshire t/n's CH287801, CH38458 and CH356569 together with all buildings and fixtures fixed plant and machinery thereon and assigns the goodwill of the business. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assignment of rents | Creato il 30 set 1996 Consegnato il 10 ott 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Assignment of the benefit of all rents, licence or tenancy fees payable by any lessee, licence or tenant of any part of the shopping centre winsford cheshire (as defined in the mortgage deed of even date). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fourth supplemental trust deed | Creato il 29 set 1995 Consegnato il 04 ott 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal of and interest on the £3,000,000 11 3/4 per cent. First mortage debenture stock 2024 and on the £15,000,000 10.5 per cent. First mortgage debenture stock 2024 of grainger trust P.L.C. and all other moneys intended to be secured by the above deed and the existing deeds (as defined in the above deed) to which it is supplemental | |
Brevi particolari Freehold property known as land and buildings lying to the east of derby road,huyton,merseyside title number MS291314 and a floating charge over all property assets including any uncalled capital and all monies payable under the insurances. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 29 nov 1994 Consegnato il 12 dic 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Acquisition of property | Creato il 12 nov 1994 Acquisito il 25 ott 1994 Consegnato il 12 nov 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £7,850,000 | |
Brevi particolari Lancaster house 36 orchard street lincoln t/no LL46183. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Acquisition of property | Creato il 12 nov 1994 Acquisito il 25 ott 1994 Consegnato il 12 nov 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £7,850,000 | |
Brevi particolari Winsford town centre cheshire t/no CH287801. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| "C" loan notes charge | Creato il 08 nov 1994 Acquisito il 25 ott 1994 Consegnato il 08 nov 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due | |
Brevi particolari 179 high street lincoln t/no LL27733. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| "C" loan notes charge | Creato il 08 nov 1994 Acquisito il 25 ott 1994 Consegnato il 08 nov 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due | |
Brevi particolari F/H property k/a lancaster house lincoln t/no LL46183 and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 22 set 1988 Acquisito il 14 giu 1995 Consegnato il 04 lug 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £6,850,000.00 | |
Brevi particolari Land and buildings at queens parade fountain court and dingle walk winsford cheshire t/n-CH287801, CH384588 and CH356569. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0