GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED

GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02955426
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?

    • (7011) /
    • (7020) /

    Dove si trova GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CROSSCO (NO.115) LIMITED03 ago 199403 ago 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Nicholas Mark Fletcher Jopling come amministratore in data 28 set 2011

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nicholas Peter On come amministratore in data 28 set 2011

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Peter Quentin Patrick Couch come amministratore in data 28 set 2011

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Nicholas Peter On il 17 mag 2011

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    12 pagineAA

    Nomina di Mark Greenwood come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Nicholas Mark Fletcher Jopling come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Peter Quentin Patrick Couch come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 ott 2010

    Stato del capitale al 12 ott 2010

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Nick On il 16 set 2010

    3 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 set 2009

    12 pagineAA

    Cessazione della carica di Rupert Dickinson come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 set 2008

    13 pagineAA

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 30 set 2007

    13 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WINDLE, Michael Patrick
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    Segretario
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    British135308530001
    CUNNINGHAM, Andrew Rolland
    Montagu Avenue
    NE3 4JH Newcastle Upon Tyne
    35
    Tyne And Wear
    Amministratore
    Montagu Avenue
    NE3 4JH Newcastle Upon Tyne
    35
    Tyne And Wear
    EnglandBritish74581390003
    GREENWOOD, Mark
    Slayley
    NE47 0AA Hexham
    Winter House
    Northumberland
    Amministratore
    Slayley
    NE47 0AA Hexham
    Winter House
    Northumberland
    United KingdomBritish154194730002
    DAVIS, Geoffrey Joseph
    9 The Copse
    Burnopfield
    NE16 6HA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    9 The Copse
    Burnopfield
    NE16 6HA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British65421150001
    GLANVILLE, Marie Louise
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    Segretario
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    English86483290001
    MILBURN, Peter Michael
    Derwent Lodge
    DH8 0TG Shotley Bridge
    County Durham
    Segretario
    Derwent Lodge
    DH8 0TG Shotley Bridge
    County Durham
    British36406380001
    DICKINSON DEES
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    Segretario nominato
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    900005460001
    CARE, Timothy James
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    Amministratore delegato nominato
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    British900005450001
    COUCH, Peter Quentin Patrick
    Amberley
    GL5 5AG Gloucestershire
    Follifoot House
    Amministratore
    Amberley
    GL5 5AG Gloucestershire
    Follifoot House
    UkBritish156117090001
    DAVIS, Geoffrey Joseph
    17 Lintzford Road
    Hamsterley Mill Rowlands Gill
    NE39 1HA Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    17 Lintzford Road
    Hamsterley Mill Rowlands Gill
    NE39 1HA Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritish65421150003
    DICKINSON, Rupert Jerome
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    Amministratore
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    United KingdomBritish60267600001
    DICKINSON, Stephen
    Crow Hall
    NE47 7BJ Bardon Mill
    Northumberland
    Amministratore
    Crow Hall
    NE47 7BJ Bardon Mill
    Northumberland
    United KingdomBritish8256950001
    FIELDER, James
    10 Bishops Road
    SW8 7AB London
    Amministratore
    10 Bishops Road
    SW8 7AB London
    United KingdomBritish72574940002
    JOPLING, Nicholas Mark Fletcher
    Chipstead Street
    SW6 3SS London
    28
    Amministratore
    Chipstead Street
    SW6 3SS London
    28
    EnglandBritish60099210003
    ON, Nicholas Peter
    The Links
    NE26 1RS Whitley Bay
    31
    Tyne And Wear
    Amministratore
    The Links
    NE26 1RS Whitley Bay
    31
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish135860930002
    SLADE, Sean Anthony
    Idlewood
    Maidenhead Road
    SL6 9DF Cookham
    Berkshire
    Amministratore
    Idlewood
    Maidenhead Road
    SL6 9DF Cookham
    Berkshire
    British94640230001

    GRAINGER TRUST COMMERCIAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 23 ott 2001
    Consegnato il 08 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The total principle sum of £1,575,000 together with all monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the legal charge
    Brevi particolari
    F/H land and buildings at 179 high street lincoln t/no: LL27733.
    Persone aventi diritto
    • Sun Life Assurance Company of Canada (UK) Limited
    Transazioni
    • 08 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 22 giu 2001
    Consegnato il 28 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £12,501,016 and all other monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the provisions of the principal deeds (including for the avoidance of doubt the termination payment) and this charge
    Brevi particolari
    By way of assignment to the lender the benefit f the deposit and subject to the reassignment of the deposit (or such of it is still subsisting and vested in the lender) on repayment to the lender of the loan in full.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Annuities Limited
    Transazioni
    • 28 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed of charge
    Creato il 30 set 1999
    Consegnato il 06 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal sum of £5,607,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the legal charge dated 3RD april 1987 and further advances (the "loan") and £1,300,000 due or to become due from the company to the chargee (the "further advance")
    Brevi particolari
    L/H property k/a 1-4 jubilee way winsford cheshire t/no: CH380718.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Annuities Limited
    Transazioni
    • 06 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 26 mag 1998
    Consegnato il 28 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal sum of £5,607,000 together with any further advances made by the chargee pursuant to the provisions of the 1987 deed (as defined)
    Brevi particolari
    L/Hold property known as queens parade,fountain court and dingle walk,winsford,cheshire; t/nos:CH287801,CH356569,CH384588 and CH402094; the benefit of all rights and/or buildings and all insurances thereto; see form 395 for full details. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Annuities Limited
    Transazioni
    • 28 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creato il 30 gen 1998
    Consegnato il 17 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £3,000,000 11 3/4 per cent. First mortgage debenture stock 2024 and on the £15,000,000 10.5 per cent. First mortgage debenture stock 2024 of grainger trust P.L.C. due or to become due from the company to the chargee and all other monies intended to be secured by the above deed and existing deeds (as defined in the above deed) to which it is supplemental
    Brevi particolari
    F/H property k/a 55 station road clacton.
    Persone aventi diritto
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transazioni
    • 17 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creato il 19 dic 1997
    Consegnato il 05 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    In favour of the chargee the principal of and interest on the £3,000,000 11 3/4 per cent. First mortgage debenture stock 2024 and on the £15,000,000 10.5 per cent. First mortgage debenture stock 2024 of grainger trust P.L.C. and all other moneys intended to be secured by the above deed and deeds dated 24TH february 1984, 23 december 1985, 26TH june 1986, 27TH november 1987, 27TH november 1987, 31ST march 1989, 30TH june 1994, 31ST march 1995, 29TH september 1995 and 13TH june 1997 to which it is supplemental
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage f/h property on the south east side of hinckley road coventry t/n-WK352152 together with all buildings and erections and fixtures (including tenants' and trade fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon belonging to it and all improvements and additions thereto.
    Persone aventi diritto
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transazioni
    • 05 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creato il 13 giu 1997
    Consegnato il 17 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £3,000,000 11 3/4 per cent. First mortgage debenture stock 2024 and on the £15,000,000 10.5 per cent. First mortgage debenture stock 2024 of grainger trust PLC and all other monies intended to be secured by the deed of release and substitution and the deeds dated 24/2/84, 23/12/85, 26/6/86, 27/11/87, 27/11/87 ,31/3/89, 30/6/94, 31/3/95 and 29/9/95 to which it is supplemental
    Brevi particolari
    The f/h properties k/a 179 high street lincoln and lancaster house 36 orchard street lincoln together with all buildings and fixtures fixed plant and machinery thereon.
    Persone aventi diritto
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transazioni
    • 17 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 30 set 1996
    Consegnato il 10 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the l/h land comprising the shopping centre winsford cheshire t/n's CH287801, CH38458 and CH356569 together with all buildings and fixtures fixed plant and machinery thereon and assigns the goodwill of the business.
    Persone aventi diritto
    • Newcastle Building Society
    Transazioni
    • 10 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment of rents
    Creato il 30 set 1996
    Consegnato il 10 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Assignment of the benefit of all rents, licence or tenancy fees payable by any lessee, licence or tenant of any part of the shopping centre winsford cheshire (as defined in the mortgage deed of even date).
    Persone aventi diritto
    • Newcastle Building Society
    Transazioni
    • 10 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fourth supplemental trust deed
    Creato il 29 set 1995
    Consegnato il 04 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £3,000,000 11 3/4 per cent. First mortage debenture stock 2024 and on the £15,000,000 10.5 per cent. First mortgage debenture stock 2024 of grainger trust P.L.C. and all other moneys intended to be secured by the above deed and the existing deeds (as defined in the above deed) to which it is supplemental
    Brevi particolari
    Freehold property known as land and buildings lying to the east of derby road,huyton,merseyside title number MS291314 and a floating charge over all property assets including any uncalled capital and all monies payable under the insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Guaradian Royal Exchange Assurance PLC
    Transazioni
    • 04 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 giu 1997Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 24 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 29 nov 1994
    Consegnato il 12 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Acquisition of property
    Creato il 12 nov 1994
    Acquisito il 25 ott 1994
    Consegnato il 12 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £7,850,000
    Brevi particolari
    Lancaster house 36 orchard street lincoln t/no LL46183.
    Persone aventi diritto
    • Friends Provident Life Office
    Transazioni
    • 12 nov 1994Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 20 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Acquisition of property
    Creato il 12 nov 1994
    Acquisito il 25 ott 1994
    Consegnato il 12 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £7,850,000
    Brevi particolari
    Winsford town centre cheshire t/no CH287801.
    Persone aventi diritto
    • Friends Provident Life Office
    Transazioni
    • 12 nov 1994Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 19 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    "C" loan notes charge
    Creato il 08 nov 1994
    Acquisito il 25 ott 1994
    Consegnato il 08 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due
    Brevi particolari
    179 high street lincoln t/no LL27733. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Caroline Patricia Darley Nicola Margaret Combes Rebecca Charlotte Baronas Trustees
    Transazioni
    • 08 nov 1994Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 20 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    "C" loan notes charge
    Creato il 08 nov 1994
    Acquisito il 25 ott 1994
    Consegnato il 08 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due
    Brevi particolari
    F/H property k/a lancaster house lincoln t/no LL46183 and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Caroline Patricia Darley Nicola Margaret Combes Rebecca Charlotte Baronas Trustees
    Transazioni
    • 08 nov 1994Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 20 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 22 set 1988
    Acquisito il 14 giu 1995
    Consegnato il 04 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £6,850,000.00
    Brevi particolari
    Land and buildings at queens parade fountain court and dingle walk winsford cheshire t/n-CH287801, CH384588 and CH356569.
    Persone aventi diritto
    • Freinds Provident Life Office
    Transazioni
    • 04 lug 1995Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 19 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0