ASHBOURNE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàASHBOURNE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02958151
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ASHBOURNE LIMITED?

    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova ASHBOURNE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ASHBOURNE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ASHBOURNE GROUP UK LIMITED08 mar 200108 mar 2001
    SUN HEALTHCARE GROUP UK LIMITED 22 gen 199922 gen 1999
    SUN HEALTHCARE GROUP INTERNATIONAL LTD.30 ago 199430 ago 1994
    BASICTOP LIMITED12 ago 199412 ago 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di ASHBOURNE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per ASHBOURNE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario in data 09 ott 2012

    1 pagineTM02

    Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione

    6 pagine1.4

    Cessazione della carica di Timothy James Bolot come amministratore in data 17 ago 2012

    1 pagineTM01

    Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore

    4 pagine1.1

    Bilancio annuale redatto al 15 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 gen 2012

    Stato del capitale al 18 gen 2012

    • Capitale: GBP 136,232,000
    SH01

    Cessazione della carica di William James Buchan come amministratore in data 15 nov 2011

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Andrew Smith come amministratore in data 01 nov 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Jonathan Taylor come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Timothy James Bolot come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    21 pagineAA

    Cessazione della carica di William Mcleish come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario

    1 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 15 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    11 pagineAR01

    Cessazione della carica di Richard Midmer come amministratore

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Explanatory statement to sole member 14/05/2010
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 15 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    12 pagineAR01

    Bilancio redatto al 27 set 2009

    18 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Andrew Smith il 07 gen 2010

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Smith come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kamma Foulkes come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di ASHBOURNE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    BROUSSARD, Bruce Dale
    4920 Calle De Tierra Ne
    FOREIGN Albuquerque
    New Mexico
    Segretario
    4920 Calle De Tierra Ne
    FOREIGN Albuquerque
    New Mexico
    American40571230001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Segretario
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    British53915080001
    FORD, Colin Andrew
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    British70144650001
    HURRELL, Steven Alfred
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    Segretario
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    British82311390001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Segretario
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British89002440002
    MACFARLANE, Rona Jane
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    Segretario
    2/2 5 Doune Quadrant
    G20 6DL Glasgow
    British62509960001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Segretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158304820001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Segretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Segretario
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    British69603410001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Segretario
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SPEIRS, Lesley Sarah
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    22 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DT Glasgow
    Lanarkshire
    British69112020001
    WIMER, Mark G
    7939 West Bayhill Court
    83704 Boise
    Idaho
    Usa
    Segretario
    7939 West Bayhill Court
    83704 Boise
    Idaho
    Usa
    American52192900001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ABLETT, Julie
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    Amministratore
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    British57906600001
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BROUSSARD, Bruce Dale
    4920 Calle De Tierra Ne
    FOREIGN Albuquerque
    New Mexico
    Amministratore
    4920 Calle De Tierra Ne
    FOREIGN Albuquerque
    New Mexico
    American40571230001
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    DAVIS, Mary
    Oakdene
    200 Culduthel Road
    IV2 4BH Inverness
    Amministratore
    Oakdene
    200 Culduthel Road
    IV2 4BH Inverness
    British76212360001
    FARRALL, Elaine Ann
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Manton Lodge
    Clumber Park
    S80 3AX Worksop
    Nottinghamshire
    British14241020001
    FEENEY, Martin
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    Amministratore
    13 Avonhead Avenue
    Condorrat Cumbernauld
    G67 4RB Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish53915080001
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Amministratore
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    American100530310001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    Amministratore
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    British66801660002
    HAMILTON, Thomas Banks
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    Amministratore
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    British79846610001
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    Amministratore
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporean101200680001
    LAWRENCE, Stephen John
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    Amministratore
    The Old Barn Littleton
    SO22 6QS Winchester
    Hants
    EnglandBritish5579020001
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Amministratore
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MARK, Larry Edward
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    Amministratore
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    New Zealander5076900001
    MCINTEER, Warren Hill
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish100131200001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MORETON, John Ernest
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    Amministratore
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    New Zealander80392940001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Amministratore
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    PHIPPEN, Kent William
    12 Elm Tree Road
    St Johns Wood
    NW8 9JX London
    Amministratore
    12 Elm Tree Road
    St Johns Wood
    NW8 9JX London
    United KingdomAmerican84576560001

    ASHBOURNE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Share charge
    Creato il 29 feb 2008
    Consegnato il 14 mar 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Its whole right, title, interest and benefit in and to the existing shares and related rights, existing shares means ordinary shares of £0.10, number of existing shares 53,648,599. related rights means all dividends see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 14 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 29 feb 2008
    Consegnato il 14 mar 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 14 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Share charge
    Creato il 06 giu 2007
    Consegnato il 19 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The whole right, title, interest and benefit in and to the existing shares and related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 19 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 giu 2007
    Consegnato il 19 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 19 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share charge
    Creato il 07 lug 2006
    Consegnato il 20 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Its whole right title and interest and benefit in and to the existing shares and related rights any additional shares and related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 20 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 lug 2006
    Consegnato il 20 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 20 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share pledge
    Creato il 02 dic 2005
    Consegnato il 15 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Its right, title, interest and benefit in and to the existing shares and related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 15 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession and charge
    Creato il 02 dic 2005
    Consegnato il 15 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 15 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 01 apr 2005
    Consegnato il 19 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever or all monies due or to become due from cannon capital ventures limited on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for the Secured Creditors (The Security Agent)
    Transazioni
    • 19 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share pledge
    Creato il 24 mar 2005
    Consegnato il 08 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares (53,648,599 ordinary shares of £0.10 each in the company, any future shares) and all related assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Agent)
    Transazioni
    • 08 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 10 feb 2005
    Consegnato il 24 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and cannon capital ventures limited to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all estates or interests in any f/h or l/h property now owned by it, and all buildings and fixtures and fixed plant and fixed machinery, all of its book and other debts, any know-how, patent, trade mark, service mark, design, business name, any copyright or other intellectual property monopoly right. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for the Secured Creditors(The Security Agent)
    Transazioni
    • 24 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ASHBOURNE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 giu 2012Data della riunione per approvare il CVA
    20 ago 2012Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Dixon Fleming
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Praticante
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0