ASHBOURNE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ASHBOURNE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02958151 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ASHBOURNE LIMITED?
- Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
Dove si trova ASHBOURNE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ASHBOURNE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ASHBOURNE GROUP UK LIMITED | 08 mar 2001 | 08 mar 2001 |
| SUN HEALTHCARE GROUP UK LIMITED | 22 gen 1999 | 22 gen 1999 |
| SUN HEALTHCARE GROUP INTERNATIONAL LTD. | 30 ago 1994 | 30 ago 1994 |
| BASICTOP LIMITED | 12 ago 1994 | 12 ago 1994 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ASHBOURNE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per ASHBOURNE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario in data 09 ott 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione | 6 pagine | 1.4 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy James Bolot come amministratore in data 17 ago 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore | 4 pagine | 1.1 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 gen 2012 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di William James Buchan come amministratore in data 15 nov 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Andrew Smith come amministratore in data 01 nov 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen Jonathan Taylor come amministratore in data 26 ott 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Timothy James Bolot come amministratore in data 26 ott 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2010 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di William Mcleish come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 gen 2011 con elenco completo degli azionisti | 11 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Midmer come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 gen 2010 con elenco completo degli azionisti | 12 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 27 set 2009 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David Andrew Smith il 07 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Smith come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kamma Foulkes come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ASHBOURNE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR, Stephen Jonathan | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 163496070001 | |||||
| BROUSSARD, Bruce Dale | Segretario | 4920 Calle De Tierra Ne FOREIGN Albuquerque New Mexico | American | 40571230001 | ||||||
| FEENEY, Martin | Segretario | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | British | 53915080001 | ||||||
| FORD, Colin Andrew | Segretario | 12 Willow Drive Milton Of Campsie G66 8DY Glasgow Lanarkshire | British | 70144650001 | ||||||
| HURRELL, Steven Alfred | Segretario | 8 Hamilton Crescent Bearsden G61 3JP Glasgow Strathclyde | British | 82311390001 | ||||||
| KIME, Sean Thomas | Segretario | Flat 1 3 Nevern Place SW5 9NR London | British | 89002440002 | ||||||
| MACFARLANE, Rona Jane | Segretario | 2/2 5 Doune Quadrant G20 6DL Glasgow | British | 62509960001 | ||||||
| MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Segretario | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158304820001 | |||||||
| MCLEISH, William David | Segretario | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
| MURPHY, Charles Furber | Segretario | 8 Tidwells Lea Warfield RG42 3TP Bracknell Berkshire | British | 69603410001 | ||||||
| RUTTER, Christopher | Segretario | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| SPEIRS, Lesley Sarah | Segretario | 22 Douglas Park Crescent Bearsden G61 3DT Glasgow Lanarkshire | British | 69112020001 | ||||||
| WIMER, Mark G | Segretario | 7939 West Bayhill Court 83704 Boise Idaho Usa | American | 52192900001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ABLETT, Julie | Amministratore | 166 Rutland Road West Bridgford NG2 5DZ Nottingham | British | 57906600001 | ||||||
| BOLOT, Timothy James | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 107837080002 | |||||
| BROUSSARD, Bruce Dale | Amministratore | 4920 Calle De Tierra Ne FOREIGN Albuquerque New Mexico | American | 40571230001 | ||||||
| BUCHAN, William James | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 79917240001 | |||||
| COLVIN, William | Amministratore | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890003 | |||||
| DAVIS, Mary | Amministratore | Oakdene 200 Culduthel Road IV2 4BH Inverness | British | 76212360001 | ||||||
| FARRALL, Elaine Ann | Amministratore | Manton Lodge Clumber Park S80 3AX Worksop Nottinghamshire | British | 14241020001 | ||||||
| FEENEY, Martin | Amministratore | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | Scotland | British | 53915080001 | |||||
| FLAHERTY, James Paul | Amministratore | Flat 18 Montagu Court 27-29 Montagu Square W1H 2LG London | American | 100530310001 | ||||||
| FOULKES, Kamma | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| GOSLING, Mark David | Amministratore | Fosse Beck Bewerley HG3 5HX Harrogate | British | 66801660002 | ||||||
| HAMILTON, Thomas Banks | Amministratore | 29 Montrose Avenue G52 4LA Hillington Park Glasgow | British | 79846610001 | ||||||
| JAP, Chee Miau | Amministratore | 8 Thurloe Street SW7 2ST London | United Kingdom | Singaporean | 101200680001 | |||||
| LAWRENCE, Stephen John | Amministratore | The Old Barn Littleton SO22 6QS Winchester Hants | England | British | 5579020001 | |||||
| LOCK, Jason David | Amministratore | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | 144822040001 | |||||
| MARK, Larry Edward | Amministratore | 29 Cedar Drive SL5 0UA Sunningdale Berkshire | New Zealander | 5076900001 | ||||||
| MCINTEER, Warren Hill | Amministratore | 11 Thorn Road Bearsden G61 4PP Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 100131200001 | |||||
| MIDMER, Richard Neil | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 110640170001 | |||||
| MORETON, John Ernest | Amministratore | The Old Farm Winkfield Row RG12 6NG Reading Berkshire | New Zealander | 80392940001 | ||||||
| MURPHY, John | Amministratore | 4 Lochend Road KA10 6JJ Troon | United Kingdom | British | 26177180004 | |||||
| PHIPPEN, Kent William | Amministratore | 12 Elm Tree Road St Johns Wood NW8 9JX London | United Kingdom | American | 84576560001 |
ASHBOURNE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Share charge | Creato il 29 feb 2008 Consegnato il 14 mar 2008 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Its whole right, title, interest and benefit in and to the existing shares and related rights, existing shares means ordinary shares of £0.10, number of existing shares 53,648,599. related rights means all dividends see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 29 feb 2008 Consegnato il 14 mar 2008 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Share charge | Creato il 06 giu 2007 Consegnato il 19 giu 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each charging company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The whole right, title, interest and benefit in and to the existing shares and related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 06 giu 2007 Consegnato il 19 giu 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Share charge | Creato il 07 lug 2006 Consegnato il 20 lug 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Its whole right title and interest and benefit in and to the existing shares and related rights any additional shares and related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 07 lug 2006 Consegnato il 20 lug 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Share pledge | Creato il 02 dic 2005 Consegnato il 15 dic 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Its right, title, interest and benefit in and to the existing shares and related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession and charge | Creato il 02 dic 2005 Consegnato il 15 dic 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 01 apr 2005 Consegnato il 19 apr 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever or all monies due or to become due from cannon capital ventures limited on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Share pledge | Creato il 24 mar 2005 Consegnato il 08 apr 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The shares (53,648,599 ordinary shares of £0.10 each in the company, any future shares) and all related assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 10 feb 2005 Consegnato il 24 feb 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and cannon capital ventures limited to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first legal mortgage all estates or interests in any f/h or l/h property now owned by it, and all buildings and fixtures and fixed plant and fixed machinery, all of its book and other debts, any know-how, patent, trade mark, service mark, design, business name, any copyright or other intellectual property monopoly right. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
ASHBOURNE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA) |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0