GROSVENOR BOSTON LIMITED
Panoramica
Nome della società | GROSVENOR BOSTON LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02966851 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GROSVENOR BOSTON LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
- Attività delle agenzie di lavoro interinale (78200) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova GROSVENOR BOSTON LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Chevron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingdon Middlesex |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GROSVENOR BOSTON LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
PREMIERE NURSING & CARE LIMITED | 16 dic 1994 | 16 dic 1994 |
PRESSCOUNT LIMITED | 12 set 1994 | 12 set 1994 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GROSVENOR BOSTON LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per GROSVENOR BOSTON LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessazione della carica di Jack Rainer Ullmann come amministratore in data 12 mar 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 ago 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Chris Martin Kenneally come amministratore in data 16 mar 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Alan Connor come segretario in data 05 mar 2020 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mr Chris Martin Kenneally come amministratore in data 05 mar 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alan Connor come segretario in data 05 mar 2020 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Chris Martin Kenneally come amministratore in data 05 mar 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 ago 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Conti modificati per una società dormiente redatti al 31 dic 2016 | 7 pagine | AAMD | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 ago 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 ago 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 ago 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2015 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 giu 2015 al 31 dic 2015 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Nomina di Mr Chris Kenneally come amministratore in data 17 set 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 ago 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Steven William Kirkpatrick come amministratore in data 21 lug 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2014 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 ago 2014 con elenco completo degli azionisti | 21 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di GROSVENOR BOSTON LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONNOR, Alan | Segretario | Chevron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingdon Middlesex | 267882660001 | |||||||
ULLMANN, Phillip Lionel | Amministratore | Chevron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingdon Middlesex | England | British | Director | 46458480002 | ||||
BELCHEM, Gary | Segretario | 17 Turkey Oak Close Upper Norwood SE19 2NZ London | British | 66391670002 | ||||||
CONNOR, Alan | Segretario | Chevron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingdon Middlesex | British | Director | 118003220001 | |||||
GARRATT, Mark Jonathan | Segretario | 21 Stradella Road Herne Hill SE24 9HN London | British | 118003050001 | ||||||
MARKS, Dorian Alan | Segretario | The Old Stables Delph New Road OL3 5BA Dobcross Oldham | British | Company Director | 94546740001 | |||||
MARKS, Dorian Alan | Segretario | The Old Stables Delph New Road OL3 5BA Dobcross Oldham | British | Company Director | 94546740001 | |||||
MILLER, David | Segretario | 3 Worsdell Way SG4 0EB Hitchin Hertfordshire | British | 59650030004 | ||||||
TAYLOR, Michael John | Segretario | 6 Garratts Lane SM7 2DZ Banstead Surrey | British | 64380001 | ||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
WACKS CALLER (NOMINEES) LIMITED | Segretario | Wacks Caller Steam Packet House 76 Cross Street M2 4JU Manchester | 77050230003 | |||||||
BLEASDALE, Kathleen Veronica | Amministratore | The Cedars 3 Telegraph Cottage Warren Road KT2 7HU Kingston Upon Thames Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 67650680001 | ||||
CARISS, John Stuart | Amministratore | The Cedars 3 Telegraph Cottage Warren Road KT2 7HU Kingston Upon Thames Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 69554890001 | ||||
CHAPMAN, Clive Richard | Amministratore | Flat 1 36 Oakley Street SW3 5NT London | United Kingdom | British | Company Director | 86129050001 | ||||
DURSTON, Robert | Amministratore | 13 Roundell Road BB18 6EB Barnoldswick Lancashire | British | Company Director | 110017830001 | |||||
HALLIDAY, Steven Don | Amministratore | Laneside Wallbank Road Bramhall SK7 3AP Stockport Cheshire | England | British | Company Director | 61413670001 | ||||
KENNEALLY, Chris Martin | Amministratore | Chevron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingdon Middlesex | Wales | British | Company Director | 267876240001 | ||||
KENNEALLY, Chris Martin | Amministratore | Chevron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingdon Middlesex | Wales | British | Director | 267876240001 | ||||
KIRKPATRICK, Steven William | Amministratore | Chevron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingdon Middlesex | Northern Ireland | Northern Irish | Director | 185295780002 | ||||
MARKS, Dorian Alan | Amministratore | The Old Stables Delph New Road OL3 5BA Dobcross Oldham | British | Company Director | 94546740001 | |||||
MARKS, Dorian Alan | Amministratore | The Old Stables Delph New Road OL3 5BA Dobcross Oldham | British | Company Director | 94546740001 | |||||
O'BRIEN, Fergal | Amministratore | 79 Hermitage Road WA15 8BW Hale Cheshire | Irish | Company Director | 78893160002 | |||||
O'BRIEN, Fergal | Amministratore | 79 Hermitage Road WA15 8BW Hale Cheshire | Irish | Director | 78893160002 | |||||
PERCIVAL, Lorraine Elizabeth | Amministratore | Chevron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingdon Middlesex | United Kingdom | British | Director | 85413680001 | ||||
PILGRIM, Alan John Templer | Amministratore | 44 Pepper Hill Great Amwell SG12 9RZ Ware Hertfordshire | England | British | Chief Executive | 11755290002 | ||||
PINDER, John Richard | Amministratore | West Pelham Manor Park BR7 5QE Chislehurst Kent | British | Finance Director | 78379030001 | |||||
ULLMANN, Jack Rainer | Amministratore | Chevron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingdon Middlesex | England | British | Director | 11342820001 | ||||
ULLMANN, Marianne Flora | Amministratore | Chevron House 346 Long Lane UB10 9PF Hillingdon Middlesex | England | British | Director | 6228260001 | ||||
WILLIAMSON, Lynda | Amministratore | 277 Hardsough Lane Irwell Vale Ewood Bridge BL0 0QF Rossendale Lancashire | British | Training Director | 39140490001 | |||||
WILLIAMSON, Mark | Amministratore | 94 Ringley Road Whitefield M45 7UV Manchester | British | Financial Controller | 64862020001 | |||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||
WACKS CALLER LIMITED | Amministratore | Wacks Caller Steam Packet House 76 Cross Street M2 4JU Manchester | 58396030003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di GROSVENOR BOSTON LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cordant Professional Staffing Limited | 06 apr 2016 | Long Lane Hillingdon UB10 9PF Uxbridge Chevron House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
GROSVENOR BOSTON LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee and debenture | Creato il 07 gen 2000 Consegnato il 26 gen 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creato il 18 ago 1999 Consegnato il 25 ago 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 07 ago 1998 Consegnato il 12 ago 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 22 dic 1997 Consegnato il 09 gen 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 06 mar 1995 Consegnato il 10 mar 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0