GROSVENOR BOSTON LIMITED

GROSVENOR BOSTON LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGROSVENOR BOSTON LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02966851
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GROSVENOR BOSTON LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
    • Attività delle agenzie di lavoro interinale (78200) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova GROSVENOR BOSTON LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GROSVENOR BOSTON LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PREMIERE NURSING & CARE LIMITED16 dic 199416 dic 1994
    PRESSCOUNT LIMITED12 set 199412 set 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di GROSVENOR BOSTON LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per GROSVENOR BOSTON LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di Jack Rainer Ullmann come amministratore in data 12 mar 2021

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 ago 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Chris Martin Kenneally come amministratore in data 16 mar 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Alan Connor come segretario in data 05 mar 2020

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Chris Martin Kenneally come amministratore in data 05 mar 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Alan Connor come segretario in data 05 mar 2020

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Chris Martin Kenneally come amministratore in data 05 mar 2020

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 ago 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    7 pagineAA

    Conti modificati per una società dormiente redatti al 31 dic 2016

    7 pagineAAMD

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 ago 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 ago 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 ago 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2015

    2 pagineAA

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 giu 2015 al 31 dic 2015

    1 pagineAA01

    Nomina di Mr Chris Kenneally come amministratore in data 17 set 2015

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 10 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 ago 2015

    Stato del capitale al 25 ago 2015

    • Capitale: GBP 2.11
    SH01

    Cessazione della carica di Steven William Kirkpatrick come amministratore in data 21 lug 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2014

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    21 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 ago 2014

    Stato del capitale al 22 ago 2014

    • Capitale: GBP 2.11
    SH01

    Chi sono gli amministratori di GROSVENOR BOSTON LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CONNOR, Alan
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Segretario
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    267882660001
    ULLMANN, Phillip Lionel
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Amministratore
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    EnglandBritishDirector46458480002
    BELCHEM, Gary
    17 Turkey Oak Close
    Upper Norwood
    SE19 2NZ London
    Segretario
    17 Turkey Oak Close
    Upper Norwood
    SE19 2NZ London
    British66391670002
    CONNOR, Alan
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Segretario
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    BritishDirector118003220001
    GARRATT, Mark Jonathan
    21 Stradella Road
    Herne Hill
    SE24 9HN London
    Segretario
    21 Stradella Road
    Herne Hill
    SE24 9HN London
    British118003050001
    MARKS, Dorian Alan
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    Segretario
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    BritishCompany Director94546740001
    MARKS, Dorian Alan
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    Segretario
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    BritishCompany Director94546740001
    MILLER, David
    3 Worsdell Way
    SG4 0EB Hitchin
    Hertfordshire
    Segretario
    3 Worsdell Way
    SG4 0EB Hitchin
    Hertfordshire
    British59650030004
    TAYLOR, Michael John
    6 Garratts Lane
    SM7 2DZ Banstead
    Surrey
    Segretario
    6 Garratts Lane
    SM7 2DZ Banstead
    Surrey
    British64380001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    WACKS CALLER (NOMINEES) LIMITED
    Wacks Caller Steam Packet House
    76 Cross Street
    M2 4JU Manchester
    Segretario
    Wacks Caller Steam Packet House
    76 Cross Street
    M2 4JU Manchester
    77050230003
    BLEASDALE, Kathleen Veronica
    The Cedars 3 Telegraph Cottage
    Warren Road
    KT2 7HU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    The Cedars 3 Telegraph Cottage
    Warren Road
    KT2 7HU Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director67650680001
    CARISS, John Stuart
    The Cedars 3 Telegraph Cottage
    Warren Road
    KT2 7HU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    The Cedars 3 Telegraph Cottage
    Warren Road
    KT2 7HU Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director69554890001
    CHAPMAN, Clive Richard
    Flat 1
    36 Oakley Street
    SW3 5NT London
    Amministratore
    Flat 1
    36 Oakley Street
    SW3 5NT London
    United KingdomBritishCompany Director86129050001
    DURSTON, Robert
    13 Roundell Road
    BB18 6EB Barnoldswick
    Lancashire
    Amministratore
    13 Roundell Road
    BB18 6EB Barnoldswick
    Lancashire
    BritishCompany Director110017830001
    HALLIDAY, Steven Don
    Laneside Wallbank Road
    Bramhall
    SK7 3AP Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    Laneside Wallbank Road
    Bramhall
    SK7 3AP Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director61413670001
    KENNEALLY, Chris Martin
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Amministratore
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    WalesBritishCompany Director267876240001
    KENNEALLY, Chris Martin
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Amministratore
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    WalesBritishDirector267876240001
    KIRKPATRICK, Steven William
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Amministratore
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Northern IrelandNorthern IrishDirector185295780002
    MARKS, Dorian Alan
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    Amministratore
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    BritishCompany Director94546740001
    MARKS, Dorian Alan
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    Amministratore
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    BritishCompany Director94546740001
    O'BRIEN, Fergal
    79 Hermitage Road
    WA15 8BW Hale
    Cheshire
    Amministratore
    79 Hermitage Road
    WA15 8BW Hale
    Cheshire
    IrishCompany Director78893160002
    O'BRIEN, Fergal
    79 Hermitage Road
    WA15 8BW Hale
    Cheshire
    Amministratore
    79 Hermitage Road
    WA15 8BW Hale
    Cheshire
    IrishDirector78893160002
    PERCIVAL, Lorraine Elizabeth
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Amministratore
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector85413680001
    PILGRIM, Alan John Templer
    44 Pepper Hill
    Great Amwell
    SG12 9RZ Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    44 Pepper Hill
    Great Amwell
    SG12 9RZ Ware
    Hertfordshire
    EnglandBritishChief Executive11755290002
    PINDER, John Richard
    West Pelham
    Manor Park
    BR7 5QE Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    West Pelham
    Manor Park
    BR7 5QE Chislehurst
    Kent
    BritishFinance Director78379030001
    ULLMANN, Jack Rainer
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Amministratore
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    EnglandBritishDirector11342820001
    ULLMANN, Marianne Flora
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Amministratore
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    EnglandBritishDirector6228260001
    WILLIAMSON, Lynda
    277 Hardsough Lane
    Irwell Vale Ewood Bridge
    BL0 0QF Rossendale
    Lancashire
    Amministratore
    277 Hardsough Lane
    Irwell Vale Ewood Bridge
    BL0 0QF Rossendale
    Lancashire
    BritishTraining Director39140490001
    WILLIAMSON, Mark
    94 Ringley Road
    Whitefield
    M45 7UV Manchester
    Amministratore
    94 Ringley Road
    Whitefield
    M45 7UV Manchester
    BritishFinancial Controller64862020001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    WACKS CALLER LIMITED
    Wacks Caller Steam Packet House
    76 Cross Street
    M2 4JU Manchester
    Amministratore
    Wacks Caller Steam Packet House
    76 Cross Street
    M2 4JU Manchester
    58396030003

    Chi sono le persone con controllo significativo di GROSVENOR BOSTON LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Cordant Professional Staffing Limited
    Long Lane
    Hillingdon
    UB10 9PF Uxbridge
    Chevron House
    England
    06 apr 2016
    Long Lane
    Hillingdon
    UB10 9PF Uxbridge
    Chevron House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEnglish
    Luogo di registrazioneUk Companies House
    Numero di registrazione1397983
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    GROSVENOR BOSTON LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 07 gen 2000
    Consegnato il 26 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Security Beneficiaries
    Transazioni
    • 26 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 18 ago 1999
    Consegnato il 25 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Security Trustee for the Securitybeneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 25 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 ago 1998
    Consegnato il 12 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 22 dic 1997
    Consegnato il 09 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 06 mar 1995
    Consegnato il 10 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0