ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED

ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02967532
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JOHN DOYLE MAINTENANCE LIMITED04 nov 199404 nov 1994
    DETAILSTOCK LIMITED14 set 199414 set 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Latham Nelson il 25 nov 2021

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    16 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Birch il 16 gen 2020

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Andrew Lee Milner come amministratore in data 12 dic 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    12 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Sherard Secretariat Services Limited il 02 set 2019

    1 pagineCH04

    Modifica dei dettagli di Accord Limited come persona con controllo significativo il 02 set 2019

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da The Sherard Building Edmund Halley Road Oxford OX4 4DQ a Chancery Exchange 10 Furnival Street London EC4A 1AB in data 02 set 2019

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2017 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Accord Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    11 pagineAA

    Nomina di Mr Paul Birch come amministratore in data 12 mag 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    10 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    Segretario
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione5615519
    109588620001
    BIRCH, Paul
    142 Speke Road
    L19 2PH Liverpool
    The Matchworks
    England
    England
    Amministratore
    142 Speke Road
    L19 2PH Liverpool
    The Matchworks
    England
    England
    United KingdomBritish76116640004
    NELSON, Andrew Latham
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Amey
    United Kingdom
    Amministratore
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Amey
    United Kingdom
    EnglandBritish36191090004
    BIRCH, Paul
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Segretario
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    British76116640002
    HARVEY, Stephen George
    163 High Road
    EN10 7BT Broxbourne
    Hertfordshire
    Segretario
    163 High Road
    EN10 7BT Broxbourne
    Hertfordshire
    British67162750001
    KELLY, Paula Frona
    12 Chells Lane
    SG2 7AA Stevenage
    Herts
    Segretario
    12 Chells Lane
    SG2 7AA Stevenage
    Herts
    British95469920001
    PRYOR, Peter David
    Jay Cottage
    Little Hormead
    SG9 0LZ Buntingford
    Hertfordshire
    Segretario
    Jay Cottage
    Little Hormead
    SG9 0LZ Buntingford
    Hertfordshire
    British67736270003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ABBEY, Geoffrey Michael
    The Habit
    The Street
    SG11 2QR Braughing
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Habit
    The Street
    SG11 2QR Braughing
    Hertfordshire
    British65112520001
    ARNOLD, David Llewelyn
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish181213200001
    ATHERTON, David
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish109058740001
    CHASTON, Stuart Paul
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish126271790001
    CHEETHAM, James Richard
    Ashfield
    Weston Rhyn
    SY10 7SD Oswestry
    Salop
    Amministratore
    Ashfield
    Weston Rhyn
    SY10 7SD Oswestry
    Salop
    British45753210001
    EWELL, Melvyn
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Amministratore
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    EnglandBritish61515760002
    FARRAR, Roland Martin
    40 Chiltern Road
    SL6 1XA Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    40 Chiltern Road
    SL6 1XA Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritish29009510002
    FELLOWES PRYNNE, Philip Windover
    76 The Shearers
    St Michaels Mead
    CM23 4AZ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    76 The Shearers
    St Michaels Mead
    CM23 4AZ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British80861440001
    FRASER, Ian Ellis
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    ScotlandUk28393850006
    JOYCE, Martin John
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish72254420003
    KIRKBY, Neil Robert Ernest
    5 Dashwood Close
    Grappenhall
    WA4 3JA Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    5 Dashwood Close
    Grappenhall
    WA4 3JA Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish51438040006
    MCLAUGHLIN, Owen Gerard
    Greyfriars Hall
    Walker Lane Fulwood
    PR2 7AN Preston
    Lancashire
    Amministratore
    Greyfriars Hall
    Walker Lane Fulwood
    PR2 7AN Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish17129800004
    MILLER, Paul Sydney
    26 Mardley Hill
    AL6 0TS Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    26 Mardley Hill
    AL6 0TS Welwyn
    Hertfordshire
    British39022040001
    MILNER, Andrew Lee
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Amministratore
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    EnglandBritish133714170002
    PRYOR, Peter David
    Jay Cottage
    Little Hormead
    SG9 0LZ Buntingford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Jay Cottage
    Little Hormead
    SG9 0LZ Buntingford
    Hertfordshire
    EnglandBritish67736270003
    SHUTKEVER, Adam Emmanuel
    11 Oakfield Road
    AL5 2NJ Harpenden
    Herts
    Amministratore
    11 Oakfield Road
    AL5 2NJ Harpenden
    Herts
    United KingdomBritish81455510002
    STEFANOU, Stefanos
    13 Park Mews
    AL9 5EP Hatfield
    Hertfordshire
    Amministratore
    13 Park Mews
    AL9 5EP Hatfield
    Hertfordshire
    EnglandBritish44867700001
    STEFANOU, Stelio Haralambos
    1 Tewin Water House
    Tewin Water
    AL6 0AA Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 Tewin Water House
    Tewin Water
    AL6 0AA Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritish2749630007
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    06 apr 2016
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3693911
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 12 nov 2007
    Consegnato il 28 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become from each obligor and each grantor of security to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee, Richard Butcher as Pension Trustee, Pitman Trusteeslimited as Pension Trustee, Philip Bridge as Pension Trustee and Each of Their Assignors Transferees and Successiors from Time to Time
    Transazioni
    • 28 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 20 dic 2006
    Consegnato il 22 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to the finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the security created under the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 22 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A guarantee and debenture
    Creato il 25 giu 1999
    Consegnato il 05 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the present and/or future obligations and liabilities due or to become due from the company to national westminster bank PLC as agent and trustee for the secured parties (the "security trustee") and any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined)(including the debenture)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 nov 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 10 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 31 mar 1995
    Consegnato il 04 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 nov 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 10 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0