CHARLTON GROUP (UK) LIMITED

CHARLTON GROUP (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCHARLTON GROUP (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02968513
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CHARLTON GROUP (UK) LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova CHARLTON GROUP (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    16 Beecham Court
    Smithy Brook Road
    WN3 6PR Pemberton Wigan
    Lancashire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CHARLTON GROUP (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE BOLTON GROUP (NW) LIMITED24 giu 199624 giu 1996
    SUITEACE LIMITED16 set 199416 set 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di CHARLTON GROUP (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per CHARLTON GROUP (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Mark Shakespeare come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Sara Simpson come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Philip Talbot come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 14 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 ott 2010

    Stato del capitale al 04 ott 2010

    • Capitale: GBP 114,570
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2009

    8 pagineAA

    Nomina di Ms Sara Simpson come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Chris Sedwell come segretario

    1 pagineTM02

    legacy

    11 pagineMG01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2008

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 set 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2007

    8 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Agreement 04/03/2009
    RES13

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di CHARLTON GROUP (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RYDER, Derek
    Eaves Brow Farm House
    Spring Lane Croft
    WA3 7AT Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    Eaves Brow Farm House
    Spring Lane Croft
    WA3 7AT Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish77864510001
    BEIRNE, David
    15 Meneval Place
    Farmleigh Dunmore Road
    IRISH Waterford
    Ireland
    Segretario
    15 Meneval Place
    Farmleigh Dunmore Road
    IRISH Waterford
    Ireland
    British107267410001
    BOLTON, Valerie Muriel
    49 Weir Lane,Martins Croft
    Woolston
    WA1 4QH Warrington
    Segretario
    49 Weir Lane,Martins Croft
    Woolston
    WA1 4QH Warrington
    English34007990001
    EDGE, Christine Anne
    622 Manchester Road
    Westhoughton
    BL5 3JD Bolton
    Greater Manchester
    Segretario
    622 Manchester Road
    Westhoughton
    BL5 3JD Bolton
    Greater Manchester
    British40498690001
    HALE, Debbie
    Stillwaters 2 Langton Brow
    Longbridge
    PR3 3XH Preston
    Lancashire
    Segretario
    Stillwaters 2 Langton Brow
    Longbridge
    PR3 3XH Preston
    Lancashire
    British125920160001
    INGLIS, James Cormack
    51 Cranleigh Drive
    Brooklands
    M33 3PN Sale
    Manchester
    Segretario
    51 Cranleigh Drive
    Brooklands
    M33 3PN Sale
    Manchester
    Scottish92168830001
    RUSSELL, Peter George
    2 Pilgrims Way
    Standish
    WN6 0AJ Wigan
    Lancashire
    Segretario
    2 Pilgrims Way
    Standish
    WN6 0AJ Wigan
    Lancashire
    British69575640001
    SEDWELL, Chris
    Benton Drive Dukes Manor
    CH22RD Chester
    14
    Uk
    Segretario
    Benton Drive Dukes Manor
    CH22RD Chester
    14
    Uk
    Other135182100001
    SHAKESPEARE, Mark
    Blackbourne Square Rathfarnham Gate
    DUBLIN 14 Rathfarnham
    6
    Dublin
    Ireland
    Segretario
    Blackbourne Square Rathfarnham Gate
    DUBLIN 14 Rathfarnham
    6
    Dublin
    Ireland
    Irish134503090001
    SIMPSON, Sara
    128 Hesketh Lane
    Tarleton
    PR4 6AS Preston
    Lock Cottage
    Lancashire
    Segretario
    128 Hesketh Lane
    Tarleton
    PR4 6AS Preston
    Lock Cottage
    Lancashire
    152306610001
    SUTCLIFFE, Julian Alexander
    4 Ashtree Grove
    Penwortham
    PR1 0XX Preston
    Lancashire
    Segretario
    4 Ashtree Grove
    Penwortham
    PR1 0XX Preston
    Lancashire
    British76858070001
    TALBOT, Philip
    3 Upton Park
    CH2 1DF Chester
    Cheshire
    Segretario
    3 Upton Park
    CH2 1DF Chester
    Cheshire
    British113553070001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BOLTON, Charles Thomas
    49 Weir Lane
    Woolston
    WA1 4QH Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    49 Weir Lane
    Woolston
    WA1 4QH Warrington
    Cheshire
    British24335490001
    BOLTON, Paul Charles
    Holly House
    71a The Common Parbold
    WN8 7EA Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    Holly House
    71a The Common Parbold
    WN8 7EA Wigan
    Lancashire
    EnglandBritish41225050003
    BOLTON, Valerie Muriel
    49 Weir Lane,Martins Croft
    Woolston
    WA1 4QH Warrington
    Amministratore
    49 Weir Lane,Martins Croft
    Woolston
    WA1 4QH Warrington
    English34007990001
    CONNOR, Mark, Director
    15 Ewanville
    L36 5YS Huyton With Roby
    Liverpool
    Amministratore
    15 Ewanville
    L36 5YS Huyton With Roby
    Liverpool
    United KingdomBritish72461640001
    HAWKESWORTH, Mark Ledlie
    Locktons Farmhouse Church Lane
    Harwell Village
    OX11 0EZ Didcot
    Oxfordshire
    Amministratore
    Locktons Farmhouse Church Lane
    Harwell Village
    OX11 0EZ Didcot
    Oxfordshire
    British13797240001
    LLOYD, Ian
    Rosebank Wingates Lane
    Westhoughton
    BL5 3LP Bolton
    Lancs
    Amministratore
    Rosebank Wingates Lane
    Westhoughton
    BL5 3LP Bolton
    Lancs
    British16794570001
    O'CONNOR, Barry
    Ardfert
    Whitshed Road
    IRISH Greystones
    Co Wicklow
    Amministratore
    Ardfert
    Whitshed Road
    IRISH Greystones
    Co Wicklow
    IrelandIrish57553900001
    O'DONNELL, Eoin Michael
    11 Eaton Mews
    Handbridge
    CH4 7EJ Chester
    Cheshire
    Amministratore
    11 Eaton Mews
    Handbridge
    CH4 7EJ Chester
    Cheshire
    Irish119888820001
    O'FLYNN, Patrick Mary
    65 Southgate
    HX5 0DQ Elland
    West Yorkshire
    Amministratore
    65 Southgate
    HX5 0DQ Elland
    West Yorkshire
    Gb-EngIrish39165690003
    RUSSELL, Peter George
    Lane,
    L40 4BL Hoscar, Nr Lathom
    53,Deans
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lane,
    L40 4BL Hoscar, Nr Lathom
    53,Deans
    Lancashire
    United Kingdom
    British130160280001
    SMITH, Ronald
    St Michaels
    Golly Burton Rossett
    LL12 0AH Wrexham
    Clwyd
    Amministratore
    St Michaels
    Golly Burton Rossett
    LL12 0AH Wrexham
    Clwyd
    British5826110001
    SUTCLIFFE, Julian Alexander
    4 Ashtree Grove
    Penwortham
    PR1 0XX Preston
    Lancashire
    Amministratore
    4 Ashtree Grove
    Penwortham
    PR1 0XX Preston
    Lancashire
    British76858070001
    SWANSON, Ian Walter
    Oakthwaite
    Thornbarrow Road
    LA23 2DQ Windermere
    Cumbria
    Amministratore
    Oakthwaite
    Thornbarrow Road
    LA23 2DQ Windermere
    Cumbria
    British44888590002
    TALBOT, Philip
    1 St Ronans Terrace
    EH10 5NG Edinburgh
    Amministratore
    1 St Ronans Terrace
    EH10 5NG Edinburgh
    United KingdomBritish113553070002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    CHARLTON GROUP (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental deed of fixed charge
    Creato il 21 gen 2010
    Consegnato il 05 feb 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each of the obligors to the beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge all rights, title and interest from time to time in relation to the inter-company receivables see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 feb 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 03 lug 2006
    Consegnato il 06 lug 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 06 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 23 mar 2005
    Consegnato il 26 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 mar 2003
    Consegnato il 11 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 gen 2003
    Consegnato il 25 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at st stephen street, salford. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 mag 2002
    Consegnato il 25 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a apartment 12 fourth floor halton garden liverpool t/n MS401234. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 gen 2002
    Consegnato il 08 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage apartment 11 ground floor hatton garden liverpool L3 2HA. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 gen 2002
    Consegnato il 08 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Apartment 13 (postal 14) ground floor, hatton garden liverpool L3 2HA. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 gen 2001
    Consegnato il 13 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that property k/a apartment 420 fourth floor hatton gardens liverpool merseyside. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 13 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 08 gen 2001
    Consegnato il 13 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A floating charge over the. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 13 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 03 gen 1995
    Consegnato il 10 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 dic 1994
    Consegnato il 05 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement of even date
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lazard Funds (Nominees) Limited
    Transazioni
    • 05 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0