WATES CITY POINT LIMITED

WATES CITY POINT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWATES CITY POINT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02973114
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WATES CITY POINT LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova WATES CITY POINT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WATES CITY POINT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NUMBER 27/35 CANNON STREET LIMITED27 gen 199527 gen 1995
    BISHOLD LIMITED03 ott 199403 ott 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di WATES CITY POINT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per WATES CITY POINT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2018

    14 pagineAA

    legacy

    186 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    3 pagineAA

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2016

    14 pagineAA

    legacy

    210 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Cessazione della carica di Philip John Martin come amministratore in data 31 ott 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Philip John Martin come segretario in data 31 ott 2016

    1 pagineTM02

    Nomina di British Land Company Secretarial Limited come segretario in data 31 ott 2016

    2 pagineAP04

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Mr Charles John Middleton come amministratore in data 13 lug 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Jonathan Charles Mcnuff come amministratore in data 13 lug 2016

    2 pagineAP01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2015 al 31 mar 2016

    1 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 ott 2015

    Stato del capitale al 19 ott 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 03 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 ott 2014

    Stato del capitale al 09 ott 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2013

    15 pagineAA

    legacy

    184 paginePARENT_ACC

    Chi sono gli amministratori di WATES CITY POINT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Segretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione8992198
    187856670001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Amministratore
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish205624050001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Amministratore
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish79841030002
    MARTIN, Philip John
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Segretario
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    British35118050001
    ROGERS, Edward
    89 Essex Road
    Islington
    N1 2SJ London
    Segretario
    89 Essex Road
    Islington
    N1 2SJ London
    British70588860003
    WILSON, Michael Anthony
    4 Alleyn Road
    SE21 8AL London
    Segretario
    4 Alleyn Road
    SE21 8AL London
    British68971270001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Segretario nominato
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006420001
    BERESFORD, Valentine Tristram
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    Amministratore
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    EnglandBritish40766290003
    CLUTTON, Rodney
    Grange Farm
    CV23 8DJ Grandborough
    Warwickshire
    Amministratore
    Grange Farm
    CV23 8DJ Grandborough
    Warwickshire
    British4388360001
    DOYLE, Eugene Francis
    2 Gombards
    AL3 5NW St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    2 Gombards
    AL3 5NW St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomIrish73961570001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Amministratore
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    MARTIN, Philip John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish35118050001
    MCGANN, Martin Francis
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    Amministratore
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    British109383240001
    NETTLETON, John Dering
    Newington House
    OX10 7AG Warborough
    Oxfordshire
    Amministratore
    Newington House
    OX10 7AG Warborough
    Oxfordshire
    EnglandEnglish1866530002
    O'DONOGHUE, Mark
    10 Corrance Road
    SW2 5RH London
    Amministratore
    10 Corrance Road
    SW2 5RH London
    British55336480001
    PRICE, Humphrey James Montgomery
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    Amministratore
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    UkBritish14448630001
    ROGERS, Edward
    89 Essex Road
    Islington
    N1 2SJ London
    Amministratore
    89 Essex Road
    Islington
    N1 2SJ London
    British70588860003
    SMITH, Andrew David
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish108214880002
    STIRLING, Mark Andrew
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    Amministratore
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    United KingdomBritish106882210001
    VAUGHAN, Patrick Lionel
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    Amministratore
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    United KingdomBritish73972350001
    WATES, Paul Christopher Ronald
    Bellasis House
    Headley Heath Approach Mickleham
    RH5 6DH Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Bellasis House
    Headley Heath Approach Mickleham
    RH5 6DH Dorking
    Surrey
    EnglandBritish2119440001
    NOROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Amministratore delegato nominato
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006410001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Amministratore delegato nominato
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006420001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WATES CITY POINT LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Wates City Of London Properties Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 apr 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    WATES CITY POINT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 05 lug 2004
    Consegnato il 14 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of shares
    Creato il 05 lug 2004
    Consegnato il 14 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage or first fixed charge all shares by way of a first fixed charge all related rights being any dividend or interest paid or payable in relation to any share.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 lug 2001
    Consegnato il 31 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined) and any reference thereto in the debenture shall include all or any part thereof
    Brevi particolari
    5 cheapsidelondon EC2 t/no: NGL155905 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais
    Transazioni
    • 31 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement between each chargor (as defined) and the agent
    Creato il 02 lug 2001
    Consegnato il 16 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) to any finance party (as defined) under each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    Freehold land k/a city point (formerly k/a britannic tower) moor lane london EC2 t/n NGL745546 for further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transazioni
    • 16 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ago 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 14 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of shares between each chargor (as defined) and the agent
    Creato il 02 lug 2001
    Consegnato il 16 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) to any finance party (as defined) under each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all shares and by way of first fixed charge all related rights including dividents please see form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transazioni
    • 16 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 18 apr 2001
    Consegnato il 03 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities of the company to any finance party (as defined) under each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (Facility Agent)
    Transazioni
    • 03 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of shares
    Creato il 20 mar 2000
    Consegnato il 30 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    In favour of the chargee all present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to the finance parties (or any of them) under each finance document
    Brevi particolari
    By way of a first legal mortgage all shares, by way of a first fixed charge its interest in all shares and all related rights.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Depfa Deutsche Pfandbriefbank Aktiengesellschaft (The "Agent")
    Transazioni
    • 30 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 mar 1999
    Acquisito il 17 lug 2001
    Consegnato il 06 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents (as defined therein)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital including bookdebts benefit of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais
    Transazioni
    • 06 ago 2001Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 14 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 mar 1998
    Consegnato il 09 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to deutsche pfandbrief- und hypothekenbank aktiengesellschaft (the "agent") and the finance parties (as defined) or any of them under each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Pfandbrief-Und Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 09 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 30 gen 1998
    Consegnato il 17 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under each of the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    F/H property k/a ling house 10-13 dominion street london t/no: LN170275 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Pfandbrief-Und Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 17 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 dic 1997
    Consegnato il 24 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee under each of the finance documents (as therein defined) to which such obligor is a party except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening S151 of the companies act 1985
    Brevi particolari
    F/H land k/a city tower (formerly britannic tower) moor lane london EC2 t/n NGL745546. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Pfandbrief- Und Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 24 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 31 dic 1996
    Consegnato il 02 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the peice of f/h and l/h land froming part of t/n's NGL686627 and LN220372 and all buildings and fixtures thereon the procceds of sale thereof and the benefit of any covenants in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC(As Agent and Trustee for Itself and Each Otherfinace Party)
    Transazioni
    • 02 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 apr 1996
    Consegnato il 07 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to the finance parties (or any of them) under each of the finance documents to which such obligor is a party except for any obligation which, if it were so included, would result in the chargor debenture contravening section 151 of the companies act 1985
    Brevi particolari
    Interest in an agreement dated 22ND march 1996 relating to the purchase of all that piece or parcel of land forming part of t/nos:-NGL686627 and LN220372. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Plcas Agent and Trustee for the Finance Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 07 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0