RENDOUR LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRENDOUR LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02974394
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RENDOUR LIMITED?

    • (7012) /

    Dove si trova RENDOUR LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4 Farm Street
    Mayfair
    W1J 5RD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di RENDOUR LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per RENDOUR LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 06 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 nov 2010

    Stato del capitale al 04 nov 2010

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 06 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 gen 2009

    12 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 gen 2008

    14 pagineAA

    legacy

    7 pagine363a

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 gen 2007

    13 pagineAA

    legacy

    7 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 gen 2006

    13 pagineAA

    legacy

    8 pagine363s

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 31 gen 2005

    12 pagineAA

    legacy

    8 pagine363s

    legacy

    pagine363(288)

    legacy

    8 pagine363s

    legacy

    pagine363(288)

    Bilancio redatto al 31 gen 2004

    13 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di RENDOUR LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ELLIOTT, Graham Hadden Dean
    7 Woden Avenue
    Stanway
    CO3 0QY Colchester
    Essex
    Segretario
    7 Woden Avenue
    Stanway
    CO3 0QY Colchester
    Essex
    British49198120003
    JONES, Stephen Douglas
    Oak Lodge
    Watts Lane
    BR7 5PJ Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    Oak Lodge
    Watts Lane
    BR7 5PJ Chislehurst
    Kent
    United KingdomBritish8695620002
    TWEEDDALE-TYE, David Michael Francis
    Tompson's Farm 64 High Street
    Long Crendon
    HP18 9AL Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Tompson's Farm 64 High Street
    Long Crendon
    HP18 9AL Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish111888220001
    WILSON, Andrew Luis
    Alassio
    243 Thorpe Hall Avenue
    SS1 3SG Thorpe Bay Southend
    Essex
    Amministratore
    Alassio
    243 Thorpe Hall Avenue
    SS1 3SG Thorpe Bay Southend
    Essex
    United KingdomBritish31101960006
    ELLIOTT, Graham Hadden Dean
    7 Woden Avenue
    Stanway
    CO3 0QY Colchester
    Essex
    Segretario
    7 Woden Avenue
    Stanway
    CO3 0QY Colchester
    Essex
    British49198120003
    JONES, Stephen Douglas
    Oak Lodge
    Watts Lane
    BR7 5PJ Chislehurst
    Kent
    Segretario
    Oak Lodge
    Watts Lane
    BR7 5PJ Chislehurst
    Kent
    British8695620002
    WHITE, Timothy Scott
    Cornwall Road
    AL1 1SQ St Albans
    37
    Hertfordshire
    Segretario
    Cornwall Road
    AL1 1SQ St Albans
    37
    Hertfordshire
    British94700490001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Segretario nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    TAYLOR, Neal Anthony
    Weybridge Park
    KT13 8SJ Weybridge
    9
    Surrey
    Amministratore
    Weybridge Park
    KT13 8SJ Weybridge
    9
    Surrey
    EnglandEnglish65914360002
    WILDMAN, Alexander James Franklin
    Chesson Road
    W14 9QU London
    102
    Amministratore
    Chesson Road
    W14 9QU London
    102
    United KingdomBritish44059520002
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    RENDOUR LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture containing fixed and floating charges
    Creato il 08 lug 2002
    Consegnato il 16 lug 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 06 ago 2001
    Consegnato il 14 ago 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a fenchurch court garsington road cowley oxford t/n ON164221. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 30 nov 2000
    Consegnato il 02 dic 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 30 nov 2000
    Consegnato il 02 dic 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    413-416 the strand in the city of westminster t/n ngl 268474. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Assignation and irrevocable mandate
    Creato il 26 apr 1999
    Consegnato il 07 mag 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rents from (I) 15 and 17 south st andrew street,edinburgh and (ii) 113/115 george st,edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 29 april 1999 and
    Creato il 21 apr 1999
    Consegnato il 08 mag 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in the terms of a personal bond dated 21 april 1999
    Brevi particolari
    113/115 george street edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 29 april 1999 and
    Creato il 19 apr 1999
    Consegnato il 08 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in the terms of a personal bond dated 29 april 1999
    Brevi particolari
    15/17 south st. Andrew street edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rents assignment
    Creato il 21 giu 1995
    Consegnato il 01 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from tranmac limited and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of a mortgage debenture dated 21ST may 1992 and all deeds supplemental thereto (as defined in the rents agreement)
    Brevi particolari
    All the companys right title and interest present and future to and in rent and all other monies due to tranmac limited under any lease or future leases in respect of the brunswick centre london WC1. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais
    Transazioni
    • 01 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of variation
    Creato il 21 giu 1995
    Consegnato il 01 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    And varying the terms of a mortgage debenture dated 21ST may 1992
    Brevi particolari
    All the companys rights title and interest in an underlease of part of the lower basement car park comprising part of the brunswick centre london together with floating charge over companys undertaking other property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais
    Transazioni
    • 01 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Account charge deed
    Creato il 21 giu 1995
    Consegnato il 01 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from tranmac limited to the chargee under the terms of the loan agreement dated 21ST june 1995 and all monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the account charge deed
    Brevi particolari
    All monies fro time to time credited to and for the time being standing to the credit of the collection account the deposit account the rent account and the service charge account (as defined in in the account charge deed and the loan agreement) together with all interest, the accounts and all other assets of the company pursuant to the terms of the account charge deed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais
    Transazioni
    • 01 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Acquisition of property
    Creato il 12 apr 1995
    Acquisito il 31 mar 1995
    Consegnato il 12 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due
    Brevi particolari
    The sum or sums standing to the credit of account no 50881457. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais
    Transazioni
    • 12 apr 1995Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 27 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge and set off
    Creato il 21 mag 1992
    Acquisito il 31 mar 1995
    Consegnato il 12 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due
    Brevi particolari
    The sum or sums standing to the credit of deposit account no 001129931-100-00. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais
    Transazioni
    • 12 apr 1995Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 27 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 21 mag 1992
    Acquisito il 31 mar 1995
    Consegnato il 12 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due
    Brevi particolari
    The rents and other payments due under the terms of the leases over the property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais
    Transazioni
    • 12 apr 1995Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 27 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge and set off
    Creato il 21 mag 1992
    Acquisito il 31 mar 1995
    Consegnato il 12 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due
    Brevi particolari
    The sums standing to the credit of deposit account number 001129931-102-00. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais
    Transazioni
    • 12 apr 1995Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 27 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge and set off
    Creato il 21 mag 1992
    Acquisito il 31 mar 1995
    Consegnato il 12 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due
    Brevi particolari
    The sums or sums standing to the credit of deposit account no 001129931-101-00. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais
    Transazioni
    • 12 apr 1995Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 27 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 21 mag 1992
    Acquisito il 31 mar 1995
    Consegnato il 12 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due
    Brevi particolari
    F/H property k/a the brunswick centre being land & buildings in marchmont street bernard street and brunswick square t/no NGL222023 with fixtures & fittings etc. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais
    Transazioni
    • 12 apr 1995Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 27 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0