THE HUNSLET ENGINE COMPANY LIMITED

THE HUNSLET ENGINE COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE HUNSLET ENGINE COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02982088
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE HUNSLET ENGINE COMPANY LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova THE HUNSLET ENGINE COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Howard House Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Staffordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE HUNSLET ENGINE COMPANY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CHAMBAY LIMITED21 ott 199421 ott 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE HUNSLET ENGINE COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per THE HUNSLET ENGINE COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 06 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 nov 2015

    Stato del capitale al 05 nov 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA

    legacy

    25 paginePARENT_ACC

    legacy

    2 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Nomina di Mr Michael James Isaac come amministratore in data 01 giu 2015

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 06 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 ott 2014

    Stato del capitale al 09 ott 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA

    legacy

    29 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Bilancio annuale redatto al 06 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 ott 2013

    Stato del capitale al 09 ott 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    2 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB* in data 17 apr 2013

    1 pagineAD01

    Nomina di David James Meyer come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Keith Hildum come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Christopher John Weatherall come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Graham Lee come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Graham Lee come amministratore

    2 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Howard House Graycar Business Park Barton Turns Barton Under Needwood Burton on Trent DE13 8EN* in data 11 ott 2012

    2 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 06 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    3 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di THE HUNSLET ENGINE COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ISAAC, Michael James
    259 Morley Road
    Oakwood
    DE21 4TD Derby
    Derbyshire
    Segretario
    259 Morley Road
    Oakwood
    DE21 4TD Derby
    Derbyshire
    BritishAccountant106397180001
    HILDUM, Keith Patrick
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    England
    United StatesAmericanVp Treasurer134557260001
    ISAAC, Michael James
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    Amministratore
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    EnglandBritishChartered Accountant106397180001
    MEYER, David James
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    England
    United StatesAmericanGroup Executive176950830001
    WEATHERALL, Christopher John
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    Graycar Business Park, Barton Turn
    Barton Under Needwood
    DE13 8EN Burton-On-Trent
    Howard House
    Staffordshire
    England
    EnglandBritishManaging Director172779280001
    BARKER, Jack
    21 Silverdale Drive
    Guiseley
    LS20 8BE Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    21 Silverdale Drive
    Guiseley
    LS20 8BE Leeds
    West Yorkshire
    BritishSolicitors Clerk34404400001
    CARR, Alan David
    11 Hogan Drive
    ML10 6EP Strathaven
    Lanarkshire
    Segretario
    11 Hogan Drive
    ML10 6EP Strathaven
    Lanarkshire
    British55885020002
    CONNELL, Brian
    9 Duart Avenue
    KA9 1NA Prestwick
    Ayrshire
    Segretario
    9 Duart Avenue
    KA9 1NA Prestwick
    Ayrshire
    BritishAccountant86550560001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Segretario nominato
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    FORD, Raymond Harry
    The Old Vicarage 50 Leeds Road
    Oulton
    LS26 8JY Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    The Old Vicarage 50 Leeds Road
    Oulton
    LS26 8JY Leeds
    West Yorkshire
    BritishManaging Director41520890001
    GUNN, Robert Diamond
    38 Merrygreen Place
    Stewarton
    KA3 5EP Kilmarnock
    Ayrshire
    Segretario
    38 Merrygreen Place
    Stewarton
    KA3 5EP Kilmarnock
    Ayrshire
    BritishAccountant78721300001
    GUNN, Robert Diamond
    38 Merrygreen Place
    Stewarton
    KA3 5EP Kilmarnock
    Ayrshire
    Segretario
    38 Merrygreen Place
    Stewarton
    KA3 5EP Kilmarnock
    Ayrshire
    BritishAccountant78721300001
    SPEIRS, William Mitchell
    3 Saint Cuthberts Crescent
    KA9 2EG Prestwick
    Ayrshire
    Segretario
    3 Saint Cuthberts Crescent
    KA9 2EG Prestwick
    Ayrshire
    British68895520001
    BARCLAY, Alexander
    Ferndale, 5 Montgomerie Terrace
    KA7 1JL Ayr
    Ayrshire
    Amministratore
    Ferndale, 5 Montgomerie Terrace
    KA7 1JL Ayr
    Ayrshire
    BritishDirector31262390002
    BARKER, Jack
    21 Silverdale Drive
    Guiseley
    LS20 8BE Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    21 Silverdale Drive
    Guiseley
    LS20 8BE Leeds
    West Yorkshire
    BritishSolicitors Clerk34404400001
    BAUER, Sylvia, Ing Mag
    Scheunenpasse 25-33/1/16
    3430 Tullin
    Austria
    Amministratore
    Scheunenpasse 25-33/1/16
    3430 Tullin
    Austria
    AustrianDirector85253810001
    COUPER, Neale Sansome
    Drumclog Cottage
    Drumclog
    ML10 6QL Strathaven
    Lanarkshire
    Amministratore
    Drumclog Cottage
    Drumclog
    ML10 6QL Strathaven
    Lanarkshire
    BritishManager640920001
    DICKSON, Michael Ian Ross
    Cadgers Way Grange
    Earlsferry, Elie
    KY9 1AN Leven
    Fife
    Amministratore
    Cadgers Way Grange
    Earlsferry, Elie
    KY9 1AN Leven
    Fife
    ScotlandBritishCompany Director43607410002
    DOYLE, Betty June
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    Amministratore delegato nominato
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    British900003960001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Amministratore delegato nominato
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    FORD, Raymond Harry
    The Old Vicarage 50 Leeds Road
    Oulton
    LS26 8JY Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Old Vicarage 50 Leeds Road
    Oulton
    LS26 8JY Leeds
    West Yorkshire
    BritishManager41520890001
    HOBSON, Glyn
    19 Orchard Croft
    Dodworth
    S75 3QY Barnsley
    South Yorkshire
    Amministratore
    19 Orchard Croft
    Dodworth
    S75 3QY Barnsley
    South Yorkshire
    EnglandBritishManager31389160002
    JONES, Clare Adele
    10 Heddon Place
    Headingley
    LS6 4EL Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    10 Heddon Place
    Headingley
    LS6 4EL Leeds
    West Yorkshire
    BritishSolicitor50145210001
    JONSSON, Ian Kenneth
    15 Cropley Close
    IP32 7EU Bury St Edmunds
    Suffolk
    Amministratore
    15 Cropley Close
    IP32 7EU Bury St Edmunds
    Suffolk
    BritishManager72548060002
    KEWNEY, Peter Edwin
    Drumellan
    KA19 7JG Maybole
    Ayrshire
    Amministratore
    Drumellan
    KA19 7JG Maybole
    Ayrshire
    BritishManager640910002
    KNOWLES, Mark Geoffrey
    Mountain Ash
    Woodmans Close
    BS37 6DH Chipping Sodbury
    S Gloucestershire
    Amministratore
    Mountain Ash
    Woodmans Close
    BS37 6DH Chipping Sodbury
    S Gloucestershire
    EnglandBritishDirector114543880001
    KUBEL, Horst Heinrich, Dipl. Wirtsch-Ing
    Gmuender Weg 11
    89522 Heidenheim
    Baden Wurtenberg
    Germany
    Amministratore
    Gmuender Weg 11
    89522 Heidenheim
    Baden Wurtenberg
    Germany
    GermanDirector83117250001
    LEE, Graham Ivan
    24 Browns Lane
    B79 8TE Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    24 Browns Lane
    B79 8TE Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector47973700001
    LEE, Graham
    Statfold Barn Farm Ashby Road
    B79 0BU Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    Statfold Barn Farm Ashby Road
    B79 0BU Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector1477360001
    MCINNES, Ian
    22 Thornwood Avenue
    Kirkintilloch
    G66 4EL Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    22 Thornwood Avenue
    Kirkintilloch
    G66 4EL Glasgow
    Lanarkshire
    BritishCommercial Director71723590001
    ORTON, George
    27 Water Royd Drive
    Dodworth
    S75 3QX Barnsley
    South Yorkshire
    Amministratore
    27 Water Royd Drive
    Dodworth
    S75 3QX Barnsley
    South Yorkshire
    EnglandBritishManager126226060001
    PRAUS, Alfred Franz
    Siccards Burgasse 4120
    Vienna
    Austria
    A 1100
    Austria
    Amministratore
    Siccards Burgasse 4120
    Vienna
    Austria
    A 1100
    Austria
    AustrianCompany Director67902760001
    RICHARDSON, Keith Martin
    2 Moorside Close
    Mapplewell
    S75 6BQ Barnsley
    South Yorkshire
    Amministratore
    2 Moorside Close
    Mapplewell
    S75 6BQ Barnsley
    South Yorkshire
    BritishManager40387370001

    THE HUNSLET ENGINE COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 28 lug 2000
    Consegnato il 01 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 01 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0