GLOTEL HOLDINGS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | GLOTEL HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02982579 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GLOTEL HOLDINGS LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova GLOTEL HOLDINGS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 10 Bishops Square E1 6EG London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GLOTEL HOLDINGS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| GLOTEL HOLDINGS PLC | 26 mar 1999 | 26 mar 1999 |
| GLOTEL PLC | 19 ott 1994 | 19 ott 1994 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GLOTEL HOLDINGS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per GLOTEL HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 2 pagine | DS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Medeco Developments Limited il 30 set 2020 | 1 pagine | CH02 | ||
Dettagli del segretario cambiati per Medeco Developments Ltd il 30 set 2020 | 1 pagine | CH04 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Millennium Bridge House 2 Lambeth Hill London EC4V 4BG a 10 Bishops Square London E1 6EG in data 30 set 2020 | 1 pagine | AD01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 set 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Yann Serge Stephane Halka il 21 ago 2019 | 2 pagine | CH01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 set 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 21 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Gavin Tagg come segretario in data 20 feb 2019 | 1 pagine | TM02 | ||
Nomina di Ms Rashida Atinuke Akinjobi come segretario in data 20 feb 2019 | 2 pagine | AP03 | ||
Nomina di Mr Gavin Kenneth Tagg come amministratore in data 20 feb 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Yann Serge Stephane Halka come amministratore in data 01 feb 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Robert Marcel Wolff come amministratore in data 01 feb 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di un amministratore | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di John Logan Marshall Iii come amministratore in data 31 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 set 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Marcello Pozzoni come amministratore in data 05 lug 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 21 pagine | AA | ||
Nomina di Ms Alexandra Helen Bishop come amministratore in data 01 apr 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 set 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Notifica di Adecco Group Ag come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 1 pagine | PSC02 | ||
Notifica di Olsten (U.K.) Holdings Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 1 pagine | PSC02 | ||
Nomina di Director Robert Marcel Wolff come amministratore in data 17 lug 2017 | 2 pagine | AP01 | ||
Chi sono gli amministratori di GLOTEL HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKINJOBI, Rashida Atinuke | Segretario | Bishops Square E1 6EG London 10 England | 255582020001 | |||||||||||
| MEDECO DEVELOPMENTS LTD | Segretario | Bishops Square E1 6EG London 10 England |
| 163884460001 | ||||||||||
| BISHOP, Alexandra Helen | Amministratore | Bishops Square E1 6EG London 10 England | United Kingdom | British | 183293230001 | |||||||||
| HALKA, Yann Serge Stephane | Amministratore | Bishops Square E1 6EG London 10 England | United Kingdom | French | 255064770002 | |||||||||
| TAGG, Gavin Kenneth | Amministratore | Bishops Square E1 6EG London 10 England | England | British | 255565180001 | |||||||||
| MEDECO DEVELOPMENTS LIMITED | Amministratore | Bishops Square E1 6EG London 10 England |
| 132749860001 | ||||||||||
| ADKINS, Christopher James | Segretario | Whinthorpe Oxford Road SL9 7DL Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 57087870002 | ||||||||||
| BRIANT, Timothy | Segretario | Chanctonbury Way Finchley N12 7AB London 116 | British | 130048920001 | ||||||||||
| BROOKS, Jonathan | Segretario | 18 Norfolk Road NW8 6HG London | British | 66911470002 | ||||||||||
| CLARK, Leslie Charles | Segretario | Silver Birches Nightingales Lane HP8 4SL Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | 22206230002 | ||||||||||
| HORWOOD, Lindsay | Segretario | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House England | 149814940001 | |||||||||||
| MCCRACKEN, Sara Benita | Segretario | 71 Elstree Way WD6 1WD Borehamwood Adecco House Hertfordshire England | 149189100001 | |||||||||||
| SAFFER, Alan | Segretario | 3 Heathfield Road WD23 2LH Bushey Hertfordshire | British | 72309130002 | ||||||||||
| TAGG, Gavin | Segretario | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House | 202423640001 | |||||||||||
| TAGG, Gavin Kenneth | Segretario | Flat 16, Cheylesmore House Ebury Bridge Road SW1W 8QY London | British | 95825170001 | ||||||||||
| ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 900004530001 | |||||||||||
| ADKINS, Christopher James | Amministratore | Whinthorpe Oxford Road SL9 7DL Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 57087870002 | ||||||||||
| BAKER, Andrew Arthur Edward | Amministratore | 1070 Fisher Lane Winnetka Il 60093 Usa | British | 22206240004 | ||||||||||
| BRIANT, Timothy | Amministratore | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House | United Kingdom | British | 130048920001 | |||||||||
| BRIANT, Timothy | Amministratore | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House England | England | British | 153642170001 | |||||||||
| CLARK, Leslie Charles | Amministratore | Silver Birches Nightingales Lane HP8 4SL Chalfont St Giles Buckinghamshire | United Kingdom | British | 22206230002 | |||||||||
| DARRAUGH, Peter Anthony | Amministratore | 77 Grove Road HP23 5PB Tring Hertfordshire | England | British | 82678530001 | |||||||||
| MARSHALL III, John Logan | Amministratore | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House | England | American | 202761210001 | |||||||||
| MARTIN, Neil Thomas George | Amministratore | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House England | England | British | 126681070003 | |||||||||
| POZZONI, Marcello | Amministratore | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House | United States | Italian | 235799700001 | |||||||||
| SAFFER, Alan | Amministratore | 3 Heathfield Road WD23 2LH Bushey Hertfordshire | England | British | 72309130002 | |||||||||
| SEARLE, Peter William | Amministratore | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House England | England | British | 116102520004 | |||||||||
| WOLFF, Robert Marcel | Amministratore | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House | Netherlands | Dutch | 235798570001 | |||||||||
| ASHCROFT CAMERON NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 900004520001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di GLOTEL HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring Group Limited | 06 apr 2016 | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House England | No | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||||
| Olsten (U.K.) Holdings Limited | 06 apr 2016 | 2 Lambeth Hill EC4V 4BG London Millennium Bridge House England | No | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||||
| Adecco Group Ag | 06 apr 2016 | Bellerivestrasse 8008 Zürich 30 Switzerland | No | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||||
GLOTEL HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 21 feb 2005 Consegnato il 22 feb 2005 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 14 feb 2000 Consegnato il 22 feb 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0