LEE COOPER GROUP LIMITED

LEE COOPER GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLEE COOPER GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02984862
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LEE COOPER GROUP LIMITED?

    • (1824) /

    Dove si trova LEE COOPER GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Gloucester House
    72 London Road
    AL1 1NS St. Albans
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LEE COOPER GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CHIEFCO HOLDINGS PLC14 nov 199414 nov 1994
    DE FACTO 373 LIMITED31 ott 199431 ott 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di LEE COOPER GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al03 mar 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per LEE COOPER GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    18 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 lug 2012

    22 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 lug 2011

    34 pagine4.68

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    10 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 06 lug 2010

    LRESEX

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 06 lug 2010

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da Hamilton House Mabledon Place London WC1H 9BB in data 11 giu 2010

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 6 Snow Hill London Uk EC1A 2AY in data 21 mag 2010

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Stefaan Le Clair come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    9 pagine395

    legacy

    8 pagine395

    Risoluzioni

    Resolutions
    5 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica del Memorandum di Associazione

    RES01

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine287

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio redatto al 03 mar 2007

    16 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di LEE COOPER GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HANN, Indira
    Danecroft
    Oldfield Road
    SL6 1TX Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    Danecroft
    Oldfield Road
    SL6 1TX Maidenhead
    Berkshire
    British118446370001
    BAZANTAY, Emmanuel Patrick Serge
    Rue Roland Douay
    80080 Amiens
    55
    Amiens
    France
    Amministratore
    Rue Roland Douay
    80080 Amiens
    55
    Amiens
    France
    French140033000001
    DUNKLEY, Andrew Albert
    High Street
    Nash
    MK17 0EP Milton Keynes
    20
    Buckinghamshire
    Amministratore
    High Street
    Nash
    MK17 0EP Milton Keynes
    20
    Buckinghamshire
    EnglandBritish134204360001
    BERRY, John Graham
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    Segretario
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    British10711650001
    FARRINGTON, David John
    23 Napoleon Road
    TW1 3EW Twickenham
    Middlesex
    Segretario
    23 Napoleon Road
    TW1 3EW Twickenham
    Middlesex
    British13372050001
    LAUGHTON, Mark Timothy
    Nesfield
    Andertons Lane, Henbury
    SK11 9PB Macclesfield
    Cheshire
    Segretario
    Nesfield
    Andertons Lane, Henbury
    SK11 9PB Macclesfield
    Cheshire
    British121239790001
    LEWIS, Sally Elizabeth
    5 Fellows Road
    NW3 3LR London
    Segretario
    5 Fellows Road
    NW3 3LR London
    British4807180001
    RICHARDS, Alan Jeffrey
    Tiryns Forest Road
    RG40 5QR Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    Tiryns Forest Road
    RG40 5QR Wokingham
    Berkshire
    British1437330001
    WALL, John Robert
    9 Fairlawn Park
    St Leonards Hill
    SL4 4HL Windsor
    Berkshire
    Segretario
    9 Fairlawn Park
    St Leonards Hill
    SL4 4HL Windsor
    Berkshire
    British72368120001
    YOUNG, Mark Osborne
    2 Oyster Quay
    Port Solent
    PO6 4TE Portsmouth
    Hampshire
    Segretario
    2 Oyster Quay
    Port Solent
    PO6 4TE Portsmouth
    Hampshire
    British71930040003
    S & J REGISTRARS LIMITED
    99 Gresham Street
    EC2V 7NG London
    Segretario
    99 Gresham Street
    EC2V 7NG London
    43122090005
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Segretario nominato
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001
    BURNETT, Christopher Thomas
    Moorfield Rombalds Lane
    Ben Rhydding
    LS29 8RT Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Moorfield Rombalds Lane
    Ben Rhydding
    LS29 8RT Ilkley
    West Yorkshire
    British905440001
    DE LALANDE DE L'HERAUDIERE, Bruno Marie Jaques Goudon
    7 Rue A. De Saint-Exupery
    FOREIGN Lyon
    69002
    France
    Amministratore
    7 Rue A. De Saint-Exupery
    FOREIGN Lyon
    69002
    France
    French121807520001
    DE VILMORIN, Philippe-Andre
    16 Boulevard Emile Augier
    FOREIGN 75016 Paris
    France
    Amministratore
    16 Boulevard Emile Augier
    FOREIGN 75016 Paris
    France
    French65336490002
    DEGIOANNI, Thierry Antoine Michel
    10 Rue De Paris
    Orsay
    91400
    France
    Amministratore
    10 Rue De Paris
    Orsay
    91400
    France
    French121806980001
    DJEMMALI, Hosni
    11 Rue Iben Rachiq
    Tunis
    Tunisia
    Amministratore
    11 Rue Iben Rachiq
    Tunis
    Tunisia
    Tunisia41812320001
    DJILANI, Hedi
    2 Bis Rue Du Reservoir
    Tunis
    Tunisia
    Amministratore
    2 Bis Rue Du Reservoir
    Tunis
    Tunisia
    Tunisian41812080001
    DJILANI, Mohamed Hechmi
    2 Bis Rue Du Reservoir
    FOREIGN Tunis
    1008
    Tunisia
    Amministratore
    2 Bis Rue Du Reservoir
    FOREIGN Tunis
    1008
    Tunisia
    Tunisian73518380001
    DUTTON, Philip
    23 Quarry Dene
    LS16 8PA Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    23 Quarry Dene
    LS16 8PA Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish141395280001
    GERETY, James Anthony
    22 Leadale Avenue
    Chingford
    E4 8AT London
    Amministratore
    22 Leadale Avenue
    Chingford
    E4 8AT London
    EnglandBritish35957840001
    HARDY, Christopher Paul Cecil
    Flat 1 30 Bolton Gardens
    SW5 0AQ London
    Amministratore
    Flat 1 30 Bolton Gardens
    SW5 0AQ London
    British59163510001
    HARGREAVES, Jason
    328 The Colonnades
    Albert Dock
    L3 4AB Liverpool
    Amministratore
    328 The Colonnades
    Albert Dock
    L3 4AB Liverpool
    British80102490001
    HARGREAVES, John
    1st Floor, Block C, Houston Palace
    1 Avenue Princess Grace
    Monaco
    Mc 98000
    Amministratore
    1st Floor, Block C, Houston Palace
    1 Avenue Princess Grace
    Monaco
    Mc 98000
    British116048300001
    HICK, Paul Arney
    Millcourt Mill Road
    SL7 1QB Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Millcourt Mill Road
    SL7 1QB Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish47699120005
    JACKSON, William Nicholas
    9 Napier Avenue
    SW6 3PS London
    Amministratore
    9 Napier Avenue
    SW6 3PS London
    British43321760002
    JORDAN KEANE, Miriam
    48 Queens Gate
    SW7 5JN London
    Amministratore
    48 Queens Gate
    SW7 5JN London
    British48402680003
    KHAITAN, Ajay
    Robsart House 10 Abingdon Road
    OX2 9QN Oxford
    Cumnor
    Amministratore
    Robsart House 10 Abingdon Road
    OX2 9QN Oxford
    Cumnor
    United KingdomBritish87678640006
    KING, John
    Crossley House Crossley Park
    New Pale Road
    WA6 6JG Manley
    Cheshire
    Amministratore
    Crossley House Crossley Park
    New Pale Road
    WA6 6JG Manley
    Cheshire
    British81185040003
    LAUGHTON, Mark Timothy
    Nesfield
    Andertons Lane, Henbury
    SK11 9PB Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    Nesfield
    Andertons Lane, Henbury
    SK11 9PB Macclesfield
    Cheshire
    British121239790001
    LE CLAIR, Stefaan A
    A. Vermaelenstraat 4
    Blanden
    3052
    Belgium
    Amministratore
    A. Vermaelenstraat 4
    Blanden
    3052
    Belgium
    Belgian123657490001
    MASON, Paul
    Darwin Bank
    Whiddon Croft, Menston
    LS29 6QQ Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Darwin Bank
    Whiddon Croft, Menston
    LS29 6QQ Ilkley
    West Yorkshire
    British117547810001
    MAUNSELL, Christopher Ernest
    Upton Manor High Street
    Upton
    OX11 9JE Didcot
    Oxfordshire
    Amministratore
    Upton Manor High Street
    Upton
    OX11 9JE Didcot
    Oxfordshire
    EnglandBritish544600001
    MOORES, Robert Patrick
    51 Airedale Avenue
    W4 2NW London
    Amministratore
    51 Airedale Avenue
    W4 2NW London
    British47268200001
    NG, Frederick Tak Wai
    13/F Block L
    141 Prince Edward Road West Kowloon
    FOREIGN Hong Kong
    Amministratore
    13/F Block L
    141 Prince Edward Road West Kowloon
    FOREIGN Hong Kong
    Chinese64183300004

    LEE COOPER GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Creato il 26 ago 2009
    Consegnato il 09 set 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Investec Bank PLC
    Transazioni
    • 09 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of pledge over inventory
    Creato il 26 ago 2009
    Consegnato il 08 set 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the pledgor and any obligor to any of the pledgees under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The entire current and future value of the inventory see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited and Investec Bank PLC
    Transazioni
    • 08 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of variation
    Creato il 12 gen 2007
    Consegnato il 27 gen 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each of the obligors and/or lee cooper suisse sa to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited (The Security Holder)
    Transazioni
    • 27 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Creato il 05 lug 2005
    Consegnato il 20 lug 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited as Security Agent for Ge Factofrance Snc
    Transazioni
    • 20 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Creato il 05 lug 2005
    Consegnato il 20 lug 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited ("the Security Holder")
    Transazioni
    • 20 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Creato il 05 lug 2005
    Consegnato il 15 lug 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transazioni
    • 15 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 04 mag 2005
    Consegnato il 24 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lee Cooper Finance, Inc
    Transazioni
    • 24 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 giu 1996
    Consegnato il 16 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in connection with any of the offer facilities agreement and the refinance credit agreement and any other agreement which is included within the definitions of the financing documents and under the debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 02 dic 1994
    Consegnato il 14 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the secured parties and to the secured parties (as defined) on any account whatsoever under or in connection with any of the transaction documents
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    LEE COOPER GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 lug 2010Inizio della liquidazione
    14 feb 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stephen Hunt
    Griffins
    Tavistock House South
    WC1H 9LG Tavistock Square
    London
    Praticante
    Griffins
    Tavistock House South
    WC1H 9LG Tavistock Square
    London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0