WILLS & CO. FINANCIAL GROUP PLC

WILLS & CO. FINANCIAL GROUP PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWILLS & CO. FINANCIAL GROUP PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 02986413
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WILLS & CO. FINANCIAL GROUP PLC?

    • (7415) /

    Dove si trova WILLS & CO. FINANCIAL GROUP PLC?

    Indirizzo della sede legale
    c/o HARRISONS BUSINESS RECOVERY & INSOLVENCY (LONDON) LIMITED
    4th Floor 25 Shaftesbury Avenue
    W1D 7EQ London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WILLS & CO. FINANCIAL GROUP PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GHW GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY05 mar 200205 mar 2002
    WALL STREET INVESTMENTS PUBLIC LIMITED COMPANY03 nov 199403 nov 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di WILLS & CO. FINANCIAL GROUP PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per WILLS & CO. FINANCIAL GROUP PLC?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per WILLS & CO. FINANCIAL GROUP PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    23 pagine4.72

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:- court order - replacement of liquidator
    5 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Bridge Business Recovery 3Rd Floor 39-45 Shaftesbury Avenue London W1D 6LA* in data 13 ott 2011

    1 pagineAD01

    legacy

    3 pagineLQ01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 4-10 Barttelot Road Horsham West Sussex RH12 1DQ* in data 20 gen 2011

    1 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    7 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Katharine Prichard come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Mrs Sarah Penelope Mcmanus come segretario

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di James Briggs come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di James Briggs come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2008

    34 pagineAA

    legacy

    6 pagine363a

    legacy

    20 pagine363s

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2007

    35 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    Memorandum e Statuto

    14 pagineMEM/ARTS

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed ghw group PUBLIC LIMITED COMPANY\certificate issued on 10/10/07
    2 pagineCERTNM

    legacy

    18 pagine363s

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di WILLS & CO. FINANCIAL GROUP PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCMANUS, Sarah Penelope
    Horsham Road
    GU6 8DY Cranleigh
    124
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Horsham Road
    GU6 8DY Cranleigh
    124
    Surrey
    United Kingdom
    British151853610001
    BRADLEY, Stephen, Doctor
    18 Bracknell Gardens
    Hampstead
    NW3 7EB London
    Amministratore
    18 Bracknell Gardens
    Hampstead
    NW3 7EB London
    British6509400001
    SHAKESHAFT, Peter Robert
    The Mardle
    Wheelers Lane
    RH3 7HJ Brockham
    Surrey
    Amministratore
    The Mardle
    Wheelers Lane
    RH3 7HJ Brockham
    Surrey
    United KingdomBritish12245160006
    BANKS COOPER, Simon Andrew
    Laurel House
    Main Street
    HU16 5TZ Skidby
    Segretario
    Laurel House
    Main Street
    HU16 5TZ Skidby
    British65037730002
    BRIGGS, James Harvey
    Tennyson Close
    RH12 5PN Horsham
    24
    West Sussex
    Segretario
    Tennyson Close
    RH12 5PN Horsham
    24
    West Sussex
    British65091690002
    FENTON, James
    The Warren
    Compton Way Moor Park
    GU10 1QY Farnham
    Surrey
    Segretario
    The Warren
    Compton Way Moor Park
    GU10 1QY Farnham
    Surrey
    British8157910001
    MACDONALD WATSON, Robert Andrew
    85 Elsenham Street
    Southfields
    SW18 5NX London
    Segretario
    85 Elsenham Street
    Southfields
    SW18 5NX London
    British27289930001
    BANKS COOPER, Simon Andrew
    Laurel House
    Main Street
    HU16 5TZ Skidby
    Amministratore
    Laurel House
    Main Street
    HU16 5TZ Skidby
    United KingdomBritish65037730002
    BRIGGS, James Harvey
    Tennyson Close
    RH12 5PN Horsham
    24
    West Sussex
    Amministratore
    Tennyson Close
    RH12 5PN Horsham
    24
    West Sussex
    EnglandBritish65091690002
    COLE, Susan
    43 Station Road
    Nailsea
    BS48 4PD Bristol
    Amministratore
    43 Station Road
    Nailsea
    BS48 4PD Bristol
    United KingdomBritish22886270002
    FENTON, James
    The Warren
    Compton Way Moor Park
    GU10 1QY Farnham
    Surrey
    Amministratore
    The Warren
    Compton Way Moor Park
    GU10 1QY Farnham
    Surrey
    British8157910001
    FRY, Jonathan Peter Hawes
    The Old Rectory
    Hambledon Road, Hambledon
    GU8 4DR Godalming
    Surrey
    Amministratore
    The Old Rectory
    Hambledon Road, Hambledon
    GU8 4DR Godalming
    Surrey
    United KingdomBritish5125830005
    HOLGATE, Robert John
    Hill Farm
    Camelsdale Road
    GU27 3SG Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Hill Farm
    Camelsdale Road
    GU27 3SG Haslemere
    Surrey
    EnglandBritish12245150006
    MASON, Michael Anthony
    5 Wadham Drive
    Frenchay
    BS16 1PF Bristol
    Avon
    Amministratore
    5 Wadham Drive
    Frenchay
    BS16 1PF Bristol
    Avon
    British3937760001
    MIGDALE, Philip Roger
    Meadowlea
    Stream Lane, Nutbourne
    RH20 2HG Pulborough
    West Sussex
    Amministratore
    Meadowlea
    Stream Lane, Nutbourne
    RH20 2HG Pulborough
    West Sussex
    British64658100001
    PRICHARD, Katharine Therese
    90 Feversham Avenue
    Queens Park
    BH8 9NJ Bournemouth
    Amministratore
    90 Feversham Avenue
    Queens Park
    BH8 9NJ Bournemouth
    EnglandBritish85729430006
    SOUTER, Katherine Fiona
    11 Underhill Park Road
    RH2 9LU Reigate
    Surrey
    Amministratore
    11 Underhill Park Road
    RH2 9LU Reigate
    Surrey
    EnglandBritish69797240004
    SOUTER, Katherine Fiona
    Woodside
    71 South Terrace
    RH4 2AF Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Woodside
    71 South Terrace
    RH4 2AF Dorking
    Surrey
    British69797240002
    THURSTON, Peter Leonard
    Great House
    Hambledon
    GU8 4DP Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Great House
    Hambledon
    GU8 4DP Godalming
    Surrey
    EnglandBritish115788090002
    TRUMPER, Zoe Elizabeth
    1 Barn Cottage
    Talbot Lane
    RH12 1ES Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    1 Barn Cottage
    Talbot Lane
    RH12 1ES Horsham
    West Sussex
    British20627130003

    WILLS & CO. FINANCIAL GROUP PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 26 set 2003
    Consegnato il 01 ott 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The sum of £65,738.31 deposited and all monies from time to time deducted therefrom and any additional sum or sums required.
    Persone aventi diritto
    • Lionbrook Nominee (44/48 Bow Lane) No.1 LTD and Lionbrook Nominee (44/48 Bow Lane) No.2 LTD
    Transazioni
    • 01 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 13 ago 2001
    Consegnato il 23 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bailey house barttelot road horsham west sussex title number WSX195867.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 208 lug 2011Nomina di un amministratore o gestore (LQ01)
      • Numero di pratica 2
    Debenture
    Creato il 06 gen 2000
    Consegnato il 11 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture
    Brevi particolari
    First floating charge the securities quoted on the ofex being pit stop PLC 404,000 shares held silicon valley PLC 1,025,240 shares held. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • T D Bailey & Son Limited
    Transazioni
    • 11 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 05 mar 1997
    Consegnato il 12 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    WILLS & CO. FINANCIAL GROUP PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 dic 2010Inizio della liquidazione
    06 ago 2015Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Anthony Murphy
    3rd Floor 39-45 Shaftesbury Avenue
    W1D 6LA London
    Praticante
    3rd Floor 39-45 Shaftesbury Avenue
    W1D 6LA London
    Robert William Leslie Horton
    One Great Cumberland Place
    Marble Arch
    W1H 7LW London
    Praticante
    One Great Cumberland Place
    Marble Arch
    W1H 7LW London
    Paul Robert Boyle
    4th Floor 25 Shaftesbury Avenue
    W1D 7EQ London
    Praticante
    4th Floor 25 Shaftesbury Avenue
    W1D 7EQ London
    2Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robert Edward Stokeley
    3 Lake Court
    Hursley
    SO21 2LD Winchester
    Hampshire
    Ricevitore/gestore
    3 Lake Court
    Hursley
    SO21 2LD Winchester
    Hampshire
    Stephen Skinner
    3 Lake Court
    Hursley
    SO21 2LD Winchester
    Hampshire
    Ricevitore/gestore
    3 Lake Court
    Hursley
    SO21 2LD Winchester
    Hampshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0