RICHMOND NANTWICH LIMITED

RICHMOND NANTWICH LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRICHMOND NANTWICH LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02988901
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di RICHMOND NANTWICH LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova RICHMOND NANTWICH LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Angel Court
    EC2R 7HJ London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RICHMOND NANTWICH LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RICHMOND VILLAGE CARE CENTRE LTD.04 lug 199504 lug 1995
    ROWAN (51) LIMITED10 nov 199410 nov 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di RICHMOND NANTWICH LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per RICHMOND NANTWICH LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al20 giu 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma04 lug 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al20 giu 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per RICHMOND NANTWICH LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Cessazione della carica di Rebecca Pearson come amministratore in data 03 feb 2025

    1 pagineTM01
    XDW7L57N

    Nomina di Mr Thomas Nichol Hoosen-Webber come amministratore in data 03 feb 2025

    2 pagineAP01
    XDW4YAP4

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XD6K45XS

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2023

    4 pagineAA
    AD3QGN88

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022

    5 pagineAA
    ACC2UP23

    Cessazione della carica di Michael Harrison come amministratore in data 31 lug 2023

    1 pagineTM01
    XC94XSZL

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XC6NSQJ4

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Rebecca Pearson il 31 gen 2022

    2 pagineCH01
    XBVWHDU8

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XB710TS0

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    5 pagineAA
    AB5QU2CH

    Nomina di Mrs Rebecca Pearson come amministratore in data 02 lug 2021

    2 pagineAP01
    XA8451G0

    Cessazione della carica di Joan Martina Elliott come amministratore in data 02 lug 2021

    1 pagineTM01
    XA844B2Z

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XA7W809T

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    5 pagineAA
    AA100GXS

    Cessazione della carica di Bupa Secretaries Limited come amministratore in data 18 mar 2021

    1 pagineTM01
    XA0MJM56

    Nomina di Mrs Aileen Waton come amministratore in data 18 mar 2021

    2 pagineAP01
    XA0MJKKA

    Nomina di Mr Neil Stephen Barker come amministratore in data 18 mar 2021

    2 pagineAP01
    XA0MJJRU

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X9BWAVLK

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    5 pagineAA
    A951XTIJ

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2019 con aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X88H8WY2

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    5 pagineAA
    A87SQ09E

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X79GOP9K

    Cessazione della carica di Catherine Elizabeth Barton come amministratore in data 27 apr 2018

    1 pagineTM01
    X79FURM0

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    15 pagineAA
    A75C46OZ

    Nomina di Mr Michael Harrison come amministratore in data 27 apr 2018

    2 pagineAP01
    X750FO4R

    Chi sono gli amministratori di RICHMOND NANTWICH LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione03155937
    162768400001
    BARKER, Neil Stephen
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director159087650001
    HOOSEN-WEBBER, Thomas Nichol
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director249384870003
    WATON, Aileen
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director237290130001
    DUNCAN, David Gregor
    Flat 43 The Piper Building
    Peterborough Road
    SW6 3EF London
    Segretario
    Flat 43 The Piper Building
    Peterborough Road
    SW6 3EF London
    BritishFinance Director97755760001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Segretario
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    BritishCompany Secretary68848420004
    JOHNSON, Katherine Elizabeth
    Manor Farm House
    Lower Westwood
    BA15 2AF Bradford On Avon
    Wiltshire
    Segretario
    Manor Farm House
    Lower Westwood
    BA15 2AF Bradford On Avon
    Wiltshire
    British41038870003
    PORTAL, Ian
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Segretario
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    165003370001
    RICHARDSON, Joanne
    Outwood Lane
    LS18 4UP Leeds
    Bridge House
    Segretario
    Outwood Lane
    LS18 4UP Leeds
    Bridge House
    177621290001
    ROWANSEC LIMITED
    135 Aztec West
    Almondsbury
    BS32 4UB Bristol
    Avon
    Segretario nominato
    135 Aztec West
    Almondsbury
    BS32 4UB Bristol
    Avon
    900006290001
    BARTON, Catherine Elizabeth
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director206964340002
    BOWDEN, Richard Thomas
    Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House 15-19
    United Kingdom
    Amministratore
    Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House 15-19
    United Kingdom
    United KingdomAustralianDirector172827550002
    BRICE, Paddy
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Amministratore
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director117415010002
    CANNON, Andrew John
    Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House 15-19
    United Kingdom
    Amministratore
    Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House 15-19
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector200461360001
    COCKELL, Keith Henry
    Old Mill Farm
    Back Lane Upper Oddington
    GL56 0XL Moreton On Marsh
    Gloucestershire
    Amministratore
    Old Mill Farm
    Back Lane Upper Oddington
    GL56 0XL Moreton On Marsh
    Gloucestershire
    United KingdomBritishDirector162548990001
    DUNCAN, David Gregor
    Flat 43 The Piper Building
    Peterborough Road
    SW6 3EF London
    Amministratore
    Flat 43 The Piper Building
    Peterborough Road
    SW6 3EF London
    United KingdomBritishFinance Director97755760001
    ELLIOTT, Joan Martina
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director 309829120001
    ELLIOTT, Joan Martina
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Amministratore
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    EnglandBritishFinance Director 309829120001
    HARRISON, Michael
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector241166230001
    HYNAM, David Emmanuel
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Amministratore
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    EnglandBritishCompany Director92485410001
    JACKSON, Paul
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Amministratore
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director135682290003
    JOHNSON, James Ronald
    Manor Farm House
    Westwood
    BA15 2AF Bradford On Avon
    Wiltshire
    Amministratore
    Manor Farm House
    Westwood
    BA15 2AF Bradford On Avon
    Wiltshire
    BritishCompany Director34256020003
    MCGARTOLL, Owen Raphael
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Amministratore
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    IrishDirector116537370001
    MOORE, Keith
    Outwood Lane
    Horsforth
    LS18 4UP Leeds
    Bridge House
    Yorkshire
    Uk
    Amministratore
    Outwood Lane
    Horsforth
    LS18 4UP Leeds
    Bridge House
    Yorkshire
    Uk
    United KingdomBritishDirector49217290002
    PARSONS, Michael Dennis
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Amministratore
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector44895330007
    PEARSON, Rebecca
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director245936140002
    PEELER, Andrew Michael
    Outwood Lane
    LS18 4UP Horsforth
    Bridge House
    Leeds
    United Kingdom
    Amministratore
    Outwood Lane
    LS18 4UP Horsforth
    Bridge House
    Leeds
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector87359710001
    PICKEN, Jonathan Stephen
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director189611450001
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione3155937
    162768400001
    ROWAN FORMATIONS LIMITED
    135 Aztec West
    Almondsbury
    BS32 4UB Bristol
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    135 Aztec West
    Almondsbury
    BS32 4UB Bristol
    Avon
    900006280001

    Chi sono le persone con controllo significativo di RICHMOND NANTWICH LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02778957
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    RICHMOND NANTWICH LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 18 ott 2011
    Consegnato il 25 ott 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 25 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 24 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 19 ago 2008
    Consegnato il 04 set 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H land on the south east side of st joseph's way nantwich t/no CH399714 and fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland as Security Trustee
    Transazioni
    • 04 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 04 gen 1999
    Consegnato il 06 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that land and property k/a and described as land on the south east side of st josephs way nantwich cheshire t/n CH399714 with all buildings structures fixtures fixed plant and machinery present and future insurances and goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 06 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattels mortgage
    Creato il 29 giu 1998
    Consegnato il 01 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the chattels as listed in the inventory attached to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 01 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 dic 1994
    Consegnato il 29 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & the Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 29 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0