FUTURESTATE LIMITED

FUTURESTATE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFUTURESTATE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02989969
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FUTURESTATE LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova FUTURESTATE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di FUTURESTATE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per FUTURESTATE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da 40 Queen Anne Street London W1G 9EL a 26-28 Bedford Row London WC1R 4HE in data 21 nov 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Dichiarazione di solvibilità

    pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 25 ott 2019

    LRESSP

    Cessazione della carica di Alexander Wilson Lamont come amministratore in data 26 set 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael George Cohen come amministratore in data 26 set 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jack Anthony Stevens come amministratore in data 26 set 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Jack Anthony Stevens come amministratore in data 10 apr 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di James Anthony Piper come amministratore in data 10 apr 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017

    16 pagineAA

    Cessazione della carica di Colin Barry Wagman come amministratore in data 29 mar 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Notifica di Minerva Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Cessazione di Antares Properties Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    1 paginePSC07

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2016

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    20 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 029899690010 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di FUTURESTATE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GOSWELL, Paul Jonathan
    Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish60475780003
    EZEKIEL, Ivan Howard
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Segretario
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    British56155670004
    KLEINER, Richard Howard
    26 Atwood Avenue
    Kew
    TW9 4HG Richmond
    Surrey
    Segretario
    26 Atwood Avenue
    Kew
    TW9 4HG Richmond
    Surrey
    British29866240002
    ROSENFELD, Andrew Ian
    14 Chemin Vert
    Vandoeuvres
    Ch-1253
    Geneva
    Switzerland
    Segretario
    14 Chemin Vert
    Vandoeuvres
    Ch-1253
    Geneva
    Switzerland
    British118467060001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    COHEN, Michael George
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    England
    Amministratore
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor Lansdowne House
    England
    EnglandBritish153509790001
    COSTER, Paul Antony
    Garth Steading
    Walpole Avenue
    CR5 3PN Chipstead
    Surrey
    Amministratore
    Garth Steading
    Walpole Avenue
    CR5 3PN Chipstead
    Surrey
    British35406400003
    EZEKIEL, Ivan Howard
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    EnglandBritish56155670004
    GARNHAM, Timothy Claude
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    EnglandBritish66502160002
    GARRARD, David Eardley, Sir
    29 Orchard Court
    Portman Square
    W1H 9PA London
    Amministratore
    29 Orchard Court
    Portman Square
    W1H 9PA London
    EnglandBritish76373440001
    HASAN, Salmaan
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    United KingdomBritish106868320001
    LAMONT, Alexander Wilson
    10 New Burlington Street
    W1S 3BE London
    6th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    10 New Burlington Street
    W1S 3BE London
    6th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish158518680001
    MOODY, Edward Robert William
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 2RY London
    42
    United Kingdom
    Great BritainBritish62122950001
    PIPER, James Anthony
    New Burlington Street
    W1S 3BE London
    Ares Management, 10
    England
    Amministratore
    New Burlington Street
    W1S 3BE London
    Ares Management, 10
    England
    EnglandBritish163685440001
    ROSENFELD, Andrew Ian
    14 Chemin Vert
    Vandoeuvres
    Ch-1253
    Geneva
    Switzerland
    Amministratore
    14 Chemin Vert
    Vandoeuvres
    Ch-1253
    Geneva
    Switzerland
    SwitzerlandBritish118467060001
    STEVENS, Jack Anthony
    10 New Burlington Street
    W1S 3BE London
    6th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    10 New Burlington Street
    W1S 3BE London
    6th Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish258333950001
    WAGMAN, Colin Barry
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor, Lansdowne House
    England
    Amministratore
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    6th Floor, Lansdowne House
    England
    EnglandBritish189915990001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore delegato nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Chi sono le persone con controllo significativo di FUTURESTATE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Antares Properties Limited
    Queen Anne Street
    W1G 9EL London
    40
    England
    06 apr 2016
    Queen Anne Street
    W1G 9EL London
    40
    England
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneRegister Of Companies England And Wales
    Numero di registrazione02524789
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Queen Anne Street
    W1G 9EL London
    40
    England
    06 apr 2016
    Queen Anne Street
    W1G 9EL London
    40
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02649607
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    FUTURESTATE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 19 dic 2014
    Consegnato il 24 dic 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsh Nordbank Ag (Security Agent)
    Transazioni
    • 24 dic 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 24 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Third party debenture
    Creato il 13 ott 2009
    Consegnato il 22 ott 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower or the company to the beneficiaires up to a maximum principal sum of £15,000,000 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 22 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 10 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security
    Creato il 21 set 2009
    Consegnato il 27 ott 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £18,000,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The subjects at westerhill road bishopbriggs glasgow and registered in the land register of scotland under title number GLA73563.
    Persone aventi diritto
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 27 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 10 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 09 dic 1998
    Consegnato il 16 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due from the company and larchfield investments limited to the chargee (as agent and trustee for itself and the beneficiaries) and to all or any of the beneficiaries (as defined) under the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Any real property acquired by the company after the date of this deed and all interest in any investment,existing goodwill and uncalled capital any intellectual property and monies standing to credit of any designated account and by way of fixed charge all other property please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank Ag
    Transazioni
    • 16 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 10TH december 1998
    Creato il 08 dic 1998
    Consegnato il 15 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of the company and larchfield investments limited to the chargee as trustee for itself and others under the loan agreement dated 9TH december 1998
    Brevi particolari
    Subjects at westerhill road bishopbriggs glasgow t/no.GLA73563.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank Ag
    Transazioni
    • 15 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignation of rents
    Creato il 08 dic 1998
    Consegnato il 15 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of the company and larchfield investments limited to the chargee as trustee for itself and others under the loan agreement dated 9TH december 1998
    Brevi particolari
    All the right title and interest of the chargor in and to all rents licence fees premiums and other payments receivable under the lease dated 28 and 29 august and 24 september 1990 under t/no.GLA73564.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank Ag
    Transazioni
    • 15 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignation of rents
    Creato il 29 dic 1994
    Consegnato il 30 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 6TH decembver 1994
    Brevi particolari
    The rights and benefits to all rents arising all reg under title no GLA73564. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Westdeutsche Landesbank Girozentrale
    Transazioni
    • 30 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registrastion in scotland
    Creato il 21 dic 1994
    Consegnato il 06 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated the 6TH of december 1994
    Brevi particolari
    The company's interest as tenants under the lease by harper collins publishers limited in favour of antares properties limited dated the 27TH of september and registered in the books of council and session on the 7TH of november both months in 1990 and registered in the land register of scotland under title number gla 73563 relative to the land and buildings k/a the harper collins complex westerhill road bishopbriggs glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Westdeutsche Landesbank Girozentrale
    Transazioni
    • 06 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Account charge
    Creato il 21 dic 1994
    Consegnato il 28 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the loan agreement dated 6TH december 1994 and any security documents
    Brevi particolari
    All its right title and interest in the rent account in the name of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Westdeutsche Landesbank Girozentrale
    Transazioni
    • 28 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 21 dic 1994
    Consegnato il 28 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the agreement dated 6TH december 1994 and any security documents
    Brevi particolari
    Floating charge. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Westdeutsche Landesbank Girozentrale
    Transazioni
    • 28 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    FUTURESTATE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    25 ott 2019Inizio della liquidazione
    07 gen 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Asher Miller
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London
    Praticante
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0