BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED

BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02990953
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Suite 9 The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    South Humberside
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CHARGENOTICE LIMITED16 nov 199416 nov 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Carlton Greener come amministratore in data 11 mar 2013

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Denise Brenda Robinson come amministratore in data 08 mar 2013

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Trevor Martin Sands come amministratore in data 08 mar 2013

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Denise Brenda Robinson come segretario in data 08 mar 2013

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    3 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Origin 4 Origin Way Europarc Grimsby South Humberside DN37 9TZ United Kingdom in data 04 set 2012

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Trevor Martin Sands come amministratore in data 30 apr 2012

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 20 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 mar 2012

    Stato del capitale al 23 mar 2012

    • Capitale: GBP 386,734.5
    SH01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 ott 2011 al 31 dic 2011

    1 pagineAA01

    Nomina di Mrs Denise Brenda Robinson come amministratore in data 30 set 2011

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Neil Richard Carrick come amministratore in data 30 set 2011

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2010

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Enter into facilities agreement 29/11/2010
    RES13

    Conto per una società dormiente redatto al 01 nov 2009

    4 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Fish Dock Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3NW in data 12 mag 2010

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 20 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Carlton Greener il 31 mar 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Neil Richard Carrick il 31 mar 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Denise Brenda Robinson il 31 mar 2010

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 26 ott 2008

    4 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Facilities agreement 31/07/2009
    RES13

    legacy

    1 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FOXFORD, Michael John
    5 Cooper Street
    M2 2FW Manchester
    Greater Manchester
    Segretario
    5 Cooper Street
    M2 2FW Manchester
    Greater Manchester
    British96216260001
    GREENER, Carlton
    3
    Roewood Lane
    SK10 2PQ Macclesfield
    Cheshire
    Segretario
    3
    Roewood Lane
    SK10 2PQ Macclesfield
    Cheshire
    British290436370002
    ROBINSON, Denise Brenda
    The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    Suite 9
    South Humberside
    United Kingdom
    Segretario
    The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    Suite 9
    South Humberside
    United Kingdom
    British112343690001
    ROBSON, Alan James
    14 Mill Place
    DN35 8ND Cleethorpes
    North East Lincolnshire
    Segretario
    14 Mill Place
    DN35 8ND Cleethorpes
    North East Lincolnshire
    British74547040004
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Segretario nominato
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001550001
    BROWNE, Peter
    11 Ravenhill Park Gardens
    BT6 0DH Belfast
    Amministratore
    11 Ravenhill Park Gardens
    BT6 0DH Belfast
    British42230710001
    CARRICK, Neil Richard
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    Amministratore
    Origin Way
    Europarc
    DN37 9TZ Grimsby
    Origin 4
    South Humberside
    United Kingdom
    EnglandBritish166312330001
    GREENER, Carlton
    The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    Suite 9
    South Humberside
    United Kingdom
    Amministratore
    The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    Suite 9
    South Humberside
    United Kingdom
    EnglandBritish290436370002
    JONSSON, Per Anders
    263 Petersham Road
    TW10 7DA Richmond
    Surrey
    Amministratore
    263 Petersham Road
    TW10 7DA Richmond
    Surrey
    EnglandSwedish189569310001
    MEADOWCROFT, Norman Russell
    3 Barley Drive
    Bramhall
    SK7 2QB Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    3 Barley Drive
    Bramhall
    SK7 2QB Stockport
    Cheshire
    British28601500001
    MEDDINGS, David William
    13 Montagu Square
    W1H 1RB London
    Amministratore
    13 Montagu Square
    W1H 1RB London
    British4416070001
    ROBINSON, Denise Brenda
    The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    Suite 9
    South Humberside
    United Kingdom
    Amministratore
    The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    Suite 9
    South Humberside
    United Kingdom
    United KingdomBritish112343690001
    RUSSELL, Richard
    12 Beechfield Drive
    CW10 9QE Middlewich
    Cheshire
    Amministratore
    12 Beechfield Drive
    CW10 9QE Middlewich
    Cheshire
    United KingdomBritish41506100001
    SANDS, Trevor Martin
    The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    Suite 9
    South Humberside
    United Kingdom
    Amministratore
    The Innovation Centre
    Innovation Way Europarc
    DN37 9TT Grimsby
    Suite 9
    South Humberside
    United Kingdom
    United KingdomUnited Kingdom164235220001
    SMALLBONE, Timothy Charles
    22 Crossway
    Didsbury
    M20 6TT Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    22 Crossway
    Didsbury
    M20 6TT Manchester
    Lancashire
    British42089430001
    STEVENSON, James Neil
    Rathlin
    Hallpath
    DG13 0EG Langholm
    Dumfriesshire
    Amministratore
    Rathlin
    Hallpath
    DG13 0EG Langholm
    Dumfriesshire
    ScotlandBritish759350001
    THOMAS, Adrian Peter Harrison
    26 Hartley Road
    WA14 4AY Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    26 Hartley Road
    WA14 4AY Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish26500450003
    TURNHEIM, Stuart
    33 Breeze Mount
    Prestwich
    M25 0AH Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    33 Breeze Mount
    Prestwich
    M25 0AH Manchester
    Lancashire
    British41506080001
    WOOD, Frederick William
    Pleasant House
    Pleasant Place
    LN11 0NA Louth
    Lincolnshire
    Amministratore
    Pleasant House
    Pleasant Place
    LN11 0NA Louth
    Lincolnshire
    United KingdomBritish3783250004
    WOOLLEY, Anthony
    22 Cross Street
    DE22 3FZ Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    22 Cross Street
    DE22 3FZ Derby
    Derbyshire
    British42230670001
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Amministratore delegato nominato
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001540001

    BALLYCLARE SPECIAL PRODUCTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite debenture
    Creato il 26 mar 2009
    Consegnato il 09 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Frederick William Wood, Ronald Briggs Heaton, Paul Arthur Bradbury, Alan Smith and Vincent Rodger Whyte Mccracken as the Trustees of the Cosalt Retirement Plan
    Transazioni
    • 09 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 26 mar 2009
    Consegnato il 04 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (the "Security Trustee")
    Transazioni
    • 04 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage which was presented for registration in northern ireland on 17TH september 1997
    Creato il 12 set 1997
    Consegnato il 25 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that piece or parcel of ground situate on the south side of the road leading from ballyclare to ballynure k/a the ballynure road situate lying and being in le ballyclare in the parish of ballynure and county of antrim. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 06 ott 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 02 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 set 1997
    Consegnato il 17 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2001Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 02 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of permanent health policy
    Creato il 25 ott 1995
    Consegnato il 26 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of assignment the policy (as defined in the assignment). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 26 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of protection plan policy
    Creato il 25 ott 1995
    Consegnato il 26 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of assignment the policy (as defined in the assignment) with sun alliance and london assurance company liited and all money that may become payable under the policy. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 26 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 27 gen 1995
    Consegnato il 10 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 10 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of life policy
    Creato il 27 gen 1995
    Consegnato il 01 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of assignment the policy (as defined in the assignment) and all money that may become payable under the policy subject to re-assignment on redemption.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 gen 1995
    Consegnato il 30 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 gen 1995
    Consegnato il 30 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that piece or parcel of ground situate at 44 ballyclare road ballyclare le ballyclare in the parish of ballyclare and county of antrim and the present or future goodwiull of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0