HALLAMSHIRE MOTOR COMPANY LIMITED

HALLAMSHIRE MOTOR COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHALLAMSHIRE MOTOR COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02992982
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HALLAMSHIRE MOTOR COMPANY LIMITED?

    • Vendita al dettaglio di autovetture nuove (45111) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Manutenzione e riparazione di autoveicoli (45200) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Commercio all'ingrosso di parti e accessori per autoveicoli (45310) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova HALLAMSHIRE MOTOR COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    No 1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HALLAMSHIRE MOTOR COMPANY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BROOMCO (861) LIMITED22 nov 199422 nov 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di HALLAMSHIRE MOTOR COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per HALLAMSHIRE MOTOR COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    7 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 Penman Way, Grove Park Leicester Leicestershire LE19 1st a No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP in data 08 ott 2015

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 set 2015

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Cessazione della carica di Gerard Edward Nieuwenhuys come amministratore in data 07 set 2015

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 10 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 nov 2014

    Stato del capitale al 17 nov 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Cessazione della carica di Laurence Edward William Vaughan come amministratore in data 01 ott 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Geoffrey Page-Morris come amministratore in data 01 ott 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jeremy Richard Mallett come amministratore in data 01 ott 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robert Harold Kurnick come amministratore in data 01 ott 2014

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Adam Collinson come amministratore in data 15 set 2014

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 10 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 nov 2013

    Stato del capitale al 12 nov 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di David Kevin Jones come segretario

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di HALLAMSHIRE MOTOR COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COLLINSON, Adam
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Segretario
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    British136375910001
    COLLINSON, Adam
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish136375910001
    CARPENTER, Mark Gwilym
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Segretario
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    British105829630002
    JONES, David Kevin
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Segretario
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    157722670001
    MORRIS, Mark Christopher
    Curtis House
    LE15 9JG Stoke Dry
    Rutland
    Segretario
    Curtis House
    LE15 9JG Stoke Dry
    Rutland
    British147628740001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001
    CARPENTER, Mark Gwilym
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish105829630002
    KURNICK, Robert Harold
    670 Pleasant
    Birmingham
    Michigan 48009
    Usa
    Amministratore
    670 Pleasant
    Birmingham
    Michigan 48009
    Usa
    United StatesAmerican82981540007
    MALLETT, Jeremy Richard
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish71752820001
    MORRIS, Mark Christopher
    Curtis House
    LE15 9JG Stoke Dry
    Rutland
    Amministratore
    Curtis House
    LE15 9JG Stoke Dry
    Rutland
    EnglandBritish147628740001
    NIEUWENHUYS, Gerard Edward
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish66435290003
    PAGE-MORRIS, Geoffrey Giovanni
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish105444550002
    SYTNER, Franklin Goodman
    The Old Rectory
    Main Street Ridlington
    LE15 9AU Oakham
    Leicestershire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Main Street Ridlington
    LE15 9AU Oakham
    Leicestershire
    British31588420002
    VAUGHAN, Laurence Edward William
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandEnglish40326440010
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003800001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001

    HALLAMSHIRE MOTOR COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge on vehicle stocks
    Creato il 01 mar 2006
    Consegnato il 03 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first floating charge all used motor vehicles,by way of first fixed charge all proceeds of sale, all insurance monies, all debts under the terms of any sale, all the rights title and interest in and the benefit including the right to receive rent hire charges or any other payments of all contracts, the benefit of all guarantee indemnities and securities, all debts under the terms of or in relation to the contracts all rights enforcing the contracts and all guarantee. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fce Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Floating charge over stock
    Creato il 31 dic 1996
    Consegnato il 03 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All stocks of used motor vehicles and all guarantees,warranties thereto and any rights thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 03 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 dic 1996
    Consegnato il 10 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    HALLAMSHIRE MOTOR COMPANY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 set 2015Inizio della liquidazione
    16 nov 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Praticante
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0