WONDER REALISATIONS LIMITED

WONDER REALISATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWONDER REALISATIONS LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02993030
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di WONDER REALISATIONS LIMITED?

    • (1533) /

    Dove si trova WONDER REALISATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Kroll Limited 10 Fleet Place
    London
    EC4M 7RB
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WONDER REALISATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GOLDEN WONDER LIMITED24 ott 199524 ott 1995
    SPINSON22 nov 199422 nov 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di WONDER REALISATIONS LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2004
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 gen 2006
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al27 dic 2003

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per WONDER REALISATIONS LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al22 nov 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma06 dic 2016
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per WONDER REALISATIONS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per WONDER REALISATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ripristino per ordine del tribunale

    5 pagineAC92

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 ott 2010

    5 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    5 pagine4.72

    Cessazione della carica di Snr Denton Secretaries Limited come segretario

    2 pagineTM02

    Dettagli del segretario cambiati per Dws Secretaries Limited il 30 set 2010

    3 pagineCH04

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 lug 2010

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 gen 2010

    7 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 lug 2009

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 gen 2009

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 lug 2008

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 gen 2008

    7 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 lug 2007

    12 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    7 pagine4.68

    Varie

    C/O release of liquidator
    4 pagineMISC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    12 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    13 pagine4.68

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed golden wonder LIMITED\certificate issued on 22/05/07
    2 pagineCERTNM

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    25 pagine2.34B

    legacy

    1 pagine288c

    Certificato modificato di costituzione del comitato dei creditori

    1 pagine2.26B

    Risultato della riunione dei creditori

    30 pagine2.23B

    Chi sono gli amministratori di WONDER REALISATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EL KASAR, Hassan El Bastawisi
    36 Wellington Court
    Wellington Road St Johns Wood
    NW8 London
    Amministratore
    36 Wellington Court
    Wellington Road St Johns Wood
    NW8 London
    EnglandBritishCompany Director25938080002
    JACKSON, Edward
    132 Selhurst Close
    Wimbledon
    SW19 6AZ London
    Amministratore
    132 Selhurst Close
    Wimbledon
    SW19 6AZ London
    BritishChief Executive Officer89486240001
    SAEED, Dirham Abdo
    1 Ferncroft Avenue
    Hampstead
    NW3 7PG London
    Amministratore
    1 Ferncroft Avenue
    Hampstead
    NW3 7PG London
    United KingdomBritishCompany Director83651520001
    BOYD, Stephen Alexander
    Church Lane
    LE15 8EY Edith Weston
    12
    Rutland
    Segretario
    Church Lane
    LE15 8EY Edith Weston
    12
    Rutland
    BritishFinance Director142394800001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Segretario nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Segretario
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    38565160001
    SNR DENTON SECRETARIES LIMITED
    One Fleet Place
    Cliffords Inn
    EC4M 7WS London
    Segretario
    One Fleet Place
    Cliffords Inn
    EC4M 7WS London
    98515470002
    BOOTHMAN, Paul Lister
    Buckley House Thicket Road
    Houghton
    PE17 2BQ Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Buckley House Thicket Road
    Houghton
    PE17 2BQ Huntingdon
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishMarketing45121570003
    BOYD, Stephen Alexander
    Church Lane
    LE15 8EY Edith Weston
    12
    Rutland
    Amministratore
    Church Lane
    LE15 8EY Edith Weston
    12
    Rutland
    EnglandBritishFinance Director142394800001
    COOK, John Alexander Ross
    Bryanston Cottage Bryanston Street
    DT11 7AZ Blandford Forum
    Dorset
    Amministratore
    Bryanston Cottage Bryanston Street
    DT11 7AZ Blandford Forum
    Dorset
    EnglandBritishCompany Director19629530002
    DUFFY, John
    12 Devonshire Road
    West Bridgford
    NG2 6EU Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    12 Devonshire Road
    West Bridgford
    NG2 6EU Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishSupply Chain Director68977480001
    JERVOISE, John Tristram Loveys
    Herriard Park
    RG25 2PL Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    Herriard Park
    RG25 2PL Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritishFund Manager45081600001
    MARSDEN, Geoffrey Edward
    35 Tarnbeck Drive
    L40 2RU Mawdsley
    Lancashire
    Amministratore
    35 Tarnbeck Drive
    L40 2RU Mawdsley
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director24650420002
    MENSFORTH, Stephen
    4 Beech House
    Lucas Court
    CV32 5JL Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    4 Beech House
    Lucas Court
    CV32 5JL Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishFinance Director92841390001
    MONK, Paul John
    Pali Gap
    Pinkneys Green
    SL6 6QE Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Pali Gap
    Pinkneys Green
    SL6 6QE Maidenhead
    Berkshire
    BritishSales Director71562530001
    NICHOLL, Joseph
    6 Poplars Court
    Leicester Road
    LE16 7BU Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    6 Poplars Court
    Leicester Road
    LE16 7BU Market Harborough
    Leicestershire
    BritishPersonnel45121510002
    SHARPE, Clive Richard
    Knighton Rise
    LE2 2RE Leicester
    18
    Leics
    Amministratore
    Knighton Rise
    LE2 2RE Leicester
    18
    Leics
    EnglandBritishChief Executive134995270001
    TAYLOR, Ian Duncan
    Nuthurst
    Pickhurst Road, Chiddingfold
    GU8 4TS Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Nuthurst
    Pickhurst Road, Chiddingfold
    GU8 4TS Godalming
    Surrey
    EnglandUnited KingdomCompany Director66944030001
    THOMPSON, Timothy Bonar Oldaker
    Cole Close
    Witchford
    CB6 2JX Ely Cambridge
    9
    Cambridgeshire
    Uk
    Amministratore
    Cole Close
    Witchford
    CB6 2JX Ely Cambridge
    9
    Cambridgeshire
    Uk
    BritishDirector133205340002
    THOMPSON, Timothy Bonar Oldaker
    Cole Close
    Witchford
    CB6 2JX Ely Cambridge
    9
    Cambridgeshire
    Uk
    Amministratore
    Cole Close
    Witchford
    CB6 2JX Ely Cambridge
    9
    Cambridgeshire
    Uk
    BritishChartered Accountant133205340002
    WARDLE, Malcolm
    6 Wing Road
    Morcott
    LE15 9DZ Rutland
    Leicestershire
    Amministratore
    6 Wing Road
    Morcott
    LE15 9DZ Rutland
    Leicestershire
    BritishManufacturing Controller45121600003
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    WONDER REALISATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 10 giu 2005
    Consegnato il 27 giu 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Longulf Trading (UK) Limited
    Transazioni
    • 27 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 01 dic 2004
    Consegnato il 10 dic 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barclays bank PLC re golden wonder limited business premium account account number 40277843. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 12 feb 2004
    Consegnato il 04 mar 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture dated 29 july 2000 as amended and restated on 11 august 2000 by a composite restatement agreement dated 10 august 2000 (the "debenture") issued by the company
    Creato il 11 ago 2000
    Consegnato il 16 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    In favour of the chargee all money or liabilities due owing or incurred to any secured party by the charging company or any other charging company under the debenture or any other obligor under any finance document in whatsoever manner
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 16 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security accession deed by which the charging company agreed to become bound by the terms of a debenture dated 29 july 2000
    Creato il 29 lug 2000
    Consegnato il 02 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein and each of the other obligors under the debenture and under any finance document to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lehman Commercial Paper Inc. (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 02 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 lug 1996
    Consegnato il 17 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the east and south east sides of barbury road and land and buildings on the south side of cottage beck road scunthorpe t/no HS13229 and all the other properties as detailed in part ii of the schedule attached to the form 395.
    Persone aventi diritto
    • Legal and General Ventures Limited (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 17 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 lug 1996
    Consegnato il 17 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the east and south east sides of barbury road and land and buildings on the south side of cottage beck road scunthorpe t/no HS13229 and all the other properties as detailed in part ii of the schedule attached to the form 395.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 17 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 lug 1996
    Consegnato il 17 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the east and south east sides of banbury road and land and buildings on the south side of cottage beck road scunthorpe t/no HS13229 land at the rear of 2/4 colin road scunthorpe t/no HS245690 land on the west side of colin road scunthorpe t/no HS217417 plot 27 northampton road scunthorpe t/no HS82060 and all the other properties as detailed in part ii of the schedule attached to the form 395.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 17 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 lug 1996
    Consegnato il 17 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company (as defined therein) to the security beneficiaries (as defined therein) on any account whatsoever under the terms of the charge
    Brevi particolari
    The various f/h and l/h properties as listed on the form 395 inclusive of f/h land and buildings on the east and south east sides of barbury road and land and buildings on the south side of cottage beck road, scunthorpe t/no. HS13229 and l/h land and buildings on the east side of colin road, scunthorpe k/a plot 3 colin road t/no. HS13648 together with all buildings fixtures fixed plant and machinery thereon. .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Legal and General Ventures Limited
    Transazioni
    • 17 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment of keyman life policies
    Creato il 18 dic 1995
    Consegnato il 23 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by any group company to the security beneficiaries (as defined) pursuant to the guarantee or otherwise
    Brevi particolari
    The company assigns and agrees to assign with full title guarantee unto the security trustee the policies as detailed and all monies including bonuses accrued as at 18 december 1995 or which may at any time thereafter accrue. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Plcas Security Trustee for the Security Beneficiaries
    Transazioni
    • 23 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 nov 1995
    Consegnato il 25 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company (as defined) to the security beneficiaries (as defined) on any account whatsoever in accordance with the facilities agreement dated 23RD october 1995
    Brevi particolari
    (I) land and buildings at the junction of abbey street and high street market harborough; (ii) land and buildings on the west side of gavin road ditton widnes cheshire; (iii) land on north side of gretton brook road, corby t/nos: LT262715, CH241595 and NN166963. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Legal & General Ventures Limited, as Security Trustee for the Security Beneficiaries
    Transazioni
    • 25 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 nov 1995
    Consegnato il 25 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed
    Brevi particolari
    Land and buildings at the junction of abbey street and high street market harborough t/n LT262715,land and buildings on the west side of gavin road ditton widnes cheshire and other properties please see form 395 for full details see form 395 for full details. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of legal charge
    Creato il 23 ott 1995
    Consegnato il 10 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from golden wonder holdings limited and its subsidiaries (as defined in the mezzanine loan agreement of 23 october 1995) to legal & general ventures limited as security trustee for the security beneficiaries (as defined herein) on any account whatsoever on a full indemnity basis all reasonable costs and expenses properly incurred by the security trustee and/or the security beneficiaries in relation to the deed of legal charge
    Brevi particolari
    With full title guarantee and as a continuing security for the payment of the secured obligations of the company pursuant to the legal charge,the facilities agreement and a composite guarantee and debenture of 23 october 1995 the company charges:-a(i) such part of the physical materials (as defined).(ii) such part of the physical materials not yet in existence but owned or acquired by the company after the date of the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Legal & General Ventures Limited
    Transazioni
    • 10 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 23 ott 1995
    Consegnato il 10 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Legal & General Ventures Limitedthe "Security Trustee"
    Transazioni
    • 10 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 giu 1997Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of legal charge
    Creato il 23 ott 1995
    Consegnato il 01 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as spinson) and/or any group company (as defined) to the chargee as security trustee for the security beneficiaries under the terms of this charge
    Brevi particolari
    Such physical materials (as defined) present and future owned by the company in favour of the security trustee. Fixed charge over all trade marks and applications for trade marks fixed charge over all rights title and interest in and to the intellectual property (as defined) ........... see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 23 ott 1995
    Consegnato il 01 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the deed
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Trustee for the Security Beneficiaries as Defined Therein)("the Security Trustee")
    Transazioni
    • 01 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 giu 1997Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 ott 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 04 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    WONDER REALISATIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 gen 2006Inizio dell'amministrazione
    06 lug 2006Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Charles Peter Holder
    Wellington Plaza 31 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Praticante
    Wellington Plaza 31 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Gary Peter Squires
    Kroll Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    Kroll Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Adrian John Wolstenholme
    Kroll Limited
    134 Edmund Street
    Birmingham
    B3 2es
    Praticante
    Kroll Limited
    134 Edmund Street
    Birmingham
    B3 2es
    2
    DataTipo
    06 lug 2006Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Charles Peter Holder
    Kroll Limited
    134 Edmond Street
    B3 2ES Birmingham
    Praticante
    Kroll Limited
    134 Edmond Street
    B3 2ES Birmingham
    Adrian John Wolstenholme
    Kroll Limited
    134 Edmund Street
    Birmingham
    B3 2es
    Praticante
    Kroll Limited
    134 Edmund Street
    Birmingham
    B3 2es
    Gary Peter Squires
    Kroll Limited
    134 Edmund Street
    B3 2ES Birmingham
    Praticante
    Kroll Limited
    134 Edmund Street
    B3 2ES Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0