WAVE (NO.3) LIMITED

WAVE (NO.3) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWAVE (NO.3) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02995522
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WAVE (NO.3) LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova WAVE (NO.3) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    KPMG LLP
    15 Canada Square Canary Wharf
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WAVE (NO.3) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NATIONAL AMERICAS HOLDINGS LIMITED29 mar 199529 mar 1995
    RICKTHORNE LIMITED28 nov 199428 nov 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di WAVE (NO.3) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per WAVE (NO.3) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per WAVE (NO.3) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da 88 Wood Street London EC2V 7QQ a 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL in data 09 lug 2015

    2 pagineAD01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed national americas holdings LIMITED\certificate issued on 07/07/15
    3 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 16 giu 2015

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 16 giu 2015

    LRESSP

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 08 giu 2015

    • Capitale: GBP 10,000
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 feb 2015

    Stato del capitale al 02 feb 2015

    • Capitale: GBP 300,000,000
    SH01

    Bilancio redatto al 30 set 2013

    23 pagineAA

    Cessazione della carica di James Duffy come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Andrew Joseph Yates come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Rolfe Alan Cameron Lakin come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christopher Burgess come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 feb 2014

    Stato del capitale al 03 feb 2014

    • Capitale: GBP 300,000,000
    SH01

    Cessazione della carica di Raymond Catt come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 20 set 2013

    • Capitale: GBP 300,000,000
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Chi sono gli amministratori di WAVE (NO.3) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LEWIS, Bernadette
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Segretario
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    BritishDeputy Uk Company Secretary71993580001
    LAKIN, Rolfe Alan Cameron
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Amministratore
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritishBanker149992660001
    YATES, Andrew Joseph
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Amministratore
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritishBanker120080410001
    COPELAND, James Fergus
    Rondane
    Shepley End Sunningdale
    SL5 0LQ Ascot
    Berkshire
    Segretario
    Rondane
    Shepley End Sunningdale
    SL5 0LQ Ascot
    Berkshire
    British67181580001
    DANGELO, Nuncio Enrico
    48 Turnberry Road
    G11 5AP Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    48 Turnberry Road
    G11 5AP Glasgow
    Lanarkshire
    Australian63997220001
    JONES, Anita Elizabeth
    59 Gloucester Street
    SW1V 4DZ London
    Segretario
    59 Gloucester Street
    SW1V 4DZ London
    British66776600001
    LEUNG, Keith Jonathan
    Flat 4 9 Linden Gardens
    W2 4HD London
    Segretario
    Flat 4 9 Linden Gardens
    W2 4HD London
    AustralianSolicitor71291750001
    MCALL, Barbara Anne
    10 Carriers Way
    Carlton
    MK43 7LN Bedford
    Bedfordshire
    Segretario
    10 Carriers Way
    Carlton
    MK43 7LN Bedford
    Bedfordshire
    BritishCompany Secretary147969860019
    MONKS, Phillip Michael
    40 Fairmile Lane
    KT11 2DQ Cobham
    Surrey
    Segretario
    40 Fairmile Lane
    KT11 2DQ Cobham
    Surrey
    BritishSolicitor53540210001
    O'CONNOR, Claudine Elaine
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Segretario
    Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    British50295880003
    SPEAK, Richard Gibson
    Flat 4 Sapphire Court
    E1 8JQ London
    Segretario
    Flat 4 Sapphire Court
    E1 8JQ London
    British100838580001
    WYNNE, Judith
    10 Hyndland Road
    G12 9UP Glasgow
    Segretario
    10 Hyndland Road
    G12 9UP Glasgow
    British67134920001
    CMH SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Segretario nominato
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000940001
    BARNES, Glenn Lawrence Lord
    Newstead Montrose Terrace
    PA11 3DD Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Amministratore
    Newstead Montrose Terrace
    PA11 3DD Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    AustralianBanker76495430002
    BURGESS, Christopher Jonathan Lloyd
    88 Wood Street
    London
    EC2V 7QQ
    Amministratore
    88 Wood Street
    London
    EC2V 7QQ
    United KingdomBritishBanker106441400001
    CAMERON, Robert Patrick
    30 Arlow Road
    Winchmore Hill
    N21 3JU London
    Amministratore
    30 Arlow Road
    Winchmore Hill
    N21 3JU London
    EnglandBritishBanker78319270001
    CATT, Raymond Michael
    88 Wood Street
    London
    EC2V 7QQ
    Amministratore
    88 Wood Street
    London
    EC2V 7QQ
    United KingdomBritishBanker106441560001
    CULLEN, Geoffrey Gilbert
    37 Lockwood Road
    Scarsdale 10583
    FOREIGN New York U S A
    Amministratore
    37 Lockwood Road
    Scarsdale 10583
    FOREIGN New York U S A
    AustrailianBanker55073590002
    DAWSON, John Kelvin
    26 Holland Street
    W8 4LT London
    Amministratore
    26 Holland Street
    W8 4LT London
    AustralianBanker36431870001
    DEVONPORT, David Grant
    48 Eaglesham Road
    Newton Mearns
    G77 5BU Glasgow
    Amministratore
    48 Eaglesham Road
    Newton Mearns
    G77 5BU Glasgow
    BritishAccountant58951550001
    DUFFY, James Anthony
    88 Wood Street
    London
    EC2V 7QQ
    Amministratore
    88 Wood Street
    London
    EC2V 7QQ
    EnglandBritishBanker101191490001
    FRANKENBURG, Alan
    2/131 Robinson Road
    Hawthorn
    Victoria
    Australia
    Amministratore
    2/131 Robinson Road
    Hawthorn
    Victoria
    Australia
    AustralianBanker43514490001
    GALAZKA, George Henry
    32 Seychelle Court
    Foxgrove Road
    BR3 2XU Beckenham
    Kent
    Amministratore
    32 Seychelle Court
    Foxgrove Road
    BR3 2XU Beckenham
    Kent
    BritishManager9029340001
    LEAROYD, Simon Martin
    c/o Uk Company Secretariat
    Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    33
    England
    Amministratore
    c/o Uk Company Secretariat
    Gracechurch Street
    EC3V 0BT London
    33
    England
    United KingdomBritishBank Manager108008770001
    MCCRACKEN, Raymond Peter
    37 Lockwood Road
    Scarsdale New York
    10583 Usa
    Amministratore
    37 Lockwood Road
    Scarsdale New York
    10583 Usa
    AustralianBanker43642750001
    PINNEY, Ross Edward
    32 Odenwald Road
    Eaglemont
    Victoria 30804
    Australia
    Amministratore
    32 Odenwald Road
    Eaglemont
    Victoria 30804
    Australia
    AustralianBanker62982000001
    PRICE, Donald
    20 Victoria Road
    BT18 9BG Holywood
    County Down
    Amministratore
    20 Victoria Road
    BT18 9BG Holywood
    County Down
    BritishBank Ceo58096440003
    PROWSE, Robert Malcolm Charles
    244 Kooyong Road
    Toorak
    Victoria 3142
    Australia
    Amministratore
    244 Kooyong Road
    Toorak
    Victoria 3142
    Australia
    AustralianBanker47081860002
    RICHARDS, David John
    10 Noel Road
    Angel
    N1 8HA London
    Amministratore
    10 Noel Road
    Angel
    N1 8HA London
    BritishManager79930110002
    SAVAGE, Grahame Peter
    Highfield House
    Sawley
    HG4 3EN Ripon
    North Yorkshire
    Amministratore
    Highfield House
    Sawley
    HG4 3EN Ripon
    North Yorkshire
    United KingdomBritishBanker124612410001
    CMH DIRECTORS LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Amministratore delegato nominato
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000930001
    CMH SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Amministratore delegato nominato
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000940001

    WAVE (NO.3) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over account
    Creato il 26 apr 2004
    Consegnato il 30 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The chargor with full title guarantee and as continuing security of the secured obligations charges in favour of the chargee its right, title and interest in the charges assounts.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse First Boston (Europe) Limited
    Transazioni
    • 30 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over shares
    Creato il 26 apr 2004
    Consegnato il 30 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The chargor by way of first fixed charge and as continuing security for the payment and discharge of the secured obligations , all its right, title, interest and benefit to the charged shares, dividends and distributions, rights, shares, money or other assets, allotments, offers and rights and other rights and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse First Boston (Europe) Limited
    Transazioni
    • 30 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    WAVE (NO.3) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 giu 2015Inizio della liquidazione
    04 apr 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Gerard Anthony Friar
    Kpmg Llp
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow
    Praticante
    Kpmg Llp
    191 West George Street
    G2 2LJ Glasgow
    Blair Carnegie Nimmo
    Saltire Court, 20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Praticante
    Saltire Court, 20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0