PERSONAL INJURY MEDICAL SERVICES LIMITED

PERSONAL INJURY MEDICAL SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPERSONAL INJURY MEDICAL SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03000625
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PERSONAL INJURY MEDICAL SERVICES LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova PERSONAL INJURY MEDICAL SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4th Floor Park Gate
    161-163 Preston Road
    BN1 6AF Brighton
    East Sussex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di PERSONAL INJURY MEDICAL SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2023

    Quali sono le ultime deposizioni per PERSONAL INJURY MEDICAL SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 mar 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Premier Medical Holdings Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2023

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 mar 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2022

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 mar 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2021

    3 pagineAA

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2020

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 mar 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Oval (1673) Limited come persona con controllo significativo il 23 feb 2021

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019

    3 pagineAA

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2018

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 030006250011 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2017

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Notifica di Oval (1673) Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Cessazione di Premier Medical Holdings Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    1 paginePSC07

    Cessazione della carica di Robert Colin Goodall come amministratore in data 05 set 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Henry Otto Brunjes come amministratore in data 05 set 2017

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di PERSONAL INJURY MEDICAL SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WARNER, John Douglas
    Park Gate
    161-163 Preston Road
    BN1 6AF Brighton
    4th Floor
    East Sussex
    Amministratore
    Park Gate
    161-163 Preston Road
    BN1 6AF Brighton
    4th Floor
    East Sussex
    EnglandBritishChartered Accountant237751510001
    ELLISON, Jeremy Simon
    23 Aldbourne Road
    Burnham
    SL1 7NJ Slough
    Buckinghamshire
    Segretario
    23 Aldbourne Road
    Burnham
    SL1 7NJ Slough
    Buckinghamshire
    BritishDirector60049170002
    MACLACHLAN, Alexander Edward
    The Old Rectory
    Tidmarsh
    RG8 8ER Reading
    Berkshire
    Segretario
    The Old Rectory
    Tidmarsh
    RG8 8ER Reading
    Berkshire
    BritishCompany Secretary2613010001
    CAPITA GROUP SECRETARY LIMITED
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    England
    Segretario
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2376959
    135207160001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BEDFORD, Nicolas Norman
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector147404780001
    BRUNJES, Henry Otto, Dr
    Park Gate
    161-163 Preston Road
    BN1 6AF Brighton
    4th Floor
    East Sussex
    England
    Amministratore
    Park Gate
    161-163 Preston Road
    BN1 6AF Brighton
    4th Floor
    East Sussex
    England
    EnglandBritishDoctor57560600003
    ELLISON, Jeremy Simon
    23 Aldbourne Road
    Burnham
    SL1 7NJ Slough
    Buckinghamshire
    Amministratore
    23 Aldbourne Road
    Burnham
    SL1 7NJ Slough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector60049170002
    FRANKLIN, Peter Mark
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector179089060001
    GOODALL, Robert Colin, Dr
    Park Gate
    161-163 Preston Road
    BN1 6AF Brighton
    4th Floor
    East Sussex
    Amministratore
    Park Gate
    161-163 Preston Road
    BN1 6AF Brighton
    4th Floor
    East Sussex
    United KingdomBritishDoctor204383930001
    HEALEY, Andrew Mark
    Lawn Crescent
    TW9 3NS Richmond
    37
    Surrey
    Amministratore
    Lawn Crescent
    TW9 3NS Richmond
    37
    Surrey
    United KingdomBritishDirector77351950001
    MACLACHLAN, Alexander Edward
    The Old Rectory
    Tidmarsh
    RG8 8ER Reading
    Berkshire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Tidmarsh
    RG8 8ER Reading
    Berkshire
    EnglandBritishDirector2613010001
    MACLACHLAN, Madeleine Paulette
    The Old Rectory
    Tidmarsh
    RG8 8ER Reading
    Berkshire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Tidmarsh
    RG8 8ER Reading
    Berkshire
    EnglandBritishBarrister54714780001
    PACKE, Maxwell Gordon
    Jessamies Barn
    Eastleach
    GL7 3NG Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    Jessamies Barn
    Eastleach
    GL7 3NG Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritishCompany Director47686490006
    SANDERSON, Martin
    5 St James Close
    Pangbourne
    RG8 7AP Reading
    Berkshire
    Amministratore
    5 St James Close
    Pangbourne
    RG8 7AP Reading
    Berkshire
    United KingdomBritishInternational Purchasing Agent41284820004
    SHEARER, Richard John
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    England
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant132651920002
    SINGH, Davinder
    216 Kingshill Road
    SN1 4NG Swindon
    Amministratore
    216 Kingshill Road
    SN1 4NG Swindon
    EnglandBritishDirector47964180002
    STIRRUP, Mark Christopher
    Park Gate
    161-163 Preston Road
    BN1 6AF Brighton
    4th Floor
    East Sussex
    Amministratore
    Park Gate
    161-163 Preston Road
    BN1 6AF Brighton
    4th Floor
    East Sussex
    EnglandBritishManaging Director204383880001
    VINCENT, James D'Arcy
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector115136550001
    CAPITA CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    England
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione5641516
    129795770003

    Chi sono le persone con controllo significativo di PERSONAL INJURY MEDICAL SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Premier Medical Holdings Limited
    161-163 Preston Road
    BN1 6AF Brighton
    4th Floor, Park Gate
    England
    06 apr 2016
    161-163 Preston Road
    BN1 6AF Brighton
    4th Floor, Park Gate
    England
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione09941789
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Premier Medical Holdings Limited
    161-163 Preston Road
    BN1 6AF Brighton
    4th Floor, Park Gate
    England
    06 apr 2016
    161-163 Preston Road
    BN1 6AF Brighton
    4th Floor, Park Gate
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione04302314
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    PERSONAL INJURY MEDICAL SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 19 gen 2016
    Consegnato il 26 gen 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Capita Health Holdings Limited
    Transazioni
    • 26 gen 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 set 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee and fixed and floating charge
    Creato il 10 lug 2008
    Consegnato il 16 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of intellectual property (including software)
    Creato il 23 apr 2002
    Consegnato il 25 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 dic 2001
    Consegnato il 03 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • John Hnilica, Dr Olga Genbacev-Krtolica and Miles Stott
    Transazioni
    • 03 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 dic 2001
    Consegnato il 02 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Investments PLC for Itself and as Trustee for the Investors (As Defined)
    Transazioni
    • 02 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 dic 2001
    Consegnato il 22 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge on all debts and related rights and floating charge on all other property
    Creato il 13 nov 2000
    Consegnato il 16 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the factoring agreement dated the 25 september 2000
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all (a) specified debts being any book debts the ownership of which shall fail to vest absolutely and effectively in the security holder for any reason together with the related rights (b) all other debts being all amounts of indebtedness now or at any time hereafter owing or becoming due to the company on any account whatsoever; by way of floating charge the undertaking and all the property rights and assets of the company including stock in trade and uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • First National Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 16 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 20 nov 1998
    Consegnato il 03 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nmb-Heller Limited
    Transazioni
    • 03 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 mag 1996
    Consegnato il 18 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a confidential invoice discount agreement of even date
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Guinness Mahon & Co. LIMITED01
    Transazioni
    • 18 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 07 nov 1995
    Consegnato il 13 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 11 mag 1995
    Consegnato il 13 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a factoring agreement leasing agreement or otherwise on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Trade Indemnity-Heller Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 13 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0