RIDGMONT CARE HOMES (SOUTH) LIMITED

RIDGMONT CARE HOMES (SOUTH) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRIDGMONT CARE HOMES (SOUTH) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03003291
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RIDGMONT CARE HOMES (SOUTH) LIMITED?

    • (7499) /
    • (9999) /

    Dove si trova RIDGMONT CARE HOMES (SOUTH) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    No 1 Dorset Street
    Southampton
    SO15 2DP
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RIDGMONT CARE HOMES (SOUTH) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HIGHCARE GROUP LIMITED14 dic 199414 dic 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di RIDGMONT CARE HOMES (SOUTH) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2005

    Quali sono le ultime deposizioni per RIDGMONT CARE HOMES (SOUTH) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 dic 2010

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 giu 2010

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 dic 2009

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 giu 2009

    5 pagine4.68

    legacy

    1 pagine288c

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 dic 2008

    5 pagine4.68

    legacy

    1 pagine287

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    9 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 mag 2005

    17 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    Chi sono gli amministratori di RIDGMONT CARE HOMES (SOUTH) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LUCK, Richard Nigel
    North Street
    Winkfield
    SL4 4TE Windsor
    The Mouse House
    Berks
    Segretario
    North Street
    Winkfield
    SL4 4TE Windsor
    The Mouse House
    Berks
    British61070930002
    KING, Christopher
    53 Kings Road
    TW10 6EG Richmond
    Surrey
    Amministratore
    53 Kings Road
    TW10 6EG Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish77423330002
    ELLIOT, Colin David
    17 St Anns Terrace
    NW8 6PH London
    Segretario
    17 St Anns Terrace
    NW8 6PH London
    British104177230001
    GIDDINGS, Barry Stephen
    2 Hunters Close
    Chartridge Lane
    HP5 2RJ Chesham
    Buckinghamshire
    Segretario
    2 Hunters Close
    Chartridge Lane
    HP5 2RJ Chesham
    Buckinghamshire
    British36687570001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1, 3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Segretario
    Flat 1, 3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British96974070001
    MISTRY, Yogeshkumar Kanchanlal
    38 Fairford Avenue
    LU2 7ER Luton
    Bedfordshire
    Segretario
    38 Fairford Avenue
    LU2 7ER Luton
    Bedfordshire
    British73852970001
    STOREY, John
    93 Dacre Park
    Blackheath
    SE13 5BX London
    Segretario
    93 Dacre Park
    Blackheath
    SE13 5BX London
    British60123860002
    KEY LEGAL SERVICES (SECRETARIAL) LIMITED
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    Segretario nominato
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    900004240001
    ELLIOT, Colin David
    54 Queens Grove
    NW8 6EN London
    Amministratore
    54 Queens Grove
    NW8 6EN London
    British84492240002
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Amministratore
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    American100530310001
    GIDDINGS, Barry Stephen
    2 Hunters Close
    Chartridge Lane
    HP5 2RJ Chesham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    2 Hunters Close
    Chartridge Lane
    HP5 2RJ Chesham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish36687570001
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    Amministratore
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    British66801660002
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    Amministratore
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporean101200680001
    MUIR, Alan Morton, Doctor
    Hunters Ride
    RG20 7AX West Ilsley
    Berkshire
    Amministratore
    Hunters Ride
    RG20 7AX West Ilsley
    Berkshire
    British105360740001
    SAVAGE, Andrew
    Lindisfarne The Cloisters
    Wadworth Hall Lane Wadworth
    DN11 9BH Doncaster
    Amministratore
    Lindisfarne The Cloisters
    Wadworth Hall Lane Wadworth
    DN11 9BH Doncaster
    EnglandBritish117869550001
    STOREY, John
    93 Dacre Park
    Blackheath
    SE13 5BX London
    Amministratore
    93 Dacre Park
    Blackheath
    SE13 5BX London
    British60123860002
    STOREY, Roger Christopher
    11 Newlands
    SG6 2JE Letchworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    11 Newlands
    SG6 2JE Letchworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish1663050001
    WHITEHEAD, Ronald James
    8 The Grazings
    HP2 5JN Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    8 The Grazings
    HP2 5JN Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    EnglandBritish7505760001
    KEY LEGAL SERVICES (NOMINEES) LIMITED
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    Amministratore delegato nominato
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    900004230001
    KEY LEGAL SERVICES (SECRETARIAL) LIMITED
    76 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    Amministratore
    76 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    94774980001

    RIDGMONT CARE HOMES (SOUTH) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    General mortgage debenture
    Creato il 25 ago 2004
    Consegnato il 07 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a drummuir 9-11 northfield bridgwater somerset t/no ST201599, f/h property k/a mountwood nursing homes 11 & 11A millway road andover hampshire t/no HP347382, f/h property k/a hazelhurst 23 kings road horsham west sussex t/no WSX184054 (for further details of mortgaged properties please see schedule to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 07 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 25 ago 2004
    Consegnato il 07 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a drummuir 9-11 northfield bridgwater somerset t/no ST201599, f/h property k/a mountwood nursing homes 11 & 11A millway road andover hampshire t/no HP347382, f/h property k/a hazelhurst 23 kings road horsham west sussex t/no WSX184054 (for further details of mortgaged properties please see schedule to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 07 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over cash deposit
    Creato il 22 mag 2002
    Consegnato il 07 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge its rights title interest and benefit in the cash deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transazioni
    • 07 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    General mortgage debenture
    Creato il 22 mag 2002
    Consegnato il 25 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank S.A./Nv
    Transazioni
    • 25 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 22 mag 2002
    Consegnato il 25 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Various properties as specified on form 395 relative to the charge headed by freehold property known as drummuir 9-11 northfield bridgwater somerset TA6 7EZ title number ST201599 freehold property known as mountwood nursing home 11 & 11A millway road andover hampshire SP10 3EU title number SP347382. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank S.a/Nv
    Transazioni
    • 25 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 30 apr 2002
    Consegnato il 09 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the trustee and the noteholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Drummuir, 9-11 northfield, bridgwater, somerset, TA6 7EZ. Mountwood nursing home, 11 millway road, andover, hampshire, SP10 3EU. Hazelhurst, 23 kings road, horsham, west sussex, RH16 5PP. (For further property charged refer to 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Graphite Capital Management Limited
    Transazioni
    • 09 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 giu 1998
    Consegnato il 06 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as fairfield manor & fairfield court fairfield road broadstairs kent. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 giu 1997
    Consegnato il 07 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a la div nursing home leadon court thornhill cwmbran torfaen wales t/no: WA337792. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 03 giu 1997
    Consegnato il 13 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a davidson house cerne abbas dorset.t/no.DT192565. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 01 apr 1997
    Consegnato il 04 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a highfield nursing home bekesbourne lane bekesbourne canterbury kent t/n's K553893, K167051 and K705018 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 set 1996
    Consegnato il 14 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a hazelhurst 23 kings road horsham west sussex t/no;-WSX184054 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 set 1996
    Consegnato il 14 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a birchwood grove 64 and 66 sydney road haywards heath west sussex t/no;- WSX111308 and WSX111304 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 01 dic 1995
    Consegnato il 13 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a drummuir nursing home 9-11 northfield bridgwater somerset and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 01 dic 1995
    Consegnato il 13 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a st margarets nursing home 36 northfield bridgwater somerset and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 gen 1995
    Consegnato il 03 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a mountwood nursing home 11 & 11A millway road andover hampshire t/n HP347382 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 24 gen 1995
    Consegnato il 27 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    RIDGMONT CARE HOMES (SOUTH) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    07 dic 2007Inizio della liquidazione
    08 giu 2011Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Daniel Robert Whiteley Smith
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Praticante
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Andrew David Conquest
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London
    Praticante
    Grant Thornton House
    Melton Street
    NW1 2EP Euston Square
    London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0