MICROTRAIN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMICROTRAIN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03004209
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MICROTRAIN LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MICROTRAIN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 1 Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MICROTRAIN LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MILLER TECHNICAL LTD18 gen 199518 gen 1995
    TELEC RETAIL SYSTEMS LIMITED21 dic 199421 dic 1994

    Quali sono gli ultimi bilanci di MICROTRAIN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per MICROTRAIN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Nomina di Victoria Anne Chandler come segretario in data 17 ago 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Richard Meirion Warwick-Saunders come segretario in data 05 ago 2016

    1 pagineTM02

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 set 2015 al 29 set 2015

    3 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 21 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 dic 2015

    Stato del capitale al 24 dic 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Cessazione della carica di Alan Stanley Wright come amministratore in data 27 nov 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Mel David Taylor come amministratore in data 27 nov 2015

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2014

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Alan Stanley Wright come amministratore in data 17 giu 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Thierry Georges Bouzac come amministratore in data 01 giu 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 21 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 dic 2014

    Stato del capitale al 23 dic 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Nomina di Mr Oliver Carl Archer come amministratore in data 26 nov 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Keith Christopher Gibbon come amministratore in data 14 nov 2014

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2013

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Thierry Georges Bouzac come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Fiona Timothy come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 21 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 dic 2013

    Stato del capitale al 24 dic 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2012

    7 pagineAA

    Nomina di Mr David Keith Christopher Gibbon come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Fiona Tee come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 21 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    15 pagineMG01

    Chi sono gli amministratori di MICROTRAIN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CHANDLER, Victoria Anne
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    Segretario
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    212446510001
    ARCHER, Oliver Carl
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    Amministratore
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    EnglandBritish150218430001
    TAYLOR, Mel David
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    Amministratore
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    EnglandEnglish203242420001
    ARNOLD, Richard Stewart
    York Road
    SP2 7AT Salisbury
    33
    Wiltshire
    Segretario
    York Road
    SP2 7AT Salisbury
    33
    Wiltshire
    British60617500003
    MCDERMOTT, Thomas Paul
    Newitt Place
    SO16 7FA Southampton
    33
    Hampshire
    Segretario
    Newitt Place
    SO16 7FA Southampton
    33
    Hampshire
    British134045580002
    MILLER, Patricia Elaine
    The Rise
    Allens Lane, Marchington
    ST14 8LA Uttoxeter
    Staffordshire
    Segretario
    The Rise
    Allens Lane, Marchington
    ST14 8LA Uttoxeter
    Staffordshire
    British41688520004
    MITCHELL, Christopher John
    53 Stoke Lane
    Westbury On Trym
    BS9 3DW Bristol
    Segretario
    53 Stoke Lane
    Westbury On Trym
    BS9 3DW Bristol
    British19750010001
    SADLER, Stephen
    Hatch Warren Lane
    Hatch Warren
    RG22 4RA Basingstoke
    Paterson House Hatch Warren Farm
    Hampshire
    Segretario
    Hatch Warren Lane
    Hatch Warren
    RG22 4RA Basingstoke
    Paterson House Hatch Warren Farm
    Hampshire
    158481390001
    SCOTT, Stephen John
    52 Mucklow Hill
    Halesowen
    B62 8BL Birmingham
    Segretario nominato
    52 Mucklow Hill
    Halesowen
    B62 8BL Birmingham
    British900002270001
    WARWICK-SAUNDERS, Richard Meirion
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    United Kingdom
    165681690001
    ASPLIN, Robert Alexander
    Hatch Warren Lane
    Hatch Warren
    RG22 4RA Basingstoke
    Paterson House Hatch Warren Farm
    Hampshire
    Amministratore
    Hatch Warren Lane
    Hatch Warren
    RG22 4RA Basingstoke
    Paterson House Hatch Warren Farm
    Hampshire
    UkBritish149870270001
    BOUZAC, Thierry Georges
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    Amministratore
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    EnglandFrench87674390003
    CHANDLER, Colin, Sir
    Hatch Warren Lane
    Hatch Warren
    RG22 4RA Basingstoke
    Paterson House Hatch Warren Farm
    Hampshire
    Amministratore
    Hatch Warren Lane
    Hatch Warren
    RG22 4RA Basingstoke
    Paterson House Hatch Warren Farm
    Hampshire
    EnglandBritish164519170001
    GIBBON, David Keith Christopher
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish49959390002
    MILLER, Andrew Douglas
    4 New Row
    Main Street, Tatenhill
    DE13 9SG Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    4 New Row
    Main Street, Tatenhill
    DE13 9SG Burton On Trent
    Staffordshire
    British41688500004
    SADLER, Stephen Paul
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish90689640003
    SCOTT, Jacqueline
    52 Mucklow Hill
    Halesowen
    B62 8BL Birmingham
    Amministratore delegato nominato
    52 Mucklow Hill
    Halesowen
    B62 8BL Birmingham
    British900002260001
    SMITH, Kenneth Ronald
    Telconia Close
    Headley Down
    GU35 8ED Bordon
    7
    Hampshire
    Amministratore
    Telconia Close
    Headley Down
    GU35 8ED Bordon
    7
    Hampshire
    United KingdomBritish34793900002
    TEE, Fiona
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish66385440005
    TIMOTHY, Fiona Maria
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish161343370001
    WALKER, Peter John
    Tring Road
    HP23 4NU Wilstone
    21
    Herts
    Amministratore
    Tring Road
    HP23 4NU Wilstone
    21
    Herts
    EnglandBritish128277860001
    WRIGHT, Alan Stanley
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    Amministratore
    Beechwood, Lime Tree Way
    Chineham Business Park, Chineham
    RG24 8WA Basingstoke
    Unit 1
    Hampshire
    EnglandBritish83067060001
    YORK, Graham
    Glebe House
    Ashmore
    SP5 5AE Shaftsbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Glebe House
    Ashmore
    SP5 5AE Shaftsbury
    Wiltshire
    EnglandEnglish91383980001

    MICROTRAIN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 18 set 2012
    Consegnato il 25 set 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Becap Fund LP
    Transazioni
    • 25 set 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 23 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 16 ott 2001
    Consegnato il 16 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 06 giu 2000
    Consegnato il 08 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all book debts and other debts and by way of floating charge the undertaking and all property and rights of the company both present and future not subject to the fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Redd Factors Limited
    Transazioni
    • 08 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 04 ago 1999
    Consegnato il 09 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 16 feb 1996
    Consegnato il 23 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0