SIMON UK 1995 LIMITED

SIMON UK 1995 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSIMON UK 1995 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03006209
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SIMON UK 1995 LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova SIMON UK 1995 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    130 Shaftesbury Avenue
    2nd Floor
    W1D 5EU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SIMON UK 1995 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PRECIS (1322) LIMITED05 gen 199505 gen 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di SIMON UK 1995 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per SIMON UK 1995 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    5 pagine4.71

    Cessazione della carica di Freddy Achiel Bracke come amministratore in data 27 mag 2013

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr. Franciscus Johannes Antonius Las come amministratore in data 27 mag 2013

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da The Quadrangle 2nd Floor 180 Wardour Street London W1F 8LB in data 26 mar 2013

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Clough Lane North Killingholme North Lincolnshire DN40 3LX in data 15 gen 2013

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    4 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 17 dic 2012

    LRESSP

    Cessazione della carica di Joost Marc Edmond Rubens come amministratore in data 30 nov 2012

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gary John Walker come amministratore in data 30 nov 2012

    2 pagineTM01

    legacy

    5 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 gen 2012

    Stato del capitale al 18 gen 2012

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Cessazione della carica di Patricia Grout come segretario

    2 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Patricia Ann Grout il 10 gen 2011

    3 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 05 gen 2011

    15 pagineAR01

    Cessazione della carica di Exrealm Limited come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Freddy Achiel Bracke come amministratore

    3 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    13 pagineAR01

    Cessazione della carica di Freddy Bracke come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gary John Walker il 01 ott 2009

    3 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di SIMON UK 1995 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LAS, Franciscus Johannes Antonius
    Shaftesbury Avenue
    2nd Floor
    W1D 5EU London
    130
    Amministratore
    Shaftesbury Avenue
    2nd Floor
    W1D 5EU London
    130
    NetherlandsDutch178713940001
    CATT, Richard John
    Avenings School Lane
    RH17 7JE Danehill
    West Sussex
    Segretario
    Avenings School Lane
    RH17 7JE Danehill
    West Sussex
    British1367810004
    GROUT, Patricia Ann
    Clough Lane
    North Killingholme
    DN40 3LX North Lincolnshire
    Segretario
    Clough Lane
    North Killingholme
    DN40 3LX North Lincolnshire
    British126598200002
    KEANE, Adrian Spencer
    Dale Acre Barn
    Main Street
    DE74 2RH Lockington
    Derby
    Segretario
    Dale Acre Barn
    Main Street
    DE74 2RH Lockington
    Derby
    British62552110002
    NOLAN, Niall Joseph
    14 Savona Close
    Wimbledon
    SW19 4HT London
    Segretario
    14 Savona Close
    Wimbledon
    SW19 4HT London
    Irish114924350001
    PARSONS, Neil
    Hope Cottage
    13 Cooper Lane Laceby
    DN37 7AY Grimsby
    Segretario
    Hope Cottage
    13 Cooper Lane Laceby
    DN37 7AY Grimsby
    British97073270001
    VAN BELLINGEN, Frank Luc Renaat
    St Amandsstraat 95
    Strombeek-Bever
    B-1853
    Belgium
    Segretario
    St Amandsstraat 95
    Strombeek-Bever
    B-1853
    Belgium
    Belgian105595770001
    OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    Segretario
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    2519400001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BRACKE, Freddy Achiel
    Wardour Street
    W1F 8FY London
    The Quadrangle 180
    Amministratore
    Wardour Street
    W1F 8FY London
    The Quadrangle 180
    LuxembourgBelgian147405030001
    BRACKE, Freddy Achiel
    Wardour Street
    W1F 8FY London
    The Quadrangle 180
    Amministratore
    Wardour Street
    W1F 8FY London
    The Quadrangle 180
    LuxembourgBelgian147405030001
    CATT, Richard John
    Avenings School Lane
    RH17 7JE Danehill
    West Sussex
    Amministratore
    Avenings School Lane
    RH17 7JE Danehill
    West Sussex
    EnglandBritish1367810004
    CHADWICK, Timothy John Mackenzie
    8 Clifton House
    Hollywood Road
    SW10 9XA London
    Amministratore
    8 Clifton House
    Hollywood Road
    SW10 9XA London
    United KingdomBritish119078580001
    CIGRANG, Christian Leon
    Arthur Goemaerelei 24
    Antwerpen
    2018
    Belgium
    Amministratore
    Arthur Goemaerelei 24
    Antwerpen
    2018
    Belgium
    BelgiumBelgian74484810001
    DILLON, John Edward Michael
    1 Belsize Mews
    Belsize Park
    NW3 5AT London
    Amministratore delegato nominato
    1 Belsize Mews
    Belsize Park
    NW3 5AT London
    British900009730001
    KEANE, Adrian Spencer
    Dale Acre Barn
    Main Street
    DE74 2RH Lockington
    Derby
    Amministratore
    Dale Acre Barn
    Main Street
    DE74 2RH Lockington
    Derby
    United KingdomBritish62552110002
    NEAL, Leon
    34 Hill Crest
    TN4 0AJ Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore delegato nominato
    34 Hill Crest
    TN4 0AJ Tunbridge Wells
    Kent
    British900008140001
    OSBORNE, Andrew Norman Robert
    43 Dalkeith Road
    Dulwich
    SE21 8LT London
    Amministratore
    43 Dalkeith Road
    Dulwich
    SE21 8LT London
    British47330430001
    PARSONS, Neil
    Hope Cottage
    13 Cooper Lane Laceby
    DN37 7AY Grimsby
    Amministratore
    Hope Cottage
    13 Cooper Lane Laceby
    DN37 7AY Grimsby
    British97073270001
    POULTON, Simon Nicholas
    15 Oakdene
    Wilton Road
    HP9 2BZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    15 Oakdene
    Wilton Road
    HP9 2BZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish11323860002
    REDBURN, Timothy John
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    Amministratore
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    EnglandBritish22018030002
    RUBENS, Joost Marc Edmond
    Wardour Street
    W1F 8FY London
    The Quadrangle 180
    Amministratore
    Wardour Street
    W1F 8FY London
    The Quadrangle 180
    BelgiumBelgian134435140002
    VAN BELLINGEN, Frank Luc Renaat
    St Amandsstraat 95
    Strombeek-Bever
    B-1853
    Belgium
    Amministratore
    St Amandsstraat 95
    Strombeek-Bever
    B-1853
    Belgium
    BelgiumBelgian105595770001
    WALKER, Gary John
    Wardour Street
    W1F 8FY London
    The Quadrangle 180
    Amministratore
    Wardour Street
    W1F 8FY London
    The Quadrangle 180
    EnglandBritish134900940001
    WILLIAMSON, Mark David
    The Old Coach House
    Wierton Hill
    ME17 4JS Boughton Monchelsea
    Kent
    Amministratore
    The Old Coach House
    Wierton Hill
    ME17 4JS Boughton Monchelsea
    Kent
    British50785820002
    EXREALM LIMITED
    The Quadrangle 2nd Floor
    180 Wardour Street
    W1F 8FY London
    Amministratore
    The Quadrangle 2nd Floor
    180 Wardour Street
    W1F 8FY London
    65100670001
    MARITIME ADVISORY SERVICES LTD
    The Quadrangle
    180 Wardour Street
    W1F 8FY London
    Amministratore
    The Quadrangle
    180 Wardour Street
    W1F 8FY London
    126598130001

    SIMON UK 1995 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 10 mar 2004
    Consegnato il 19 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the principal borrower and each chargor and/or any other member of the group to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC: Capital Markets (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 19 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 07 apr 1997
    Consegnato il 25 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC(As Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 25 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 07 apr 1997
    Consegnato il 25 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture
    Brevi particolari
    Floating charge all the charging company's undertaking property assets and revenues both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Simon Engineering PLC
    Transazioni
    • 25 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    SIMON UK 1995 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 feb 2014Data di scioglimento
    17 dic 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Martin N Widdowson
    Brebner Allen & Trapp
    The Quadrangle
    W1F 8LB 180 Wardour Street
    London
    Praticante
    Brebner Allen & Trapp
    The Quadrangle
    W1F 8LB 180 Wardour Street
    London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0