RIPPONDEN 7 LIMITED

RIPPONDEN 7 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRIPPONDEN 7 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03006635
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RIPPONDEN 7 LIMITED?

    • Riparazione di altre apparecchiature (33190) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova RIPPONDEN 7 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RIPPONDEN 7 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CARFORD GROUP LIMITED23 nov 199523 nov 1995
    ELJAY LIMITED06 gen 199506 gen 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di RIPPONDEN 7 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 nov 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per RIPPONDEN 7 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    13 pagineLIQ13

    Cessazione della carica di Paul Justin Humphreys come amministratore in data 02 lug 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stephen Roy Baxter come amministratore in data 02 lug 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 01 set 2017

    13 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 01 set 2016

    23 pagine4.68

    Soddisfazione dell'onere 030066350008 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 030066350007 in pieno

    1 pagineMR04

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Meadowcroft Lane Ripponden West Yorkshire HX6 4AJ

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Meadowcroft Lane Halifax Road Ripponden West Yorkshire HX6 4AJ a Deloitte Llp 1 City Square Leeds West Yorkshire LS1 2AL in data 14 set 2015

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 02 set 2015

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed carford group LIMITED\certificate issued on 31/07/15
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name31 lug 2015

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 29 lug 2015

    RES15

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Cessazione della carica di Alan Andrew Barr come amministratore in data 23 gen 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 10 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 gen 2015

    Stato del capitale al 06 gen 2015

    • Capitale: GBP 666,667
    SH01

    Nomina di Mr Paul Justin Humphreys come amministratore in data 22 ott 2014

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 nov 2013

    22 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 030066350008, creata il 30 lug 2014

    79 pagineMR01

    Memorandum e Statuto

    7 pagineMEM/ARTS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 030066350007

    16 pagineMR01

    Bilancio annuale redatto al 10 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 gen 2014

    Stato del capitale al 31 gen 2014

    • Capitale: GBP 666,667
    SH01

    Chi sono gli amministratori di RIPPONDEN 7 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CARTER, John David
    17 Poplar Close
    BH21 1TL Wimborne
    Dorset
    Segretario
    17 Poplar Close
    BH21 1TL Wimborne
    Dorset
    British22240380001
    CARTER, Sheila Raynor
    17 Poplar Close
    BH21 1TL Wimborne
    Dorset
    Segretario
    17 Poplar Close
    BH21 1TL Wimborne
    Dorset
    British56304790001
    WELLER, Richard Norman
    25 Chander Close
    BH22 8DW Ferndown
    Avalon
    Dorset
    Segretario
    25 Chander Close
    BH22 8DW Ferndown
    Avalon
    Dorset
    British77637390003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AUBIN, Nicholas David Ashton
    4 Old Barn Close
    BH23 2QZ Christchurch
    Dorset
    Amministratore
    4 Old Barn Close
    BH23 2QZ Christchurch
    Dorset
    EnglandBritish86274810001
    BARR, Alan Andrew
    Meadowcroft Lane
    Halifax Road
    HX6 4AJ Ripponden
    West Yorkshire
    Amministratore
    Meadowcroft Lane
    Halifax Road
    HX6 4AJ Ripponden
    West Yorkshire
    ScotlandBritish121452150001
    BAXTER, Stephen Roy
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Deloitte Llp
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Deloitte Llp
    West Yorkshire
    ScotlandBritish86622660005
    CARTER, John David
    19 Greenhill Close
    BH21 2RQ Wimborne
    Dorset
    Amministratore
    19 Greenhill Close
    BH21 2RQ Wimborne
    Dorset
    British22240380003
    CARTER, Leonard Edwin
    Terranova 43 Ashurst Road
    West Moors
    BH22 0LR Ferndown
    Dorset
    Amministratore
    Terranova 43 Ashurst Road
    West Moors
    BH22 0LR Ferndown
    Dorset
    British22240390001
    CARTER, Sheila Raynor
    19 Greenhill Close
    BH21 2RQ Wimborne
    Dorset
    Amministratore
    19 Greenhill Close
    BH21 2RQ Wimborne
    Dorset
    British56304790003
    HUMPHREYS, Paul Justin
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Deloitte Llp
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Deloitte Llp
    West Yorkshire
    United KingdomBritish33223550003
    ORYINO, Nicholas Paul
    87 Richmond Hill Gate
    Richmond Hill
    BH2 6LT Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    87 Richmond Hill Gate
    Richmond Hill
    BH2 6LT Bournemouth
    Dorset
    EnglandBritish45059670005
    WELLER, Richard Norman
    25 Chander Close
    BH22 8DW Ferndown
    Avalon
    Dorset
    Amministratore
    25 Chander Close
    BH22 8DW Ferndown
    Avalon
    Dorset
    EnglandBritish77637390003

    RIPPONDEN 7 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 30 lug 2014
    Consegnato il 01 ago 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Registered domain names: carford.co.UK and carfordgroupltd.co.UK. L/h unit 5 mitchell road, fernside park, ferndown, dorset t/no DT384011. L/h unit 1-4 mitchell road, fernside park, ferndown, dorset t/no DT380116.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hayfin Services LLP
    Transazioni
    • 01 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 12 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 04 feb 2014
    Consegnato il 06 feb 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    L/H interest in units 1-4 mitchell road fernside park ferndown industrial estate ferndown dorset and l/h interest in unit 5 mitchell road fernside park ferndown industrial estate ferndown dorset. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hayfin Capital Management LLP
    Transazioni
    • 06 feb 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 12 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 08 ott 2009
    Consegnato il 15 ott 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 15 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 23 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 11 giu 2008
    Consegnato il 13 giu 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge (all assets)
    Creato il 19 mag 2006
    Consegnato il 09 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (the Security Holder)
    Transazioni
    • 09 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 apr 2002
    Consegnato il 03 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 19 mar 2002
    Consegnato il 20 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the chargee pursuant to an agreement for the purchase of debts between the chargee and the company (including the associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the chargee for any reason.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD
    Transazioni
    • 20 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 nov 2001
    Consegnato il 04 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    RIPPONDEN 7 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    02 set 2015Inizio della liquidazione
    07 nov 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stephen Roland Browne
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Adrian Peter Berry
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Praticante
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0