SHORE TO SHORE EUROPE LIMITED

SHORE TO SHORE EUROPE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSHORE TO SHORE EUROPE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03013086
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SHORE TO SHORE EUROPE LIMITED?

    • (2121) /
    • (2222) /

    Dove si trova SHORE TO SHORE EUROPE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 6 Castle Bridge Office Village
    Castle Marina Road
    NG7 1TN Nottingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di SHORE TO SHORE EUROPE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2007

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SHORE TO SHORE EUROPE LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per SHORE TO SHORE EUROPE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    4 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 ott 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 apr 2011

    5 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da Regency House 21 the Ropewalk Nottingham Nottinghamshire NG1 5DU in data 11 apr 2011

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 ott 2010

    8 pagine4.68

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    11 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da Heanor Gate Industrial Park Delves Road Heanor Derbyshire DE75 7SJ in data 07 ott 2009

    2 pagineAD01

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    19 pagineAA

    legacy

    59 pagine395

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    10 pagine395

    legacy

    1 pagine403a

    Chi sono gli amministratori di SHORE TO SHORE EUROPE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HARRIS, Kevin Raymond
    The Barn
    27 Ashbourne Road, Blackbrook
    DE56 2LD Belper
    Derbyshire
    Amministratore
    The Barn
    27 Ashbourne Road, Blackbrook
    DE56 2LD Belper
    Derbyshire
    EnglandBritishDirector66198830002
    KURDIN, Howard Joseph
    8284 Old Woods Court
    Springboro
    Ohio 45342
    Usa
    Amministratore
    8284 Old Woods Court
    Springboro
    Ohio 45342
    Usa
    CanadianCompany Director87466010001
    LAU, Shun Keung
    Flat A 10/F Tower 2, Tptl 135
    4699 Tai Po Road, Deerhill Tower,
    Deerhill Bay Tai Po
    New Territories
    China
    Amministratore
    Flat A 10/F Tower 2, Tptl 135
    4699 Tai Po Road, Deerhill Tower,
    Deerhill Bay Tai Po
    New Territories
    China
    ChineseCompany Director73805520004
    BURKE, Gillian
    62 Dugard Avenue
    Lexden
    CO3 5EL Colchester
    Essex
    Segretario
    62 Dugard Avenue
    Lexden
    CO3 5EL Colchester
    Essex
    British51944940001
    FAWKES, Neil Robert
    25 Sandringham Close
    IP2 9DU Ipswich
    Suffolk
    Segretario
    25 Sandringham Close
    IP2 9DU Ipswich
    Suffolk
    British68449030001
    HARPER, Gary Colin
    86 Ball Hill
    South Normanton
    DE55 2EB Alfreton
    Derbyshire
    Segretario
    86 Ball Hill
    South Normanton
    DE55 2EB Alfreton
    Derbyshire
    BritishCompany Director75419080002
    HUSSEY, Terence Ralph
    Headmasters House
    Hadham Hall
    SG11 2EB Little Hadham
    Hertfordshire
    Segretario
    Headmasters House
    Hadham Hall
    SG11 2EB Little Hadham
    Hertfordshire
    BritishDirector40038070001
    KURDIN, Howard Joseph
    8284 Old Woods Court
    Springboro
    Ohio 45342
    Usa
    Segretario
    8284 Old Woods Court
    Springboro
    Ohio 45342
    Usa
    Canadian87466010001
    LOWEY, John Francis
    Flat 2 Castlethorpe
    Newcastle Circus The Park
    NG7 1BJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Flat 2 Castlethorpe
    Newcastle Circus The Park
    NG7 1BJ Nottingham
    Nottinghamshire
    British93467510002
    SALT, Jacqueline Ann
    Butlers Cottage
    Rectory Farm
    CV9 2LW Baxterley
    Warwickshire
    Segretario nominato
    Butlers Cottage
    Rectory Farm
    CV9 2LW Baxterley
    Warwickshire
    British900006180001
    SPIERS, Susan Lesley
    57 James Close
    DE1 1DP Derby
    Segretario
    57 James Close
    DE1 1DP Derby
    British86690960001
    TOMLINSON, Linda Patricia
    Highfield Road
    Nuthall
    NG16 1BQ Nottingham
    11
    Nottinghamshire
    Segretario
    Highfield Road
    Nuthall
    NG16 1BQ Nottingham
    11
    Nottinghamshire
    BritishHr Director & Company Secretary130073770001
    BURKE, Sean Joseph
    17 Thompson Close
    East Leake
    LE12 6HP Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    17 Thompson Close
    East Leake
    LE12 6HP Loughborough
    Leicestershire
    BritishDirector85201830001
    HARPER, Gary Colin
    86 Ball Hill
    South Normanton
    DE55 2EB Alfreton
    Derbyshire
    Amministratore
    86 Ball Hill
    South Normanton
    DE55 2EB Alfreton
    Derbyshire
    BritishManaging Director75419080002
    HARRIS, Kevin Raymond
    The Barn
    27 Ashbourne Road, Blackbrook
    DE56 2LD Belper
    Derbyshire
    Amministratore
    The Barn
    27 Ashbourne Road, Blackbrook
    DE56 2LD Belper
    Derbyshire
    EnglandBritishDirector66198830002
    HUSSEY, Terence Ralph
    Headmasters House
    Hadham Hall
    SG11 2EB Little Hadham
    Hertfordshire
    Amministratore
    Headmasters House
    Hadham Hall
    SG11 2EB Little Hadham
    Hertfordshire
    BritishDirector40038070001
    KINNEY, James Douglas
    18 Murray Drive
    Neshanic Station
    New Jersey 08853
    U.S.A.
    Amministratore
    18 Murray Drive
    Neshanic Station
    New Jersey 08853
    U.S.A.
    AmericanCompany Director42065170002
    NAKER, Girishkumar Chunilal
    2 Hall Close
    Glen Parva
    LE2 9HZ Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    2 Hall Close
    Glen Parva
    LE2 9HZ Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishFinancial Controller122707730001
    ROWLAND, Charles Nathan
    65 Beck Court
    Springbro
    Ohio 45066
    Usa
    Amministratore
    65 Beck Court
    Springbro
    Ohio 45066
    Usa
    AmericanCompany Director73805510002
    SPIERS, Susan Lesley
    57 James Close
    DE1 1DP Derby
    Amministratore
    57 James Close
    DE1 1DP Derby
    BritishFinance Director86690960001
    TOMLINSON, Linda Patricia
    Highfield Road
    Nuthall
    NG16 1BQ Nottingham
    11
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Highfield Road
    Nuthall
    NG16 1BQ Nottingham
    11
    Nottinghamshire
    UkBritishHr Director & Company Secretary130073770001
    SPRINGFIELD FINANCE LIMITED
    112 High Street
    Coleshill
    B46 3BL Birmingham
    Warwickshire
    Amministratore delegato nominato
    112 High Street
    Coleshill
    B46 3BL Birmingham
    Warwickshire
    900006170001

    SHORE TO SHORE EUROPE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Chattels mortgage
    Creato il 25 giu 2008
    Consegnato il 05 lug 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The equipment being. Reception = ibm think centre personal computer, value £100. flat screen monitor, £40, keyboard and mouse, £10. for details of further chattels charged please refer to form 395. see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Davenham Trust PLC
    Transazioni
    • 05 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee and fixed and floating charge
    Creato il 12 mag 2008
    Consegnato il 15 mag 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 09 nov 2007
    Consegnato il 17 nov 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Davenham Trade Finance Limited
    Transazioni
    • 17 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 22 dic 2006
    Consegnato il 03 gen 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattel mortgage
    Creato il 02 mar 2006
    Consegnato il 07 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited (Gecfl)
    Transazioni
    • 07 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 15 feb 2006
    Consegnato il 16 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Lockwood close top valley nottingham f/h NT236803. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 16 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2008Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 12 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite all assets guarantee and debenture
    Creato il 17 ott 2005
    Consegnato il 18 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 18 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 set 2005
    Consegnato il 10 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 02 set 2003
    Consegnato il 09 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Focus label machinery model 180 used serial no: 1992 5 colour printer. Focus label machinery model F140 used serial no: 1994 4 colour printer. Focus label machinery model L4 used serial no: 160996 1996 4 colour printer. For further details of chattels charged please refer to form 395.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 09 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 31 lug 2003
    Consegnato il 09 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 09 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 29 gen 2003
    Consegnato il 06 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Capital Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 06 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 dic 2002
    Consegnato il 12 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the shares owned by the company in pat print limited.
    Persone aventi diritto
    • Mr and Mrs T Briggs Richmond
    Transazioni
    • 12 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 17 mar 2000
    Consegnato il 23 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 27 apr 1999
    Consegnato il 11 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • G E Capital Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 11 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SHORE TO SHORE EUROPE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 ott 2009Inizio della liquidazione
    30 gen 2015Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    William John Kelly
    Regency House 21 The Ropewalk
    NG1 5DU Nottingham
    Nottinghamshire
    Praticante
    Regency House 21 The Ropewalk
    NG1 5DU Nottingham
    Nottinghamshire
    Peter Andrew Blair
    Regency House 21 The Ropewalk
    NG1 5DU Nottingham
    Nottinghamshire
    Praticante
    Regency House 21 The Ropewalk
    NG1 5DU Nottingham
    Nottinghamshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0