KNOWMASTER LIMITED
Panoramica
Nome della società | KNOWMASTER LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03013147 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di KNOWMASTER LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova KNOWMASTER LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Tower Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Kent England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di KNOWMASTER LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per KNOWMASTER LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Stato del capitale al 18 dic 2012
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Nomina di Mr David James Bruce come amministratore in data 08 ago 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Graham Maxwell Barr come amministratore in data 08 ago 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Nomina di Mr Graham Maxwell Barr come amministratore in data 16 apr 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Bryan Park come amministratore in data 16 apr 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 gen 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Tower Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN United Kingdom in data 21 feb 2012 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 2 County Gate Staceys Street Maidstone Kent ME14 1st in data 07 ott 2011 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Bryan Park come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 gen 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
legacy | 9 pagine | MG01 | ||||||||||
Nomina di Mr Samuel Thomas Budgen Clark come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2009 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Roger Brown come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 24 gen 2010 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di KNOWMASTER LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLARK, Samuel Thomas Budgen | Segretario | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | British | 117669700002 | ||||||
BRUCE, David James | Amministratore | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | United Kingdom | British | Director | 171398800001 | ||||
CLARK, Samuel Thomas Budgen | Amministratore | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | England | British | Director | 149939610001 | ||||
REA, Michael Peter | Amministratore | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | England | British | Director | 147194830001 | ||||
MCLEAN, Linda Ann | Segretario | Rose Cottage Prees Green SY13 2BN Whitchurch Shropshire | British | 95019110001 | ||||||
RICHARDSON, Norman | Segretario | The Moorings School Lane CH66 5PH Childer Thornton South Wirral | British | Solicitor | 34876810002 | |||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BARR, Graham Maxwell | Amministratore | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | United Kingdom | British | Director | 125097020001 | ||||
BROWN, Roger Michael | Amministratore | Staceys Street ME14 1ST Maidstone 2 County Gate Kent | England | British | Director | 134140540001 | ||||
BUNTING, David John | Amministratore | 1 Dibbs Pocket Preston Old Road, Freckleton PR4 1JF Preston Lancashire | United Kingdom | British | Insurance Broker | 63563080002 | ||||
HAMEL, Karl | Amministratore | 47 Forest Road CH60 5SN Heswall Merseyside | United Kingdom | British | Insurance Broker | 111016270001 | ||||
HARRISON, Thomas Millward | Amministratore | 29 Orston Crescent Spital CH63 9NZ Wirral Merseyside | British | Insurance Broker | 94218200001 | |||||
JOHNSON, Timothy David | Amministratore | The Green Westerham TN16 1AS Kent Nursery Cottage 3a | England | British | Director | 129538180001 | ||||
PARK, Bryan | Amministratore | Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent England | England | British | Director | 113694470002 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
KNOWMASTER LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 14 set 2010 Consegnato il 18 set 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of accession to a debenture dated 30 june 2006 and | Creato il 03 ott 2007 Consegnato il 17 ott 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0