RANIER LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRANIER LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03015021
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RANIER LIMITED?

    • Fabbricazione di strumenti e forniture medico-chirurgiche (32500) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova RANIER LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Greenhouse Park Innovation
    Centre, Newmarket Road
    CB5 8AA Teversham
    Cambridge
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di RANIER LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per RANIER LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Completamento della liquidazione

    1 pagineL64.07

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP

    Bilancio annuale redatto al 27 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 feb 2016

    Stato del capitale al 23 feb 2016

    • Capitale: GBP 51,153.85
    SH01

    Cessazione della carica di Nicholas Alexander James Tait come segretario in data 10 lug 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 27 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 mar 2015

    Stato del capitale al 10 mar 2015

    • Capitale: GBP 51,153.85
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2014

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di James Allan Livingston come amministratore in data 29 set 2014

    1 pagineTM01

    Acquisto di azioni proprie.

    3 pagineSH03

    Annullamento di azioni. Stato del capitale al 04 giu 2014

    • Capitale: GBP 51,153.85
    5 pagineSH06

    Risoluzioni

    Resolutions
    7 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di autorità per acquistare un numero di azioni

    RES09

    Nomina di Mr Nicholas Alexander James Tait come segretario

    2 pagineAP03

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 21 mar 2014

    • Capitale: GBP 1,201,502.35
    6 pagineSH01

    Scissione delle azioni al 20 feb 2014

    11 pagineSH02

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 20 feb 2014

    • Capitale: GBP 1,198,980.030000
    7 pagineSH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    90 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    resolution

    Risoluzione di capitalizzazione o emissione di azioni bonus

    £20795.81 20/02/2014
    RES14
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Subdivision 20/02/2014
    RES13
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 030150210006

    36 pagineMR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr James Allan Livingston il 24 feb 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 27 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01

    Memorandum e Statuto

    40 pagineMEM/ARTS

    Risoluzioni

    Resolutions
    8 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 01 nov 2013

    • Capitale: GBP 2,811,458.44
    10 pagineSH01

    Annullamento di azioni. Stato del capitale al 27 gen 2014

    • Capitale: GBP 1,169,958.44
    10 pagineSH06

    Chi sono gli amministratori di RANIER LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ANDREWS, Geoffrey Thomas, Dr
    Greenhouse Park Innovation
    Centre, Newmarket Road
    CB5 8AA Teversham
    Cambridge
    Amministratore
    Greenhouse Park Innovation
    Centre, Newmarket Road
    CB5 8AA Teversham
    Cambridge
    EnglandBritishScientist41797280002
    LEWIS, Michael Geoffrey
    Greenhouse Park Innovation
    Centre, Newmarket Road
    CB5 8AA Teversham
    Cambridge
    Amministratore
    Greenhouse Park Innovation
    Centre, Newmarket Road
    CB5 8AA Teversham
    Cambridge
    United KingdomEnglishNon-Executive165471580001
    WOLFERS, Peter Benjamin
    Greenhouse Park Innovation
    Centre, Newmarket Road
    CB5 8AA Teversham
    Cambridge
    Amministratore
    Greenhouse Park Innovation
    Centre, Newmarket Road
    CB5 8AA Teversham
    Cambridge
    United KingdomBritishDirector72173650002
    ANDREWS, Geoffrey Thomas, Dr
    18 Maids Causeway
    CB5 8DA Cambridge
    Segretario
    18 Maids Causeway
    CB5 8DA Cambridge
    BritishScientist41797280002
    BIRD, Caroline Helen
    Greenhouse Park Innovation
    Centre, Newmarket Road
    CB5 8AA Teversham
    Cambridge
    Segretario
    Greenhouse Park Innovation
    Centre, Newmarket Road
    CB5 8AA Teversham
    Cambridge
    BritishFinance And Administration Man118090030003
    KEAVENEY, Rachel
    31 Butt Lane
    Milton
    CB4 6DG Cambridge
    Segretario
    31 Butt Lane
    Milton
    CB4 6DG Cambridge
    BritishFinance & Admin Manager82264420002
    TAIT, Nicholas Alexander James
    Greenhouse Park Innovation
    Centre, Newmarket Road
    CB5 8AA Teversham
    Cambridge
    Segretario
    Greenhouse Park Innovation
    Centre, Newmarket Road
    CB5 8AA Teversham
    Cambridge
    187669590001
    WOLFERS, Peter
    Greenhouse Park Innovation
    Centre, Newmarket Road
    CB5 8AA Teversham
    Cambridge
    Segretario
    Greenhouse Park Innovation
    Centre, Newmarket Road
    CB5 8AA Teversham
    Cambridge
    173882290001
    ANDREWS, Wendy Dallas
    18 Maids Causeway
    CB5 8DA Cambridge
    Amministratore
    18 Maids Causeway
    CB5 8DA Cambridge
    BritishConsultant41797270002
    ELLERKAMP, William Gerard
    55 Rotherwick Road
    NW11 7DD London
    Amministratore
    55 Rotherwick Road
    NW11 7DD London
    UsaDirector111043080001
    HOPE, Richard Lawrie
    Belgrave Crescent
    EH4 3AJ Edinburgh
    20/3
    Midlothian
    Amministratore
    Belgrave Crescent
    EH4 3AJ Edinburgh
    20/3
    Midlothian
    ScotlandBritishInvestment Manager128447390001
    HUGHES, Graham Robert, Dr
    Westholme
    Heath Road
    GU21 4DT Woking
    Surrey
    Amministratore
    Westholme
    Heath Road
    GU21 4DT Woking
    Surrey
    BritishDirector Of Scientific Affairs80664690001
    KRUSE, Gunther, Dr
    33 Kent Road
    KT8 9JZ East Molesey
    Surrey
    Amministratore
    33 Kent Road
    KT8 9JZ East Molesey
    Surrey
    GermanDirector60394960002
    LIVINGSTON, James Allan
    London Bridge Street
    SE1 9SG London
    32
    England
    Amministratore
    London Bridge Street
    SE1 9SG London
    32
    England
    UkBritishInvestment Manager164760010003
    MASON, William Thomas, Dr
    7 Curzon Street
    Mayfair
    W1J 5HG London
    Amministratore
    7 Curzon Street
    Mayfair
    W1J 5HG London
    United KingdomAmericanNon Exec Director13387940004
    MORAN, John C
    Greenhouse Park Innovation
    Centre, Newmarket Road
    CB5 8AA Teversham
    Cambridge
    Amministratore
    Greenhouse Park Innovation
    Centre, Newmarket Road
    CB5 8AA Teversham
    Cambridge
    UsaAmericanDirector116585140001
    PONCIPE, Carlo
    11 Woodhead Drive
    CB4 1FG Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    11 Woodhead Drive
    CB4 1FG Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishDevelopment Director45350200001
    ROSTRON, Laurence
    Grace Cottage
    Church Lane
    HP27 0QX Lacey Green
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Grace Cottage
    Church Lane
    HP27 0QX Lacey Green
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishNon Exec Director- Advisor125951190001
    SMITH, Nigel Gordon
    The Tythe Barn
    Shaftenhoe End, Barley
    SG8 8LE Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Tythe Barn
    Shaftenhoe End, Barley
    SG8 8LE Royston
    Hertfordshire
    BritishDirector67473960002
    SNELL, Robert Adam
    Greenhouse Park Innovation
    Centre, Newmarket Road
    CB5 8AA Teversham
    Cambridge
    Amministratore
    Greenhouse Park Innovation
    Centre, Newmarket Road
    CB5 8AA Teversham
    Cambridge
    EnglandBritishDirector66836460002

    RANIER LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 feb 2014
    Consegnato il 28 feb 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Patent scope: manufacturing (ppm) territory:au patent or application no. 2001275733 status: granted. Au patent or application no. 2006201583 status: granted. Br patent or application no. P10112968-6 status: granted. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Kreos Capital Iv (UK) Limited
    Transazioni
    • 28 feb 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 13 set 2012
    Consegnato il 29 set 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the holders from time to time of loan notes under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge interest in any intellectual property, any existing and future proceeds of any insurance of any charged property and any sum now or at any time after the date of the deed received as a result of any order of court see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • First Ventures Limited
    Transazioni
    • 29 set 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 mar 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 12 set 2011
    Consegnato il 29 set 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the holders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed and floating charge the interest in any intellectual property and proceeds of any insurance see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • First Ventures Limited (Agent)
    Transazioni
    • 29 set 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 29 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 14 feb 2007
    Consegnato il 22 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Renate Nixdorf Gmbh & Co Kg
    Transazioni
    • 22 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge over intellectual property
    Creato il 28 feb 2005
    Consegnato il 11 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the noteholders or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the right title interest and benefit in each of the following the materials the chargor ip the licences the goodwill in and relating to the business. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Renate Nixdorf Verwaltungsgesellschaft Mbh (The Security Trustee in Its Capacity as Securitytrustee for the Noteholders
    Transazioni
    • 11 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 28 set 2001
    Consegnato il 05 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Martin Heinz Nixdorf
    Transazioni
    • 05 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    RANIER LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 ago 2016Conclusione della liquidazione
    22 gen 2016Data della petizione
    07 mar 2016Inizio della liquidazione
    12 nov 2016Data prevista di scioglimento
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or Cambridge
    3rd Floor Eastbrook Shaftesbury Road
    CB2 8DR Cambridge
    Cambridgeshire
    Praticante
    3rd Floor Eastbrook Shaftesbury Road
    CB2 8DR Cambridge
    Cambridgeshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0