NSB RETAIL SYSTEMS LIMITED

NSB RETAIL SYSTEMS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNSB RETAIL SYSTEMS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03015908
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NSB RETAIL SYSTEMS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova NSB RETAIL SYSTEMS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    First Floor Templeback
    10 Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NSB RETAIL SYSTEMS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NSB RETAIL SYSTEMS PLC30 gen 199530 gen 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di NSB RETAIL SYSTEMS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per NSB RETAIL SYSTEMS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 gen 2024 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 30 set 2022

    18 pagineAA

    legacy

    69 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    69 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 gen 2023 con aggiornamenti

    7 pagineCS01

    Stato del capitale al 12 gen 2023

    • Capitale: GBP 0.999944
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 12/01/2023
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 14 dic 2022

    • Capitale: GBP 0.999944
    4 pagineSH01

    Memorandum e Statuto

    7 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 30 set 2021

    18 pagineAA

    legacy

    68 paginePARENT_ACC

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Approval of accounts 26/09/2022
    RES13

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 gen 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 030159080012 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di NSB RETAIL SYSTEMS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VISTRA COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Templeback
    10 Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    First Floor
    Segretario
    Templeback
    10 Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    First Floor
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione00555893
    97584300011
    BAUM, David
    Suite 300
    St-Laurent
    9300 Trans-Canada Hwy
    Quebec H4s 1k5
    Canada
    Amministratore
    Suite 300
    St-Laurent
    9300 Trans-Canada Hwy
    Quebec H4s 1k5
    Canada
    CanadaCanadian197997360001
    BOLT, Geoffrey Robert
    37 St Marys Road
    Little Haywood
    ST18 0QG Stafford
    Staffordshire
    Segretario
    37 St Marys Road
    Little Haywood
    ST18 0QG Stafford
    Staffordshire
    British16454990001
    CHEUNG, Yu-Ho
    St. Marys Close
    Wheatley
    OX33 1YP Oxford
    48
    England
    Segretario
    St. Marys Close
    Wheatley
    OX33 1YP Oxford
    48
    England
    British129862370001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Segretario nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    ABRAHAM, Ashley Richard
    39 Platts Lane
    NW3 7NN London
    Amministratore
    39 Platts Lane
    NW3 7NN London
    EnglandBritish54808030001
    ALLEN, Paul Christopher
    Broom House
    Bayleys Hill Road
    TN8 7AS Bough Beech
    Kent
    Amministratore
    Broom House
    Bayleys Hill Road
    TN8 7AS Bough Beech
    Kent
    United KingdomIrish185112730001
    BECKETT, Nikaila Susan
    The Old Manor
    DT2 8TQ Dorchester
    Dorset
    Amministratore
    The Old Manor
    DT2 8TQ Dorchester
    Dorset
    United KingdomBritish125142900001
    BENTLER, Mark J., Mr.
    Suite 300
    St-Laurent
    9300 Trans-Canada Hwy
    Quebec H4s 1k5
    Canada
    Amministratore
    Suite 300
    St-Laurent
    9300 Trans-Canada Hwy
    Quebec H4s 1k5
    Canada
    CanadaCanadian197997370001
    BOLT, Geoffrey Robert
    37 St Marys Road
    Little Haywood
    ST18 0QG Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    37 St Marys Road
    Little Haywood
    ST18 0QG Stafford
    Staffordshire
    EnglandBritish16454990001
    BRIMS, John Charles Roy
    Four Seasons
    Hillfoot, Bucklebury
    RG7 6PG Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Four Seasons
    Hillfoot, Bucklebury
    RG7 6PG Reading
    Berkshire
    EnglandBritish72118430001
    CARRELL, Michael Eddie
    Shooters
    Westmill
    SG9 9LJ Buntingford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Shooters
    Westmill
    SG9 9LJ Buntingford
    Hertfordshire
    British16003460001
    CHATWIN, Martin Anthony
    Clifton House 2 Newfield Place
    Dore
    S17 3ER Sheffield
    Amministratore
    Clifton House 2 Newfield Place
    Dore
    S17 3ER Sheffield
    EnglandBritish141351250001
    CHEUNG, Yu-Ho, Mr.
    St. Marys Close
    Wheatley
    OX33 1YP Oxford
    48
    England
    Amministratore
    St. Marys Close
    Wheatley
    OX33 1YP Oxford
    48
    England
    EnglandBritish129862370004
    CLARK, Richard John
    c/o Epicor Software (Uk) Limited
    The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No.1
    Berkshire
    England
    Amministratore
    c/o Epicor Software (Uk) Limited
    The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No.1
    Berkshire
    England
    EnglandBritish91263440002
    FERGUSON, David Sinclair
    2469, Rivers Road N.W.
    Atlanta
    FOREIGN 30305 Georgia
    Usa
    Amministratore
    2469, Rivers Road N.W.
    Atlanta
    FOREIGN 30305 Georgia
    Usa
    American120316060001
    FRAZER, Virginia May
    Branksomewood Road
    GU51 4JY Fleet
    Branksome House
    Hampshire
    Amministratore
    Branksomewood Road
    GU51 4JY Fleet
    Branksome House
    Hampshire
    British129779470001
    HATFIELD, Alan John
    The Rowans
    Buckworth
    PE28 5AN Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    The Rowans
    Buckworth
    PE28 5AN Huntingdon
    Cambridgeshire
    British111419140001
    HENNING, David
    210 Gentlewoods Dc
    Cary
    Nc 27518
    Usa
    Amministratore
    210 Gentlewoods Dc
    Cary
    Nc 27518
    Usa
    Usa121435430002
    IRELAND, John David
    Patterson Road
    Austin
    1380
    Texas
    Usa
    Amministratore
    Patterson Road
    Austin
    1380
    Texas
    Usa
    United StatesAmerican129773050002
    JOHNSON, Peter Robert
    3524 Jackson Street
    San Francisco
    FOREIGN California
    94118
    Usa
    Amministratore
    3524 Jackson Street
    San Francisco
    FOREIGN California
    94118
    Usa
    Australian54805470002
    LABORDE, Jeffrey Monroe
    Suite 2500
    Atlanta
    945 East Paces Ferry Rd Ne
    Georgia 30326
    United States
    Amministratore
    Suite 2500
    Atlanta
    945 East Paces Ferry Rd Ne
    Georgia 30326
    United States
    GeorgiaAmerican232934100001
    LASSNER, William Michael Victor
    328 Kensington Avenue
    Westmount
    Quebec H3z 2h3
    Canada
    Amministratore
    328 Kensington Avenue
    Westmount
    Quebec H3z 2h3
    Canada
    Canadian74567210001
    LINDSAY, Iain Dixon
    Parkway
    SL7 1YL Marlow
    Marlow International
    United Kingdom
    Amministratore
    Parkway
    SL7 1YL Marlow
    Marlow International
    United Kingdom
    United KingdomBritish109197530002
    MCALEESE, John
    5 Cavendish Gardens
    Winnersh
    RG41 5TG Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    5 Cavendish Gardens
    Winnersh
    RG41 5TG Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish125362020001
    MITCHELL, Stuart Roger
    60 William Hunt Mansions
    Somerville Avenue
    SW13 8HT London
    Amministratore
    60 William Hunt Mansions
    Somerville Avenue
    SW13 8HT London
    New Zealand1447530003
    MONRO, Angus
    84 Macclesfield Road
    SK10 4AG Prestbury
    Cheshire
    Amministratore
    84 Macclesfield Road
    SK10 4AG Prestbury
    Cheshire
    EnglandBritish79054360001
    MOORER, Seale
    2905 Indigo Bush Way
    Naples
    FOREIGN Florida
    34105
    Usa
    Amministratore
    2905 Indigo Bush Way
    Naples
    FOREIGN Florida
    34105
    Usa
    American65641530003
    QUARTERMAINE, Mark Richard
    Gary Cottage
    London Road
    SL5 0PH Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Gary Cottage
    London Road
    SL5 0PH Ascot
    Berkshire
    EnglandBritish206030570001
    ROSE, Stuart Alan Ransom
    4 St Johns House
    30 Smith Square
    SW1P 3HF London
    Amministratore
    4 St Johns House
    30 Smith Square
    SW1P 3HF London
    British73189720001
    STOTLAND, Howard
    561 Lansdowne Avenue
    West Mount
    FOREIGN Quebec H32 2ls
    Canada
    Amministratore
    561 Lansdowne Avenue
    West Mount
    FOREIGN Quebec H32 2ls
    Canada
    Canadian24566610001
    VICKERY, Alan Graham
    Greensleeves Talbot Avenue
    B74 3DB Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    Greensleeves Talbot Avenue
    B74 3DB Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish4180850001
    ZACK, Stanley Ernest
    5822 Einstein
    FOREIGN Montreal
    Qye H4w 2y6
    Canada
    Amministratore
    5822 Einstein
    FOREIGN Montreal
    Qye H4w 2y6
    Canada
    Canadian75045070001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Chi sono le persone con controllo significativo di NSB RETAIL SYSTEMS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Templeback
    10 Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    First Floor
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Templeback
    10 Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    First Floor
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione10238826
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    NSB RETAIL SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 11 feb 2021
    Consegnato il 11 feb 2021
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    None.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wilmington Savings Fund Society, Fsb
    Transazioni
    • 11 feb 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 dic 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 17 apr 2020
    Consegnato il 22 apr 2020
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Keybank National Association
    Transazioni
    • 22 apr 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 dic 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 23 lug 2018
    Consegnato il 31 lug 2018
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse Ag, Cayman Islands Branch, as Collateral Agent for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 31 lug 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 24 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 02 ott 2017
    Consegnato il 04 ott 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    None.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Macquarie Capital Funding Llc
    Transazioni
    • 04 ott 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 31 lug 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 01 set 2016
    Consegnato il 12 set 2016
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ubs Ag, Stamford Branch (The Collateral Agent)
    Transazioni
    • 12 set 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 31 lug 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Pledge agreement
    Creato il 13 nov 2003
    Consegnato il 28 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the nsb parties to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All stock & other equity interests. All the right, title & interest in & to such stock & equity interests.
    Persone aventi diritto
    • 3068358 Canada Inc.
    Transazioni
    • 28 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 nov 2003
    Consegnato il 28 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the nsb parties to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3068358 Canada Inc
    Transazioni
    • 28 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 nov 2002
    Consegnato il 04 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of charge
    Creato il 03 mar 2000
    Consegnato il 17 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under all or any of the finance documents (as defined in a facility letter dated 27TH january 2000)
    Brevi particolari
    All sums of money deposited by the company deposited to the credit of account number 90863432 with barclays bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 03 apr 1996
    Consegnato il 24 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £10,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The rental deposit of £10,000 and the amount from time to time standing to the credit of a deposit account at barclays bank PLC.
    Persone aventi diritto
    • Palace Street Investments PLC
    Transazioni
    • 24 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 feb 1995
    Consegnato il 17 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    $300,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Peter R.Johnson
    Transazioni
    • 17 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0