SCHOICE EUROPE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SCHOICE EUROPE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03017507 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SCHOICE EUROPE LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova SCHOICE EUROPE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SCHOICE EUROPE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SUNCHOICE EUROPE LIMITED | 31 gen 2001 | 31 gen 2001 |
| SUNSCRIPT UK LIMITED | 03 mar 1995 | 03 mar 1995 |
| ADULTMERIT LIMITED | 02 feb 1995 | 02 feb 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SCHOICE EUROPE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per SCHOICE EUROPE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario in data 09 ott 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione | 6 pagine | 1.4 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Timothy James Bolot come amministratore in data 17 ago 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore | 4 pagine | 1.1 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 gen 2012 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di William James Buchan come amministratore in data 15 nov 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di David Andrew Smith come amministratore in data 01 nov 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Stephen Jonathan Taylor come amministratore in data 26 ott 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Timothy James Bolot come amministratore in data 26 ott 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2010 | 28 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Mr Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di William Mcleish come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 gen 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Richard Midmer come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
legacy | 18 pagine | MG01 | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 4 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 27 set 2009 | 27 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 gen 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David Andrew Smith il 07 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di SCHOICE EUROPE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR, Stephen Jonathan | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 163496070001 | |||||
| FORD, Colin Andrew | Segretario | 12 Willow Drive Milton Of Campsie G66 8DY Glasgow Lanarkshire | British | 70144650001 | ||||||
| HURRELL, Steven Alfred | Segretario | 8 Hamilton Crescent Bearsden G61 3JP Glasgow Strathclyde | British | 82311390001 | ||||||
| KIME, Sean Thomas | Segretario | Flat 1 3 Nevern Place SW5 9NR London | British | 89002440002 | ||||||
| MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Segretario | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158661980001 | |||||||
| MCLEISH, William David | Segretario | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
| MURPHY, Charles Furber | Segretario | 8 Tidwells Lea Warfield RG42 3TP Bracknell Berkshire | British | 69603410001 | ||||||
| ROACH, Paul Vyvyan | Segretario | 65 Greenfields Avenue Appleton WA4 3BW Warrington | British | 61280700002 | ||||||
| RUTTER, Christopher | Segretario | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| WALKER, David James | Segretario | 16 Ribchester Gardens Culcheth WA3 5EZ Warrington | British | 50400470001 | ||||||
| MINCING LANE CORPORATE SERVICES LIMITED | Segretario | Pickfords Wharf Clink Street SE1 9DG London | 32940220004 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ABLETT, Julie | Amministratore | 166 Rutland Road West Bridgford NG2 5DZ Nottingham | British | 57906600001 | ||||||
| ANTONIADES, Linos | Amministratore | Redcroft 90 Bloom Street SK3 9LH Stockport Cheshire | British | 76247350001 | ||||||
| ATWILL, Robert Frederick | Amministratore | 46 Saint Johns Avenue WA16 0DH Knutsford Cheshire | British | 61398460002 | ||||||
| BAXENDALE, Peter David | Amministratore | 11 Chaucer Close Eccleston PR7 5UJ Chorley Lancashire | British | 48955500002 | ||||||
| BOLOT, Timothy James | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 107837080002 | |||||
| BUCHAN, William James | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 79917240001 | |||||
| COLVIN, William | Amministratore | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890003 | |||||
| FLAHERTY, James Paul | Amministratore | Flat 18 Montagu Court 27-29 Montagu Square W1H 2LG London | American | 100530310001 | ||||||
| FOULKES, Kamma | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| GOSLING, Mark David | Amministratore | Fosse Beck Bewerley HG3 5HX Harrogate | British | 66801660002 | ||||||
| HORNBY, Barbara Mccall | Amministratore | 22 The Willows Eaves Green PR7 3RQ Chorley Lasncashire | British | 81964520002 | ||||||
| JAP, Chee Miau | Amministratore | 8 Thurloe Street SW7 2ST London | United Kingdom | Singaporean | 101200680001 | |||||
| KERR, Andrew | Amministratore | 33 Vermont Close Great Sankey WA5 5WX Warrington Cheshire | British | 62025650002 | ||||||
| LIDDLE, Peter | Amministratore | 10 Lock Close CV37 6GF Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 76247270001 | ||||||
| LOCK, Jason David | Amministratore | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | 144822040001 | |||||
| MCINTEER, Warren Hill | Amministratore | 11 Thorn Road Bearsden G61 4PP Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 100131200001 | |||||
| MIDMER, Richard Neil | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 110640170001 | |||||
| MURPHY, John | Amministratore | 4 Lochend Road KA10 6JJ Troon | United Kingdom | British | 26177180004 | |||||
| PHIPPEN, Kent William | Amministratore | 12 Elm Tree Road St Johns Wood NW8 9JX London | United Kingdom | American | 84576560001 | |||||
| ROACH, Paul Vyvyan | Amministratore | 65 Greenfields Avenue Appleton WA4 3BW Warrington | British | 61280700002 | ||||||
| SAXTON, Karen Margaret | Amministratore | Pickfords Wharf Clink Street SE1 9DG London | British | 42430820001 | ||||||
| SCHELLING, Warren Charles | Amministratore | 1117 Desert Classic Lane Ne 87111 Albuquerque New Mexico America | American | 66841650001 | ||||||
| SCOTT, Kenneth Cameron Knowles | Amministratore | Weeke Hill TQ6 0JT Dartmouth Little Weeke Devon | United Kingdom | British | 86218520002 |
SCHOICE EUROPE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of accession and charge | Creato il 18 ago 2010 Consegnato il 27 ago 2010 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital plant and machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 12 set 2001 Consegnato il 02 ott 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 04 gen 2001 Consegnato il 09 gen 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 22 feb 2000 Consegnato il 13 mar 2000 | In corso | Importo garantito £14,777 due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The chargors interest in the deposit account opened by the chargee at hsbc bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 22 feb 2000 Consegnato il 13 mar 2000 | In corso | Importo garantito £29,554 due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The chargors interest in the deposit account opened by the chargee at hsbc bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 15 nov 1995 Consegnato il 02 dic 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a lease dated 19/8/92 | |
Brevi particolari The initial sum of £9,600 held as stakeholders by bates & partners of bartya house. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 15 nov 1995 Consegnato il 30 nov 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £9,600 due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The sum of £9,600 and interest thereon held in a deposit account at barclays bank PLC. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
SCHOICE EUROPE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA) |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0