SCHOICE EUROPE LIMITED

SCHOICE EUROPE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSCHOICE EUROPE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03017507
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SCHOICE EUROPE LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova SCHOICE EUROPE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SCHOICE EUROPE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SUNCHOICE EUROPE LIMITED31 gen 200131 gen 2001
    SUNSCRIPT UK LIMITED03 mar 199503 mar 1995
    ADULTMERIT LIMITED02 feb 199502 feb 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di SCHOICE EUROPE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per SCHOICE EUROPE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario in data 09 ott 2012

    1 pagineTM02

    Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione

    6 pagine1.4

    Cessazione della carica di Timothy James Bolot come amministratore in data 17 ago 2012

    1 pagineTM01

    Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore

    4 pagine1.1

    Bilancio annuale redatto al 21 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 gen 2012

    Stato del capitale al 31 gen 2012

    • Capitale: GBP 3,742,000
    SH01

    Cessazione della carica di William James Buchan come amministratore in data 15 nov 2011

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Andrew Smith come amministratore in data 01 nov 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Jonathan Taylor come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Timothy James Bolot come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    28 pagineAA

    Nomina di Mr Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di William Mcleish come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 21 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Cessazione della carica di Richard Midmer come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    18 pagineMG01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Terms of banking facilities-documents agreed 17/06/2010
    RES13

    Bilancio redatto al 27 set 2009

    27 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Andrew Smith il 07 gen 2010

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di SCHOICE EUROPE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    FORD, Colin Andrew
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    12 Willow Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8DY Glasgow
    Lanarkshire
    British70144650001
    HURRELL, Steven Alfred
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    Segretario
    8 Hamilton Crescent
    Bearsden
    G61 3JP Glasgow
    Strathclyde
    British82311390001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Segretario
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British89002440002
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Segretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158661980001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Segretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Segretario
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    British69603410001
    ROACH, Paul Vyvyan
    65 Greenfields Avenue
    Appleton
    WA4 3BW Warrington
    Segretario
    65 Greenfields Avenue
    Appleton
    WA4 3BW Warrington
    British61280700002
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Segretario
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    WALKER, David James
    16 Ribchester Gardens
    Culcheth
    WA3 5EZ Warrington
    Segretario
    16 Ribchester Gardens
    Culcheth
    WA3 5EZ Warrington
    British50400470001
    MINCING LANE CORPORATE SERVICES LIMITED
    Pickfords Wharf
    Clink Street
    SE1 9DG London
    Segretario
    Pickfords Wharf
    Clink Street
    SE1 9DG London
    32940220004
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ABLETT, Julie
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    Amministratore
    166 Rutland Road
    West Bridgford
    NG2 5DZ Nottingham
    British57906600001
    ANTONIADES, Linos
    Redcroft
    90 Bloom Street
    SK3 9LH Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    Redcroft
    90 Bloom Street
    SK3 9LH Stockport
    Cheshire
    British76247350001
    ATWILL, Robert Frederick
    46 Saint Johns Avenue
    WA16 0DH Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    46 Saint Johns Avenue
    WA16 0DH Knutsford
    Cheshire
    British61398460002
    BAXENDALE, Peter David
    11 Chaucer Close
    Eccleston
    PR7 5UJ Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    11 Chaucer Close
    Eccleston
    PR7 5UJ Chorley
    Lancashire
    British48955500002
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Amministratore
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    American100530310001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    Amministratore
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    British66801660002
    HORNBY, Barbara Mccall
    22 The Willows
    Eaves Green
    PR7 3RQ Chorley
    Lasncashire
    Amministratore
    22 The Willows
    Eaves Green
    PR7 3RQ Chorley
    Lasncashire
    British81964520002
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    Amministratore
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporean101200680001
    KERR, Andrew
    33 Vermont Close
    Great Sankey
    WA5 5WX Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    33 Vermont Close
    Great Sankey
    WA5 5WX Warrington
    Cheshire
    British62025650002
    LIDDLE, Peter
    10 Lock Close
    CV37 6GF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    10 Lock Close
    CV37 6GF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British76247270001
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Amministratore
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MCINTEER, Warren Hill
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    11 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish100131200001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Amministratore
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    PHIPPEN, Kent William
    12 Elm Tree Road
    St Johns Wood
    NW8 9JX London
    Amministratore
    12 Elm Tree Road
    St Johns Wood
    NW8 9JX London
    United KingdomAmerican84576560001
    ROACH, Paul Vyvyan
    65 Greenfields Avenue
    Appleton
    WA4 3BW Warrington
    Amministratore
    65 Greenfields Avenue
    Appleton
    WA4 3BW Warrington
    British61280700002
    SAXTON, Karen Margaret
    Pickfords Wharf Clink Street
    SE1 9DG London
    Amministratore
    Pickfords Wharf Clink Street
    SE1 9DG London
    British42430820001
    SCHELLING, Warren Charles
    1117 Desert Classic Lane Ne
    87111 Albuquerque
    New Mexico
    America
    Amministratore
    1117 Desert Classic Lane Ne
    87111 Albuquerque
    New Mexico
    America
    American66841650001
    SCOTT, Kenneth Cameron Knowles
    Weeke Hill
    TQ6 0JT Dartmouth
    Little Weeke
    Devon
    Amministratore
    Weeke Hill
    TQ6 0JT Dartmouth
    Little Weeke
    Devon
    United KingdomBritish86218520002

    SCHOICE EUROPE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of accession and charge
    Creato il 18 ago 2010
    Consegnato il 27 ago 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 27 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Fixed and floating charge
    Creato il 12 set 2001
    Consegnato il 02 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ashbourne Limited
    Transazioni
    • 02 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 13 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 04 gen 2001
    Consegnato il 09 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 22 feb 2000
    Consegnato il 13 mar 2000
    In corso
    Importo garantito
    £14,777 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The chargors interest in the deposit account opened by the chargee at hsbc bank.
    Persone aventi diritto
    • Taylor Woodrow Developments Limited
    Transazioni
    • 13 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 22 feb 2000
    Consegnato il 13 mar 2000
    In corso
    Importo garantito
    £29,554 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The chargors interest in the deposit account opened by the chargee at hsbc bank.
    Persone aventi diritto
    • Taylor Woodrow Developments Limited
    Transazioni
    • 13 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 15 nov 1995
    Consegnato il 02 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a lease dated 19/8/92
    Brevi particolari
    The initial sum of £9,600 held as stakeholders by bates & partners of bartya house. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ian Bernard Woolf
    Transazioni
    • 02 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 15 nov 1995
    Consegnato il 30 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £9,600 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The sum of £9,600 and interest thereon held in a deposit account at barclays bank PLC.
    Persone aventi diritto
    • Ian Bernard Woolf
    Transazioni
    • 30 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    SCHOICE EUROPE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 giu 2012Data della riunione per approvare il CVA
    20 ago 2012Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Dixon Fleming
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Praticante
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0