THE LOCUM GROUP LIMITED

THE LOCUM GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE LOCUM GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03020008
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE LOCUM GROUP LIMITED?

    • Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. (74909) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
    • Altre attività delle agenzie di collocamento (78109) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova THE LOCUM GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Academy Court
    94 Chancery Lane
    WC2A 1DT London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE LOCUM GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MERRINWORTH LIMITED09 feb 199509 feb 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE LOCUM GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per THE LOCUM GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 feb 2016

    Stato del capitale al 10 feb 2016

    • Capitale: GBP 6,007,500
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 09 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 feb 2015

    Stato del capitale al 12 feb 2015

    • Capitale: GBP 6,007,500
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2014

    4 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2013

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 feb 2014

    Stato del capitale al 17 feb 2014

    • Capitale: GBP 6,007,500
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2012

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    1 pagineCC04

    Risoluzioni

    Resolutions
    34 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 09 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Academy Court, Third Floor 94 Chancery Lane London WC2A 1DT* in data 13 feb 2012

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2011

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Joan Edmunds il 15 feb 2011

    1 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2010

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Derek Beal come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr James Andrew Reed come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 27 giu 2009

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2008 al 30 giu 2009

    1 pagineAA01

    Chi sono gli amministratori di THE LOCUM GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EDMUNDS, Joan
    94 Chancery Lane
    WC2A 1DT London
    Academy Court
    United Kingdom
    Segretario
    94 Chancery Lane
    WC2A 1DT London
    Academy Court
    United Kingdom
    British18978230001
    REED, James Andrew
    94 Chancery Lane
    WC2A 1DT London
    Academy Court
    United Kingdom
    Amministratore
    94 Chancery Lane
    WC2A 1DT London
    Academy Court
    United Kingdom
    EnglandBritish84718880002
    CARTER, Adrian John
    Linton House
    Hopping Jacks Lane, Danbury
    CM3 4PJ Chelmsford
    Essex
    Segretario
    Linton House
    Hopping Jacks Lane, Danbury
    CM3 4PJ Chelmsford
    Essex
    British49358790006
    CHAPMAN, Peter
    52 Braeburn Way
    Kings Hill
    ME19 4BY West Malling
    Kent
    Segretario
    52 Braeburn Way
    Kings Hill
    ME19 4BY West Malling
    Kent
    British85205140001
    CHICK, Lesley Anne
    4 The Terrace
    Folly Lane
    BS25 1TE Shipham
    Winscombe
    North Somerset
    Segretario nominato
    4 The Terrace
    Folly Lane
    BS25 1TE Shipham
    Winscombe
    North Somerset
    British900008230001
    HARA, Balbir
    30 Highcliffe Gardens
    IG4 5HR Ilford
    Essex
    Segretario
    30 Highcliffe Gardens
    IG4 5HR Ilford
    Essex
    British54925610001
    WYNN, Martin Stuart
    Fernbank East Street
    Rusper
    RH12 4RE Horsham
    West Sussex
    Segretario
    Fernbank East Street
    Rusper
    RH12 4RE Horsham
    West Sussex
    British37363980002
    BEAL, Derek George
    The Crest 1 Highview Place
    Arterberry Road
    SW20 8AL London
    Amministratore
    The Crest 1 Highview Place
    Arterberry Road
    SW20 8AL London
    EnglandBritish16866760004
    CONNELL, Richard Andrew
    Lower Roundhurst
    Tennyson's Lane Roundhurst
    GU27 3BN Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Lower Roundhurst
    Tennyson's Lane Roundhurst
    GU27 3BN Haslemere
    Surrey
    United KingdomBritish102127970001
    COX, Gary Alan
    36 Rosslyn Park
    KT13 9QZ Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    36 Rosslyn Park
    KT13 9QZ Weybridge
    Surrey
    EnglandBritish85047330001
    DAEL, Susan
    18 Halidon Rise
    Harold Park
    RM3 0YL Romford
    Essex
    Amministratore
    18 Halidon Rise
    Harold Park
    RM3 0YL Romford
    Essex
    British74826250002
    DOYLE, Desmond Mark Christopher
    Woodlawn House
    Arrow Lane, Hartley Witney
    RG27 8LR Hook
    Hampshire
    Amministratore
    Woodlawn House
    Arrow Lane, Hartley Witney
    RG27 8LR Hook
    Hampshire
    British88770150001
    ECHTLE, Christa Iris
    9 Old Palace Lane
    TW9 1PG Richmond
    Surrey
    Amministratore
    9 Old Palace Lane
    TW9 1PG Richmond
    Surrey
    British39803450001
    FENNELL, David Michael
    The Laurels
    Maple Court Rodmersham
    ME9 0LR Sittingbourne
    Kent
    Amministratore
    The Laurels
    Maple Court Rodmersham
    ME9 0LR Sittingbourne
    Kent
    EnglandBritish108942680001
    FURNISS, Ian William
    Middle Field
    2 Woodlands Close
    NR25 6DU Holt
    Norfolk
    Amministratore
    Middle Field
    2 Woodlands Close
    NR25 6DU Holt
    Norfolk
    EnglandBritish117943650001
    GARRATT, Mark Jonathan
    21 Stradella Road
    Herne Hill
    SE24 9HN London
    Amministratore
    21 Stradella Road
    Herne Hill
    SE24 9HN London
    EnglandBritish118003050001
    GOUL-WHEEKER, Trevor Robert Ogilvie
    La Petite Sevelotte
    15, The Park
    KT23 3LN Bookham
    Surrey
    Amministratore
    La Petite Sevelotte
    15, The Park
    KT23 3LN Bookham
    Surrey
    EnglandBritish102096180002
    GUNN, Dorothy Patricia
    36 Brunswick Gardens
    Hainault
    IG6 2QU Ilford
    Essex
    Amministratore
    36 Brunswick Gardens
    Hainault
    IG6 2QU Ilford
    Essex
    British49390740001
    HARPER, Paul Stephen
    Drey Cottage 15 Firs Walk
    Tewin Wood
    AL6 0NY Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    Drey Cottage 15 Firs Walk
    Tewin Wood
    AL6 0NY Welwyn
    Hertfordshire
    British64302310001
    HARTOP, Barry
    Field Cottage
    The Ridgeway
    GU1 2DG Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Field Cottage
    The Ridgeway
    GU1 2DG Guildford
    Surrey
    EnglandBritish67432850001
    MEIGHAN, Julia
    3a Spareleaze Hill
    IG10 1BS Loughton
    Essex
    Amministratore
    3a Spareleaze Hill
    IG10 1BS Loughton
    Essex
    British30536990002
    MORRIS, Angela Smith
    14 Moor Lane
    GU22 9QY Woking
    Surrey
    Amministratore
    14 Moor Lane
    GU22 9QY Woking
    Surrey
    EnglandBritish75022250001
    NEALE, Frank Leslie George
    Archway House 53 The Avenue
    WD17 4NU Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Archway House 53 The Avenue
    WD17 4NU Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritish4554050001
    NICHOLLS, Nigel Philip
    46 Tollgate Road
    Colney Heath
    AL4 0PY St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    46 Tollgate Road
    Colney Heath
    AL4 0PY St Albans
    Hertfordshire
    British5999120002
    NICHOLSON, William
    2a Ashbridge Road
    Leytonstone
    E11 1NH London
    Amministratore
    2a Ashbridge Road
    Leytonstone
    E11 1NH London
    British74826470002
    PEACOCK, Teresa
    39 Bridport Way
    Kings Park Village
    CM7 9FJ Braintree
    Essex
    Amministratore
    39 Bridport Way
    Kings Park Village
    CM7 9FJ Braintree
    Essex
    British44331460002
    RAWORTH, Richard
    7 St Georges Road
    St Margarets
    TW1 1QS Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    7 St Georges Road
    St Margarets
    TW1 1QS Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish1506920001
    REDDING, Diana Elizabeth
    Rainbow House
    Oakridge Lane Sidcot
    BS25 1LZ Winscombe
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Rainbow House
    Oakridge Lane Sidcot
    BS25 1LZ Winscombe
    Avon
    EnglandBritish900004650001
    WYNN, Martin Stuart
    Fernbank East Street
    Rusper
    RH12 4RE Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Fernbank East Street
    Rusper
    RH12 4RE Horsham
    West Sussex
    United KingdomBritish37363980002

    Chi sono le persone con controllo significativo di THE LOCUM GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Reed Healthcare Limited
    94 Chancery Lane
    WC2A 1DT London
    Academy Court
    England
    06 apr 2016
    94 Chancery Lane
    WC2A 1DT London
    Academy Court
    England
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Autorità legaleEnglish Law
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    THE LOCUM GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 04 lug 2002
    Consegnato il 24 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage of life policy
    Creato il 07 set 1999
    Consegnato il 14 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies accruing under the policy of insurance dated 10.2.99 policy number x 68381609 on the life of d m r fennell with standard life assurance company.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 07 ago 1996
    Consegnato il 19 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    2 ordinary shares of £1.00 each (the shares) in the capital of L.G. international employment services limited including all dividends bonuses rights and benefits attaching to or arising in respect thereof.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 07 ago 1996
    Consegnato il 19 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    2 ordinary shares of £1.00 each (the shares) in the capital of L.G. international employment services limited including all dividends bonuses rights and benefits attaching to or arising in respect thereof.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transazioni
    • 19 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 26 giu 1995
    Consegnato il 08 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All dividends, bonuses, rights and benefits in respect of the 100 ordinary shares of £1.00 each in the capital of caroline pelham limited and all beneficial interests therein and to any proceeds of sale.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 26 giu 1995
    Consegnato il 08 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 26 giu 1995
    Consegnato il 08 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All dividends, bonuses, rights and benefits in respect of the 100 ordinary shares of £1.00 each in the capital of caroline pelham limited and all beneficial interests of the company therein and to any proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transazioni
    • 08 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 26 giu 1995
    Consegnato il 08 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transazioni
    • 08 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0