GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED

GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03020221
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o R P RENDLE & CO LIMITED
    9 Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    West Midlands
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LANDMARK CARE FACILITIES LIMITED21 feb 200221 feb 2002
    COMMUNITY DEVELOPMENTS LIMITED30 apr 199830 apr 1998
    STOPPA LIMITED17 nov 199517 nov 1995
    MARKETEL LIMITED09 feb 199509 feb 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 11 dic 2013

    14 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    15 pagine4.71

    Certificato che i creditori sono stati pagati per intero

    2 pagine4.51

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Indirizzo della sede legale modificato da * 4Th Floor 3-5 Swallow Place London W1B 2AF* in data 06 dic 2012

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Anton David Curtis il 11 ott 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Anton David Curtis il 11 ott 2012

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jeremy Ungelson il 08 ott 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 09 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 mar 2012

    Stato del capitale al 08 mar 2012

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2009

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 12-14 St Christopher's Place London W1U 1NB* in data 25 feb 2010

    2 pagineAD01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2009 al 31 dic 2009

    3 pagineAA01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2008

    9 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    3 pagine395

    legacy

    3 pagine395

    legacy

    3 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CURTIS, Anton David
    c/o R P Rendle & Co Limited
    Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    9
    West Midlands
    United Kingdom
    Segretario
    c/o R P Rendle & Co Limited
    Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    9
    West Midlands
    United Kingdom
    British115446010001
    CURTIS, Anton David
    c/o R P Rendle & Co Limited
    Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    9
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o R P Rendle & Co Limited
    Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    9
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish151245590002
    UNGELSON, Jeremy
    c/o R P Rendle & Co Limited
    Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    9
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o R P Rendle & Co Limited
    Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    9
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish125304300002
    CLARKE, Rachel Ann
    5 Longridge Avenue
    NE7 7LB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    5 Longridge Avenue
    NE7 7LB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British81840100001
    FRANCIS, Hugh
    40 Topstreet Way
    AL5 5TT Harpenden
    Segretario
    40 Topstreet Way
    AL5 5TT Harpenden
    English40354440003
    MATTHEWS, Ian
    Ffordd Bryngwyn
    Gwernymynydd
    CH7 5JW Nr Mold
    The Croft
    Flintshire
    Segretario
    Ffordd Bryngwyn
    Gwernymynydd
    CH7 5JW Nr Mold
    The Croft
    Flintshire
    British143242660001
    MCCAFFERTY, Mark John
    16 Gowan Terrace
    Jesmond
    NE2 2PS Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    16 Gowan Terrace
    Jesmond
    NE2 2PS Newcastle Upon Tyne
    British81370550001
    MCLEISH, William David
    26 Newtyle Road
    Ralston
    PA1 3JX Paisley
    Renfrewshire
    Segretario
    26 Newtyle Road
    Ralston
    PA1 3JX Paisley
    Renfrewshire
    British168970640001
    MICHELSON, Allan Denis
    33 North Avenue
    Gosforth
    NE3 4DQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    33 North Avenue
    Gosforth
    NE3 4DQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British13305820001
    MISTRY, Yogeshkumar Kanchanlal
    38 Fairford Avenue
    LU2 7ER Luton
    Bedfordshire
    Segretario
    38 Fairford Avenue
    LU2 7ER Luton
    Bedfordshire
    British73852970001
    RILEY, Michelle
    2 Camberwell Close
    NE11 9TZ Gateshead
    Tyne & Wear
    Segretario
    2 Camberwell Close
    NE11 9TZ Gateshead
    Tyne & Wear
    British52057290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    FRANCIS, Hugh
    40 Topstreet Way
    AL5 5TT Harpenden
    Amministratore
    40 Topstreet Way
    AL5 5TT Harpenden
    EnglandEnglish40354440003
    LEWIS, Gary Owen
    Mount Farm
    Eighton Banks
    NE9 7YP Gateshead
    Amministratore
    Mount Farm
    Eighton Banks
    NE9 7YP Gateshead
    British51006650004
    LEWIS, Gary Owen
    Valemount Eighton Banks
    NE9 7YL Gateshead
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Valemount Eighton Banks
    NE9 7YL Gateshead
    Tyne & Wear
    British51006650001
    LEWIS, Gary Owen
    4 Larwood Court
    DH3 3QQ Chester Le Street
    County Durham
    Amministratore
    4 Larwood Court
    DH3 3QQ Chester Le Street
    County Durham
    British41951370002
    LEWIS, Joanne Lynn
    17 Bewicke View
    DH3 1RU Birtley
    Amministratore
    17 Bewicke View
    DH3 1RU Birtley
    British41951380004
    MATTHEWS, Ian
    Ffordd Bryngwyn
    Gwernymynydd
    CH7 5JW Nr Mold
    The Croft
    Flintshire
    Amministratore
    Ffordd Bryngwyn
    Gwernymynydd
    CH7 5JW Nr Mold
    The Croft
    Flintshire
    United KingdomBritish143242660001
    MCCAFFERTY, Mark John
    16 Gowan Terrace
    Jesmond
    NE2 2PS Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    16 Gowan Terrace
    Jesmond
    NE2 2PS Newcastle Upon Tyne
    British81370550001
    MCGRATH, Kay
    23 Hazelmoor
    NE31 1DH Hebburn
    Tyne & Wear
    Amministratore
    23 Hazelmoor
    NE31 1DH Hebburn
    Tyne & Wear
    British103145700001
    MURPHY, John
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    Amministratore
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    British26177180002
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Amministratore
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    STROWBRIDGE, John Michael Barrie
    Keepers Lodge
    Hollowell Reservoir Hollowell
    NN6 8RL Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Keepers Lodge
    Hollowell Reservoir Hollowell
    NN6 8RL Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish157860840001

    GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of legal charge
    Creato il 14 nov 2007
    Consegnato il 23 nov 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from citrus healthcare limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the north west side of chester row shiney row sunderland t/no TY94518 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    Transazioni
    • 23 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of assignment
    Creato il 14 nov 2007
    Consegnato il 23 nov 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from citrus healthcare limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the leases in respect of f/h land and buildings on the north west side of chester row shiney row sunderland t/no TY94518. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    Transazioni
    • 23 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    An amendment and restatement deed to a debenture dated 10 march 2006 and
    Creato il 30 giu 2006
    Consegnato il 17 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC, in Its Capacity as Security Trustee for and on Behalf of They Trustee)
    • The Royal Bank of Scotland PLC, in Its Capacity as Security Trustee for and on Behalf of Thefinance Parties and Secured Parties (The Securit
    Transazioni
    • 17 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession
    Creato il 02 mag 2006
    Consegnato il 04 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company to the chargee or the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Mill lodge care centre 1A moorside place bradford west yorkshire t/n WYK677390 and WYK730706, crabwall hall residential home parkgate road millington chester t/n's CH246622 CH305068 and CH334555, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Graphite Capital Management LLP
    Transazioni
    • 04 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 11 apr 2006
    Consegnato il 21 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company to the security beneficiaries (or any of them) or to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H & l/h mill lodge care centre, 1A moorside place, bradford, west yorkshire t/nos. WYK677390 and WYK730706. F/h & l/hcrabwell hall residential home, parkgate road, mollington, chester t/nos. CH2466. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mr John Strowbridge (The "Trustee")
    Transazioni
    • 21 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Accession deed
    Creato il 11 apr 2006
    Consegnato il 26 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company to the finance parties and/or any receiver or any other person or persons on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property k/a grangewood care centre, chester road, shiney row, tyne and. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland as Security for and on Behalf of the Finance Parties (The Securitytrustee)
    • The Royal Bank of Scotland as Security for and on Behalf of the Finance Parties (The Securitytrustee)
    Transazioni
    • 26 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 ago 2004
    Consegnato il 17 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 apr 2003
    Consegnato il 19 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a former grangewood service station chester road shiney row sunderland tyne and wear t/no: TY94518.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 giu 1998
    Consegnato il 24 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land situate near radford avenue and baxter avenue kidderminster t/n-WR30985.. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 giu 1998
    Consegnato il 24 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H all that parcel of land situate at pershore road selly park birmingham west midlands t/nos: WM211875 and WM519519.. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GRANGEWOOD CARE CENTRE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 mag 2014Data di scioglimento
    12 dic 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Paul Rendle
    9 Hockley Court
    Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    Praticante
    9 Hockley Court
    Hockley Heath
    B94 6NW Solihull

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0