ABLEX LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàABLEX LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03020801
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ABLEX LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova ABLEX LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ABLEX LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ABLEX AUDIO VIDEO LIMITED05 apr 199505 apr 1995
    BROOMCO (874) LIMITED13 feb 199513 feb 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di ABLEX LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per ABLEX LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 14 ott 2011

    8 pagine4.68

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 15 ott 2010

    LRESSP

    Indirizzo della sede legale modificato da Building 3 Windrush Park Burford Road Witney Oxfordshire OX29 7EW in data 28 ott 2010

    2 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 feb 2010

    Stato del capitale al 17 feb 2010

    • Capitale: GBP 375,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    9 pagineAA

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio modificato redatto al 31 dic 2006

    6 pagineAAMD

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    6 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    8 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    6 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2003

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ABLEX LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PITT, Arthur Ronald John
    125 Hambleton Road
    B63 1JT Halesowen
    West Midlands
    Segretario
    125 Hambleton Road
    B63 1JT Halesowen
    West Midlands
    British31011970001
    ALTING VON GEUSAU, Michiel
    Marktplein 5
    5296 NA Esch
    5296 Na
    The Netherlands
    Amministratore
    Marktplein 5
    5296 NA Esch
    5296 Na
    The Netherlands
    NetherlandsDutch63040700002
    PITT, Arthur Ronald John
    125 Hambleton Road
    B63 1JT Halesowen
    West Midlands
    Amministratore
    125 Hambleton Road
    B63 1JT Halesowen
    West Midlands
    EnglandBritish31011970001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001
    BANKS, Malcolm James Peter
    2 Ryelands Gardens
    WV16 5BG Bridgnorth
    Salop
    Amministratore
    2 Ryelands Gardens
    WV16 5BG Bridgnorth
    Salop
    British31011990001
    EALES, Darryl Charles
    7 Sycamore Drive
    Hollywood
    B47 5QX Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    7 Sycamore Drive
    Hollywood
    B47 5QX Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritish2886080001
    LEWIS, Alan Laurence
    Oakbank
    Weston Lullingfields
    SY4 2AD Shrewsbury
    Shropshire
    Amministratore
    Oakbank
    Weston Lullingfields
    SY4 2AD Shrewsbury
    Shropshire
    British50866840001
    MAJOR, Martine
    3 The Courtyard Hall Lane
    Ackleton
    WV6 7JJ Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    3 The Courtyard Hall Lane
    Ackleton
    WV6 7JJ Wolverhampton
    West Midlands
    British56957330001
    MCEWEN, Stephen John
    51 Springhill Park
    Lower Penn
    WV4 4TR Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    51 Springhill Park
    Lower Penn
    WV4 4TR Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritish2331520001
    METCALF, John Everett
    White House 65 Birmingham Road
    Shenstone Wood End
    WS14 0LQ Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    White House 65 Birmingham Road
    Shenstone Wood End
    WS14 0LQ Lichfield
    Staffordshire
    British66557750001
    SHAKESPEARE, Howard Leslie
    Covert Cottage
    3 Covert Lane Chelmarsh
    WV16 6BH Bridgnorth
    Salop
    Amministratore
    Covert Cottage
    3 Covert Lane Chelmarsh
    WV16 6BH Bridgnorth
    Salop
    British127281880001
    TOMPSETT, Rodney Graham
    11 Chatsworth Gardens
    Keepers Gate Tettenhall
    WV6 8UU Wolverhampton
    Amministratore
    11 Chatsworth Gardens
    Keepers Gate Tettenhall
    WV6 8UU Wolverhampton
    British30964760002
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003800001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001

    ABLEX LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Chattels mortgage
    Creato il 07 lug 1998
    Consegnato il 07 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    One new heino islemann kcd 4 packing machine serial no. 98:28341. one new heino islemann cm 3 wrapping machine serial no. 98:29732.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Group Limited
    Transazioni
    • 07 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 set 1995
    Consegnato il 13 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 13 set 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 03 apr 1995
    Consegnato il 19 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as broomco (874) limited) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ott 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 13 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Loan agreement
    Creato il 03 apr 1995
    Consegnato il 13 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £500,000 due or to become due from the company formerly known as broomco (874) limited to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Racal Electronics PLC
    Transazioni
    • 13 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 apr 1995
    Consegnato il 06 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as broomco (874) limited) to the chargee under the terms of a loan agreement of even date
    Brevi particolari
    L/H unit g halesfield 14 telford shropshire together with all buildings and fixtures and fixed plant and machinery therein. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Development Capital Limited
    Transazioni
    • 06 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ABLEX LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    25 lug 2012Data di scioglimento
    15 ott 2010Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Praticante
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0