SERVASSURE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSERVASSURE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03021117
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SERVASSURE LIMITED?

    • (6420) /

    Dove si trova SERVASSURE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Greenway House
    Greenway Business Park
    CM19 5QD Pinnacles, Harlow
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SERVASSURE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STERRY COMMUNICATIONS (UK) LIMITED25 apr 199525 apr 1995
    NEMOURE LIMITED13 feb 199513 feb 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di SERVASSURE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per SERVASSURE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    6 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    10 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed sterry communications (uk) limit ed\certificate issued on 18/02/08
    2 pagineCERTNM

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    5 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine190

    Chi sono gli amministratori di SERVASSURE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WEST, Michael David
    6 Woodside Place
    Wildhill Road Woodside
    AL9 6DN Hatfield
    Hertfordshire
    Segretario
    6 Woodside Place
    Wildhill Road Woodside
    AL9 6DN Hatfield
    Hertfordshire
    British112844320001
    WEST, Michael David
    6 Woodside Place
    Wildhill Road Woodside
    AL9 6DN Hatfield
    Hertfordshire
    Segretario
    6 Woodside Place
    Wildhill Road Woodside
    AL9 6DN Hatfield
    Hertfordshire
    British112844320001
    KEAN, Scott Charles
    39 Lawrence Moorings
    CM21 9PE Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    39 Lawrence Moorings
    CM21 9PE Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    British80444700003
    BULTITUDE, David John, Mr.
    The Old Cottage Bucks Hill
    Watford
    WD4 9AE Kings Langley
    Hertfordshire
    Segretario
    The Old Cottage Bucks Hill
    Watford
    WD4 9AE Kings Langley
    Hertfordshire
    British61307690002
    HENWOOD, Julian Richard
    8 Brickyard Close
    CV7 7EN Balsall Common
    Warwickshire
    Segretario
    8 Brickyard Close
    CV7 7EN Balsall Common
    Warwickshire
    British65188860002
    POWER, Mark Peter
    8 Whitewillow Close
    Failsworth
    M35 9GG Manchester
    Segretario
    8 Whitewillow Close
    Failsworth
    M35 9GG Manchester
    British24900380002
    WILKINSON, Alexander Mcnish
    71 Mount Pleasant Village
    Nangreaves
    BL9 6SP Bury
    Lancashire
    Segretario
    71 Mount Pleasant Village
    Nangreaves
    BL9 6SP Bury
    Lancashire
    British76710610001
    WOODBRIDGE, Mark Gavin
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    Segretario
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    British74738270002
    CMH SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Segretario nominato
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000940001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Segretario
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    BLOOMFIELD, Garry James
    Lower Ridge Farm
    Plucksbridge Road
    SK6 7DY Marple
    Cheshire
    Amministratore
    Lower Ridge Farm
    Plucksbridge Road
    SK6 7DY Marple
    Cheshire
    EnglandBritish43196770002
    DICKER, Timothy Stanley
    260 Rayleigh Road
    SS9 5XL Leigh On Sea
    Essex
    Amministratore
    260 Rayleigh Road
    SS9 5XL Leigh On Sea
    Essex
    British98850820001
    FOX, John Martin
    The Haven
    Carters Lane
    CM22 6AQ Henham
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Haven
    Carters Lane
    CM22 6AQ Henham
    Hertfordshire
    Great BritainBritish127207050001
    FREEMAN, William Ian Bede
    Herons Cottage
    Ferry Lane, Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Herons Cottage
    Ferry Lane, Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish64442870001
    GLOVER, Michael John
    Commerce House
    2-6 Bath Street
    Slough
    Berkshire
    Amministratore
    Commerce House
    2-6 Bath Street
    Slough
    Berkshire
    British2239730001
    KEEVIL, Geoffrey Charles
    65 Shepherds Lane
    HP9 2DU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    65 Shepherds Lane
    HP9 2DU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British19845180001
    TUPMAN, Timothy Alexander
    Highlands
    Berden
    CM23 1AB Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Highlands
    Berden
    CM23 1AB Bishops Stortford
    Hertfordshire
    EnglandBritish67184090006
    WILKINSON, Alexander Mcnish
    71 Mount Pleasant Village
    Nangreaves
    BL9 6SP Bury
    Lancashire
    Amministratore
    71 Mount Pleasant Village
    Nangreaves
    BL9 6SP Bury
    Lancashire
    British76710610001
    WOODBRIDGE, Mark Gavin
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    The Bungalow
    Marton
    CV23 9RS Rugby
    Warwickshire
    British74738270002
    CMH DIRECTORS LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Amministratore delegato nominato
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000930001
    CMH SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    Amministratore delegato nominato
    Mitre House
    160 Aldergate Street
    EC1A 4DD London
    900000940001

    SERVASSURE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 24 mar 2000
    Consegnato il 14 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and all monies and liabilities due or to become due from sterry group limited, sterry holdings limited and the company to the chargee on any account whatsoever in accordance with the terms of the deferred consideration agreement dated on or around 24TH march 2000
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • !Siemens Communications Limited
    Transazioni
    • 14 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 22 nov 1999
    Consegnato il 02 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 nov 1999
    Consegnato il 29 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 29 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 mag 1995
    Consegnato il 11 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 02 mag 1995
    Consegnato il 11 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of assignment any monies payable to the bank for or in connection with the disposal (by way of sale or otherwise) of any chattels the chattels :-nom code 70182 pd no 08/93 invoice date FEB93 internal ref 210762 invoice VALUE6,270,00 david polland asset description 610MB 498/33. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0