REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03021292 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Central House Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate North Yorkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| REDSTONE COMMUNICATIONS LIMITED | 06 feb 2002 | 06 feb 2002 |
| REDSTONE NETWORK SERVICES LIMITED | 17 dic 2001 | 17 dic 2001 |
| REDSTONE COMMUNICATIONS LIMITED | 21 dic 2000 | 21 dic 2000 |
| REDSTONE NETWORK SERVICES LIMITED | 14 feb 1995 | 14 feb 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 10 dic 2020
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Dean Anthony Barber come amministratore in data 03 apr 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 feb 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Dean Anthony Barber come amministratore in data 02 set 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 feb 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Peter Brotherton come segretario in data 03 set 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Nomina di Harneet Jagpal come segretario in data 03 set 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Fraser St John Fisher come amministratore in data 20 ott 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Peter James Brotherton come amministratore in data 28 nov 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Peter Brotherton come segretario in data 28 nov 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Timothy James Coleman come amministratore in data 06 nov 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Timothy James Coleman come segretario in data 06 nov 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGPAL, Harneet | Segretario | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | 250198230001 | |||||||
| BROTHERTON, Peter James | Amministratore | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | England | British | 116701310002 | |||||
| BRACHER, Alan Richard | Segretario | 53 Foley Road KT10 0LU Claygate Surrey | British | 36451680001 | ||||||
| BROTHERTON, Peter | Segretario | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | 220552440001 | |||||||
| COLEMAN, Timothy James | Segretario | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | 210014290001 | |||||||
| CROFT, Estelle Louise | Segretario | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire England | 195008160001 | |||||||
| HARROLD, Alan Henry | Segretario | Cherry Tree House The Drive SL8 5RE Bourne End Buckinghamshire | British | 88772110001 | ||||||
| HAYES, Peter Andrew | Segretario | Cambridge Business Park, Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Newton House United Kingdom | 164939920001 | |||||||
| HAYES, Peter Andrew | Segretario | 2 Somersby Crescent SL6 3YY Maidenhead Berkshire | British | 66610550002 | ||||||
| MYHILL, Paul Harvey | Segretario | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire England | 175306270001 | |||||||
| O'RORKE, Nicholas | Segretario | Slade Farm Kirtlington OX5 3JA Kidlington Building B-Office 10 Kirtlington Business Centre Oxfordshire | 149441960001 | |||||||
| VAN DEN HEUVEL, Christopher Edward Francis, Mr. | Segretario | 7 Hawkes Leap GU20 6JL Windlesham Surrey | British | 80721980001 | ||||||
| BALAAM, Martin Anthony | Amministratore | The Laurels Coole Lane CW5 8AY Nantwich Cheshire | United Kingdom | British | 82233550001 | |||||
| BARBER, Dean Anthony | Amministratore | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | England | British | 230739040001 | |||||
| BROWN, Ian Christopher | Amministratore | Fox Hollow Westwood Road GU20 6LX Windlesham Surrey | England | British | 75493580001 | |||||
| BRUCE, Robert David Glenrinnes | Amministratore | 45 Gally Hill Road Church Crookham GU13 0QE Fleet Hampshire | British | 66210170001 | ||||||
| BYAM SHAW, Justin David Elliott | Amministratore | 6 Westbourne Park Road W2 5PH London | British | 40017100001 | ||||||
| CARRINGTON, John Christopher | Amministratore | 1 Anchor Brewhouse 50 Shad Thames SE1 2LY London | United Kingdom | British | 79087670001 | |||||
| CHATFIELD, Paul | Amministratore | 21 Ludlow Avenue WR4 0EN Worcester Worcestershire | British | 71912610001 | ||||||
| COLEMAN, Timothy James | Amministratore | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire England | United Kingdom | British | 163698620001 | |||||
| COVE, Graham Lawrence | Amministratore | 2 White House Close SG14 3TW Watton At Stone Hertfordshire | England | British | 45340010002 | |||||
| COX, David Howard | Amministratore | Waverley Chenies Road Chorleywood WD3 5LU Rickmansworth Hertfordshire | United Kingdom | British | 100698330001 | |||||
| CUSHING, Robert Sefton | Amministratore | 66 Columbia Place Fornham Street S2 4AR Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | 117325300001 | |||||
| DAWSON, John Hugh | Amministratore | Ashleigh Grenofen PL19 9EW Tavistock Devon | England | British | 59251210001 | |||||
| DEANE, Keith | Amministratore | 2 Westminster Close GU51 4NR Fleet Hampshire | England | British | 85309310001 | |||||
| DONNELLY, Mary Kathleen | Amministratore | Prospect House 1a Prospect Row CB1 1DU Cambridge | England | British | 85309000001 | |||||
| DOUGHTY, Royston George | Amministratore | 60 Cedars Road Hampton Wick KT1 4BE Kingston Upon Thames Surrey | British | 6194830001 | ||||||
| DOWNHAM, Robert Henry | Amministratore | Spring Cottage The Common DT11 8QY Blandford Forum Dorset | British | 98701880001 | ||||||
| FISHER, Fraser St John | Amministratore | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | England | British | 72704710002 | |||||
| GRAY, Christopher Robert | Amministratore | 15 Vale Close Lower Bourne GU10 3HR Farnham Surrey | United Kingdom | British | 23552180001 | |||||
| HALLETT, Peter John | Amministratore | Cambridge Business Park, Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Newton House United Kingdom | United Kingdom | British | 20621770002 | |||||
| HARROLD, Alan Henry | Amministratore | Cherry Tree House The Drive SL8 5RE Bourne End Buckinghamshire | England | British | 88772110001 | |||||
| LANCH, Nigel Leslie | Amministratore | Willow Cottage 19 Water Lane KT11 2PA Cobham Surrey | British | 54508950001 | ||||||
| MCGOUGAN, Malcolm James Andrew | Amministratore | 33 Shrub End Road CO3 3UD Colchester Essex | British | 44066820001 | ||||||
| MOONEY, Jeremy | Amministratore | 135 Victoria Road N22 7XH London | British | 71912690001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redcentric Holdings Limited | 06 apr 2016 | Otley Road HG3 1UG Harrogate Central House England | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 20 dic 2013 Consegnato il 08 gen 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Ground floor, building no. 3 (newton house), the cambridge business park, milton road, cambridge t/no CB340008. Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Group debenture | Creato il 21 giu 2012 Consegnato il 29 giu 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to each present and future secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over shares | Creato il 24 feb 2009 Consegnato il 27 feb 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first fixed charge the charged securities, any related rights, dividends, see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 01 ott 2006 Consegnato il 13 ott 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 05 lug 2005 Consegnato il 26 lug 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed | Creato il 24 lug 2002 Consegnato il 13 ago 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £22,500.00 and all further moneys due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Deposit of £22,500 and all other moneys and interest thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed | Creato il 24 lug 2002 Consegnato il 13 ago 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £12,500.00 and all further moneys due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari £12,500 deposit with all other moneys and interest thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed | Creato il 24 lug 2002 Consegnato il 13 ago 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £15,000.00 and all further moneys due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari £15,000 deposit and all other moneys demanded and all interest thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 09 mag 2001 Consegnato il 15 mag 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease granted on the same date as the deed | |
Brevi particolari The deposit is defined in the deed as the sum or sums standing to the credit of the account including an initial deposit of £25,375,00 paid by the tenant under the deed, any renewal or replacement of these sums, all interest earned on the account and all entitlements, rights and benefits accruing directly or indirectly to the account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 21 ago 2000 Consegnato il 24 ago 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and lease of even date relating to the property known as third floor unit b south herts office campus borehamwood | |
Brevi particolari A deposit of £33,876 and accruing interest. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 15 ago 2000 Consegnato il 25 ago 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities of the obligors to the chargee under each of the finance documents | |
Brevi particolari All right title and interest in and to the equipment all benefits in respect of the insurances and all proceeds thereof for full details and definitions please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 28 giu 2000 Consegnato il 18 lug 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease | |
Brevi particolari The tenant charges its interest in the deposit balance. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit | Creato il 08 mar 2000 Consegnato il 28 mar 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The sum of £61,117 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The sum. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deposit deed | Creato il 16 lug 1998 Consegnato il 18 lug 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The due compliance of the company's obligations with the chargee under the lease dated 16TH july 1998 | |
Brevi particolari The sum of £27,354.25 deposited at the royal bank of scotland PLC 67 lombard street london together with any interest accrued. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 04 set 1997 Consegnato il 10 set 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 03 ott 1996 Consegnato il 17 ott 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 17 apr 1996 Consegnato il 25 apr 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £482,925 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Three okeford switches. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deposit deed | Creato il 27 feb 1996 Consegnato il 28 feb 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 27TH february 1996 | |
Brevi particolari Deposit of £18,175 maintained at the royal bank of scotland PLC 67 lombard street london tigether with all interest accruing. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0