REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED

REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàREDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03021292
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Central House
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    North Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    REDSTONE COMMUNICATIONS LIMITED06 feb 200206 feb 2002
    REDSTONE NETWORK SERVICES LIMITED17 dic 200117 dic 2001
    REDSTONE COMMUNICATIONS LIMITED 21 dic 200021 dic 2000
    REDSTONE NETWORK SERVICES LIMITED14 feb 199514 feb 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Stato del capitale al 10 dic 2020

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account be cancelled 18/11/2020
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Dean Anthony Barber come amministratore in data 03 apr 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 feb 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Dean Anthony Barber come amministratore in data 02 set 2019

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 feb 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Peter Brotherton come segretario in data 03 set 2018

    1 pagineTM02

    Nomina di Harneet Jagpal come segretario in data 03 set 2018

    2 pagineAP03

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Fraser St John Fisher come amministratore in data 20 ott 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Mr Peter James Brotherton come amministratore in data 28 nov 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Peter Brotherton come segretario in data 28 nov 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Timothy James Coleman come amministratore in data 06 nov 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Timothy James Coleman come segretario in data 06 nov 2016

    1 pagineTM02

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2016

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JAGPAL, Harneet
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Segretario
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    250198230001
    BROTHERTON, Peter James
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Amministratore
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    EnglandBritish116701310002
    BRACHER, Alan Richard
    53 Foley Road
    KT10 0LU Claygate
    Surrey
    Segretario
    53 Foley Road
    KT10 0LU Claygate
    Surrey
    British36451680001
    BROTHERTON, Peter
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Segretario
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    220552440001
    COLEMAN, Timothy James
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Segretario
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    210014290001
    CROFT, Estelle Louise
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    Segretario
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    195008160001
    HARROLD, Alan Henry
    Cherry Tree House
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    Segretario
    Cherry Tree House
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    British88772110001
    HAYES, Peter Andrew
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Segretario
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    164939920001
    HAYES, Peter Andrew
    2 Somersby Crescent
    SL6 3YY Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    2 Somersby Crescent
    SL6 3YY Maidenhead
    Berkshire
    British66610550002
    MYHILL, Paul Harvey
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    Segretario
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    175306270001
    O'RORKE, Nicholas
    Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B-Office 10 Kirtlington Business Centre
    Oxfordshire
    Segretario
    Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B-Office 10 Kirtlington Business Centre
    Oxfordshire
    149441960001
    VAN DEN HEUVEL, Christopher Edward Francis, Mr.
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    Segretario
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    British80721980001
    BALAAM, Martin Anthony
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    Amministratore
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    United KingdomBritish82233550001
    BARBER, Dean Anthony
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Amministratore
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    EnglandBritish230739040001
    BROWN, Ian Christopher
    Fox Hollow
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    Amministratore
    Fox Hollow
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    EnglandBritish75493580001
    BRUCE, Robert David Glenrinnes
    45 Gally Hill Road
    Church Crookham
    GU13 0QE Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    45 Gally Hill Road
    Church Crookham
    GU13 0QE Fleet
    Hampshire
    British66210170001
    BYAM SHAW, Justin David Elliott
    6 Westbourne Park Road
    W2 5PH London
    Amministratore
    6 Westbourne Park Road
    W2 5PH London
    British40017100001
    CARRINGTON, John Christopher
    1 Anchor Brewhouse
    50 Shad Thames
    SE1 2LY London
    Amministratore
    1 Anchor Brewhouse
    50 Shad Thames
    SE1 2LY London
    United KingdomBritish79087670001
    CHATFIELD, Paul
    21 Ludlow Avenue
    WR4 0EN Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    21 Ludlow Avenue
    WR4 0EN Worcester
    Worcestershire
    British71912610001
    COLEMAN, Timothy James
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    Amministratore
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    United KingdomBritish163698620001
    COVE, Graham Lawrence
    2 White House Close
    SG14 3TW Watton At Stone
    Hertfordshire
    Amministratore
    2 White House Close
    SG14 3TW Watton At Stone
    Hertfordshire
    EnglandBritish45340010002
    COX, David Howard
    Waverley
    Chenies Road Chorleywood
    WD3 5LU Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Waverley
    Chenies Road Chorleywood
    WD3 5LU Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish100698330001
    CUSHING, Robert Sefton
    66 Columbia Place Fornham Street
    S2 4AR Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    66 Columbia Place Fornham Street
    S2 4AR Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish117325300001
    DAWSON, John Hugh
    Ashleigh
    Grenofen
    PL19 9EW Tavistock
    Devon
    Amministratore
    Ashleigh
    Grenofen
    PL19 9EW Tavistock
    Devon
    EnglandBritish59251210001
    DEANE, Keith
    2 Westminster Close
    GU51 4NR Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    2 Westminster Close
    GU51 4NR Fleet
    Hampshire
    EnglandBritish85309310001
    DONNELLY, Mary Kathleen
    Prospect House
    1a Prospect Row
    CB1 1DU Cambridge
    Amministratore
    Prospect House
    1a Prospect Row
    CB1 1DU Cambridge
    EnglandBritish85309000001
    DOUGHTY, Royston George
    60 Cedars Road
    Hampton Wick
    KT1 4BE Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    60 Cedars Road
    Hampton Wick
    KT1 4BE Kingston Upon Thames
    Surrey
    British6194830001
    DOWNHAM, Robert Henry
    Spring Cottage
    The Common
    DT11 8QY Blandford Forum
    Dorset
    Amministratore
    Spring Cottage
    The Common
    DT11 8QY Blandford Forum
    Dorset
    British98701880001
    FISHER, Fraser St John
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Amministratore
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    EnglandBritish72704710002
    GRAY, Christopher Robert
    15 Vale Close
    Lower Bourne
    GU10 3HR Farnham
    Surrey
    Amministratore
    15 Vale Close
    Lower Bourne
    GU10 3HR Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish23552180001
    HALLETT, Peter John
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Amministratore
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    United KingdomBritish20621770002
    HARROLD, Alan Henry
    Cherry Tree House
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Cherry Tree House
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    EnglandBritish88772110001
    LANCH, Nigel Leslie
    Willow Cottage 19 Water Lane
    KT11 2PA Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Willow Cottage 19 Water Lane
    KT11 2PA Cobham
    Surrey
    British54508950001
    MCGOUGAN, Malcolm James Andrew
    33 Shrub End Road
    CO3 3UD Colchester
    Essex
    Amministratore
    33 Shrub End Road
    CO3 3UD Colchester
    Essex
    British44066820001
    MOONEY, Jeremy
    135 Victoria Road
    N22 7XH London
    Amministratore
    135 Victoria Road
    N22 7XH London
    British71912690001

    Chi sono le persone con controllo significativo di REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Redcentric Holdings Limited
    Otley Road
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    England
    06 apr 2016
    Otley Road
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    REDCENTRIC COMMUNICATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 dic 2013
    Consegnato il 08 gen 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Ground floor, building no. 3 (newton house), the cambridge business park, milton road, cambridge t/no CB340008. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 gen 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 02 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Group debenture
    Creato il 21 giu 2012
    Consegnato il 29 giu 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each present and future secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 giu 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over shares
    Creato il 24 feb 2009
    Consegnato il 27 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the charged securities, any related rights, dividends, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 02 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 ott 2006
    Consegnato il 13 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 02 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 05 lug 2005
    Consegnato il 26 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 02 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed
    Creato il 24 lug 2002
    Consegnato il 13 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £22,500.00 and all further moneys due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Deposit of £22,500 and all other moneys and interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Goodall Barnard Holdings Limited
    Transazioni
    • 13 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed
    Creato il 24 lug 2002
    Consegnato il 13 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £12,500.00 and all further moneys due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £12,500 deposit with all other moneys and interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Goodall Barnard Holdings Limited
    Transazioni
    • 13 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed
    Creato il 24 lug 2002
    Consegnato il 13 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £15,000.00 and all further moneys due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £15,000 deposit and all other moneys demanded and all interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Goodall Barnard Properties Limited
    Transazioni
    • 13 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 09 mag 2001
    Consegnato il 15 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease granted on the same date as the deed
    Brevi particolari
    The deposit is defined in the deed as the sum or sums standing to the credit of the account including an initial deposit of £25,375,00 paid by the tenant under the deed, any renewal or replacement of these sums, all interest earned on the account and all entitlements, rights and benefits accruing directly or indirectly to the account.
    Persone aventi diritto
    • South Herts Office Campus Limited
    Transazioni
    • 15 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 21 ago 2000
    Consegnato il 24 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and lease of even date relating to the property known as third floor unit b south herts office campus borehamwood
    Brevi particolari
    A deposit of £33,876 and accruing interest. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Possfund Custodian Trustee Limited
    Transazioni
    • 24 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 15 ago 2000
    Consegnato il 25 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of the obligors to the chargee under each of the finance documents
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the equipment all benefits in respect of the insurances and all proceeds thereof for full details and definitions please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dresdner Bank Ag
    Transazioni
    • 25 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 28 giu 2000
    Consegnato il 18 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease
    Brevi particolari
    The tenant charges its interest in the deposit balance.
    Persone aventi diritto
    • Computer Associates UK Limited
    Transazioni
    • 18 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit
    Creato il 08 mar 2000
    Consegnato il 28 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The sum of £61,117 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The sum. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Computer Associates UK Limited
    Transazioni
    • 28 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit deed
    Creato il 16 lug 1998
    Consegnato il 18 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The due compliance of the company's obligations with the chargee under the lease dated 16TH july 1998
    Brevi particolari
    The sum of £27,354.25 deposited at the royal bank of scotland PLC 67 lombard street london together with any interest accrued.
    Persone aventi diritto
    • Possfund Custodian Trustee Limited
    Transazioni
    • 18 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 04 set 1997
    Consegnato il 10 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 03 ott 1996
    Consegnato il 17 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 apr 1996
    Consegnato il 25 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £482,925 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Three okeford switches.
    Persone aventi diritto
    • Planet Internet (UK) Limited
    Transazioni
    • 25 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit deed
    Creato il 27 feb 1996
    Consegnato il 28 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 27TH february 1996
    Brevi particolari
    Deposit of £18,175 maintained at the royal bank of scotland PLC 67 lombard street london tigether with all interest accruing. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Possfund Custodian Trustee Limited
    Transazioni
    • 28 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0