MIKE CORBY GROUP LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MIKE CORBY GROUP LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03024086 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MIKE CORBY GROUP LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova MIKE CORBY GROUP LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Whelco Place Enfield Street WN5 8DB Wigan England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MIKE CORBY GROUP LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ALDAIR LIMITED | 21 feb 1995 | 21 feb 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MIKE CORBY GROUP LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2023 |
Quali sono le ultime deposizioni per MIKE CORBY GROUP LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2023 | 1 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 feb 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022 | 1 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 feb 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021 | 1 pagine | AA | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020 | 1 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 feb 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione di Mike Corby Holdings Ltd come persona con controllo significativo il 25 feb 2020 | 1 pagine | PSC07 | ||
Cessazione di Dave Whelan Sports Ltd come persona con controllo significativo il 25 feb 2020 | 1 pagine | PSC07 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 feb 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 1 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 feb 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Daniel Andrew Cornes come amministratore in data 08 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Anthony John Riley come amministratore in data 08 gen 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018 | 1 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 feb 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 1 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Martin Seibold come amministratore in data 28 apr 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 feb 2017 con aggiornamenti | 7 pagine | CS01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 58 Fleets Lane Poole Dorset BH15 3BT a Whelco Place Enfield Street Wigan WN5 8DB in data 04 ott 2016 | 1 pagine | AD01 | ||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 ott 2016 al 31 mar 2017 | 1 pagine | AA01 | ||
Cessazione della carica di James Peter Williams come amministratore in data 30 set 2016 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Paul Richard Stevens come amministratore in data 30 set 2016 | 1 pagine | TM01 | ||
Chi sono gli amministratori di MIKE CORBY GROUP LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEST, Scott Barry | Amministratore | Enfield Street WN5 8DB Wigan Whelco Place England | England | British | 215469920001 | |||||
| RILEY, Anthony John | Amministratore | Enfield Street WN5 8DB Wigan Whelco Place England | England | British | 89230160001 | |||||
| WHELAN, David | Amministratore | Enfield Street WN5 8DB Wigan Whelco Place England | England | British | 215468920001 | |||||
| BHALLA, Jinder | Segretario | 218 Leigh Hunt Drive N14 6DS Southgate London | British | 14843710005 | ||||||
| BRUEN, Colin Francis | Segretario | 11 Langdon Park Road N6 5PS London | British | 61285140001 | ||||||
| CADD, Susan Anne | Segretario | 58 Fleets Lane Poole BH15 3BT Dorset | British | 82401780001 | ||||||
| JAGTIANI, Anil | Segretario | 61 Sandringham Road Golders Green NW11 9DR London | British | 73281620001 | ||||||
| WOOTTON, Jeremy Charles | Segretario | 109 Bow Lane N12 0JL London | British | 65081940001 | ||||||
| AA COMPANY SERVICES LIMITED | Segretario nominato | First Floor Offices 8-10 Stamford Hill N16 6XZ London | 900002630001 | |||||||
| BHALLA, Jinder | Amministratore | 218 Leigh Hunt Drive N14 6DS Southgate London | British | 14843710005 | ||||||
| BROMAGE, Jeremy Tobias Arthur | Amministratore | 4 Sunningdale Road Bickley BR1 2ET Bromley Kent | British | 20552690001 | ||||||
| BYNG MADDICK, Zillah | Amministratore | Russet House 14 Claremont Gardens SL7 1BS Slough | England | British | 118619550001 | |||||
| CAREY, Carmel | Amministratore | 83 Brondesbury Villas NW6 6AG London | France | British | 60460790003 | |||||
| CORBY, Michael Wells | Amministratore | Coolham Manor Coolham RH13 8QE Horsham West Sussex | United Kingdom | British | 195099270001 | |||||
| CORBY, Mike | Amministratore | Coolham Manor RH1 3QE Coolham West Sussex | United Kingdom | British | 112826320001 | |||||
| CORNES, Daniel Andrew | Amministratore | Enfield Street WN5 8DB Wigan Whelco Place England | England | British | 209191050001 | |||||
| FEINGOLD, Limor | Amministratore | 23 Elms Avenue BH14 8EE Poole Dorset | British | 109022770001 | ||||||
| FLETCHER, Richard Anthony Homer | Amministratore | Ragmans Castle Common Hill West Chiltington RH20 2NR Pulborough West Sussex | British | 14843720001 | ||||||
| NEWMAN, Timothy Carlo | Amministratore | Charlton Marshall DT11 9NE Blandford Newlands Manor House Dorset | England | British | 133499820001 | |||||
| SEIBOLD, Martin | Amministratore | Enfield Street WN5 8DB Wigan Whelco Place England | England | German | 177678040001 | |||||
| STEVENS, Paul Richard | Amministratore | 58 Fleets Lane Poole BH15 3BT Dorset | England | British | 186050040001 | |||||
| WAGGETT, Colin Douglas | Amministratore | 22 Edgar Road SO23 9TW Winchester Hampshire | England | British | 104154090003 | |||||
| WILLIAMS, James Peter | Amministratore | 58 Fleets Lane Poole BH15 3BT Dorset | England | British | 170546570001 | |||||
| WILLIAMS, Jeremy David | Amministratore | Witchampton BH21 5AR Wimborne Welcombe Thatch | United Kingdom | British | 121982220002 | |||||
| BUYVIEW LTD | Amministratore delegato nominato | 1st Floor Offices 8-10 Stamford Hill N16 6XZ London | 900002620001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MIKE CORBY GROUP LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Whelan Sports Ltd | 01 ott 2016 | Enfield Street WN5 8DB Wigan Whelco Place England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Mrs Jayne Alison Best | 01 ott 2016 | Enfield Street WN5 8DB Wigan Whelco Place England | No | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Mike Corby Holdings Ltd | 06 apr 2016 | Enfield Street WN5 8DB Wigan Whelco Place England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
MIKE CORBY GROUP LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 23 dic 2004 Consegnato il 29 dic 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The property known as 179A tottenham court road london title number NGL737753. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 13 set 1999 Consegnato il 27 set 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The l/h property k/a 179A tottenham court road london. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0