PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED

PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03024878
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Devon Lodge
    Iddesleigh
    EX19 8BE Winkleigh
    Devon
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MERCANTILE LEASING COMPANY (NO.162) LIMITED22 feb 199522 feb 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 22 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 feb 2015

    Stato del capitale al 23 feb 2015

    • Capitale: GBP 102
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Beechfield House Winterton Way Lyme Green Business Park Macclesfield Cheshire SK11 0LP a Devon Lodge Iddesleigh Winkleigh Devon EX19 8BE in data 09 feb 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 mar 2014

    Stato del capitale al 04 mar 2014

    • Capitale: GBP 102
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Miss Jane Elizabeth Ruston il 01 gen 2013

    1 pagineCH03

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2012

    4 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * Suite 14 Beechfield House Winterton Way Lyme Green Business Pk, Macclesfield, Cheshire SK11 0LP* in data 04 dic 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 22 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2011

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Peter Beale come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Peter Anthony Martin Dillon come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 22 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2010

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    legacy

    3 pagine363a

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2008

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    5 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine190

    Chi sono gli amministratori di PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RUSTON, Jane Elizabeth
    Iddesleigh
    EX19 8BE Winkleigh
    Devon Lodge
    Devon
    England
    Segretario
    Iddesleigh
    EX19 8BE Winkleigh
    Devon Lodge
    Devon
    England
    British70986180008
    DILLON, Peter Anthony Martin
    Iddesleigh
    EX19 8BE Winkleigh
    Devon Lodge
    Devon
    England
    Amministratore
    Iddesleigh
    EX19 8BE Winkleigh
    Devon Lodge
    Devon
    England
    United KingdomBritish129983290001
    LEATHER, Jonathan Terence
    57 The Crofts
    Hatch Warren
    RG22 4RE Basingstoke
    Hampshire
    Segretario
    57 The Crofts
    Hatch Warren
    RG22 4RE Basingstoke
    Hampshire
    British69140360001
    SCOTT, Elizabeth Mary
    8 Belvidere Road
    WS1 3AU Walsall
    Segretario
    8 Belvidere Road
    WS1 3AU Walsall
    British76715280003
    SHOOLBRED, Charles Frederick
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    Segretario
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    British540290002
    BARCOSEC LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Segretario
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    49004930001
    EVER 1993 LIMITED
    International Headquarters
    Longbridge
    B31 2TB Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    International Headquarters
    Longbridge
    B31 2TB Birmingham
    West Midlands
    88822950001
    BEALE, Peter Robert
    Dunhampstead House
    Dunhampstead
    WR9 7JX Droitwich Spa
    West Midlands
    Amministratore
    Dunhampstead House
    Dunhampstead
    WR9 7JX Droitwich Spa
    West Midlands
    United KingdomBritish25365060002
    BOOBYER, Christopher Leslie Richard
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Amministratore
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    British92233050001
    BOX, Sarah
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    Amministratore
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    British47381630004
    CALLENDER, John Dalrymple
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    Amministratore
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    United KingdomBritish2444200001
    DOWDING, Eric Robert
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    Amministratore
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    British46728970001
    LEATHER, Jonathan Terence
    47 Firecrest Road
    Kempshott
    RG22 5UL Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    47 Firecrest Road
    Kempshott
    RG22 5UL Basingstoke
    Hampshire
    British69140360002
    MCCORMICK, Kevin
    7 Laidlaw Close
    Talbot Village Wallisdown
    BH12 5EW Poole
    Dorset
    Amministratore
    7 Laidlaw Close
    Talbot Village Wallisdown
    BH12 5EW Poole
    Dorset
    British14860030001
    MCMILLAN, Richard John
    17 Hawthorn Close
    Colden Common
    SO21 1UX Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    17 Hawthorn Close
    Colden Common
    SO21 1UX Winchester
    Hampshire
    British68601920001
    PATTERSON, Mark Allan
    6 Vespasian Gardens
    RG24 9SH Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    6 Vespasian Gardens
    RG24 9SH Basingstoke
    Hampshire
    British71785630001
    ROWAN, Charles Paul
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    British49237910001
    ROWBERRY, Duncan John
    2 Morris Rise
    Chineham
    RG24 8LD Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    2 Morris Rise
    Chineham
    RG24 8LD Basingstoke
    Hampshire
    British49237880002
    RUSTON, Jane Elizabeth
    4 Mainwaring Road
    Over Peover
    WA16 8TR Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    4 Mainwaring Road
    Over Peover
    WA16 8TR Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish70986180008
    SHAW, Robert Michael
    11 Westminster Road
    Branksome Park
    BH13 6JQ Poole
    Dorset
    Amministratore
    11 Westminster Road
    Branksome Park
    BH13 6JQ Poole
    Dorset
    EnglandBritish6887610001
    VAUGHAN, Phil
    Lexington
    Wyche Lane
    CW6 9PD Bunbury
    Cheshire
    Amministratore
    Lexington
    Wyche Lane
    CW6 9PD Bunbury
    Cheshire
    British35020290001
    WATSON, Hazel Anne Marie
    6 Abbotsmead Place
    Caversham
    RG4 8BB Reading
    Reading
    Amministratore
    6 Abbotsmead Place
    Caversham
    RG4 8BB Reading
    Reading
    British71785600001
    WEAL, Barry
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    British40203100001
    WEAVING, John Martin
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    Amministratore
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    British58523120001
    BARCOSEC LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Amministratore
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    49004930001
    BAROMETERS LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Amministratore
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    57357300002

    PHOENIX VENTURE LEASING 2 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Aircraft mortgage
    Creato il 01 apr 2003
    Consegnato il 15 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    With full title guarantee all its interest, present and future, in and to: the aircraft and all technical records, together the mortgaged property;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 15 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of payments due under the group relief deed and certain payments of corporation tax
    Creato il 01 apr 2003
    Consegnato il 11 apr 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The assigned barclays property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (Acting for Itself and as Agent for Members of the Barclays Group) Andthomson Travel International Ag and Tui Northern Europe Limited
    Transazioni
    • 11 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fee account charge
    Creato il 01 apr 2003
    Consegnato il 11 apr 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies liabilities and obligations due or to become due from the company (formerly known as mercantile leasing company (no.162) limited to the chargee (as security trustee for the secured parties) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Assignment of insurances
    Creato il 01 apr 2003
    Consegnato il 09 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The assigned property absolutely by way of security. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 09 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security assignment
    Creato il 01 apr 2003
    Consegnato il 09 apr 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its rights, title and interest, present and future, in and to, or arising under or in respect of the assigned documents and all moneys whatsoever payable to the owner thereunder, including all claims for damages and compensation in respect of any breach thereof.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 09 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Account charge
    Creato il 01 apr 2003
    Consegnato il 09 apr 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to the deposit and all and any rights and benefits accruing to or arising in connection therewith.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0