LUXURYTIME LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLUXURYTIME LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03026762
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LUXURYTIME LIMITED?

    • (7020) /

    Dove si trova LUXURYTIME LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    823 Salisbury House
    29 Finsbury Circus
    EC2M 5QQ London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di LUXURYTIME LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per LUXURYTIME LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Leif Stiholt come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 27 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 mar 2011

    Stato del capitale al 03 mar 2011

    • Capitale: GBP 2,150,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    15 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Krogh & Partners Limited 823 Salisbury House 29 Finsbury Circus London EC2M 5QQ in data 15 apr 2010

    2 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Eurobrake Halesfield 13 Telford Shropshire TF7 4NP in data 29 mar 2010

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Leif Stiholt il 26 feb 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    16 pagineAA

    legacy

    7 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    16 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    15 pagineAA

    legacy

    8 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    15 pagineAA

    legacy

    8 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    23 pagineAA

    legacy

    8 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2003

    25 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di LUXURYTIME LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FUGLGAARD, Hans, Director
    Soparken 97
    FOREIGN Odense S
    Dk-5260
    Denmark
    Segretario
    Soparken 97
    FOREIGN Odense S
    Dk-5260
    Denmark
    DanishManaging Director94031720001
    FUGLGAARD, Hans, Director
    Soparken 97
    FOREIGN Odense S
    Dk-5260
    Denmark
    Amministratore
    Soparken 97
    FOREIGN Odense S
    Dk-5260
    Denmark
    DenmarkDanishManaging Director94031720001
    ARCHER, Susan Irene
    Martin Cottage
    Church Lane
    WR3 8TQ Martin Hussingtree
    Worcester
    Segretario
    Martin Cottage
    Church Lane
    WR3 8TQ Martin Hussingtree
    Worcester
    BritishCompany Secretary24740700001
    JESPERSEN, Steffen Busk
    76 Lowbrook Lane
    Tidbury Green
    B90 1QS Solihull
    West Midlands
    Segretario
    76 Lowbrook Lane
    Tidbury Green
    B90 1QS Solihull
    West Midlands
    DanishManaging Director67846270002
    MCBRIDE, Sean Ralph
    Oakhaven,
    Longdon Upon Tern
    TF6 6LJ Telford
    Shropshire
    Segretario
    Oakhaven,
    Longdon Upon Tern
    TF6 6LJ Telford
    Shropshire
    British79045250001
    MOLLER, Jens
    Prices Havevej 41
    5600 Faaborg
    Denmark
    Segretario
    Prices Havevej 41
    5600 Faaborg
    Denmark
    Danish56169920001
    EXPRESS SECRETARIES LIMITED
    4 Blackett Drive
    Heather
    LE67 2RL Coalville
    Leicestershire
    Segretario nominato
    4 Blackett Drive
    Heather
    LE67 2RL Coalville
    Leicestershire
    900006670001
    RUTLAND SECRETARIES LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Segretario
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    38851450001
    ARCHER, Leslie Gordon
    Martin Cottage
    Church Lane
    WR3 8TQ Martin Hussingtree
    Worcester
    Amministratore
    Martin Cottage
    Church Lane
    WR3 8TQ Martin Hussingtree
    Worcester
    BritishAccountant24740710001
    ARCHER, Susan Irene
    Martin Cottage
    Church Lane
    WR3 8TQ Martin Hussingtree
    Worcester
    Amministratore
    Martin Cottage
    Church Lane
    WR3 8TQ Martin Hussingtree
    Worcester
    BritishCompany Secretary24740700001
    CARTER, Alan Harold
    Woodcote Woodcote Lane
    Upton Warren
    B61 9ED Bromsgrove
    Worcestershire
    Amministratore
    Woodcote Woodcote Lane
    Upton Warren
    B61 9ED Bromsgrove
    Worcestershire
    United KingdomBritishConsultant27384250001
    JESPERSEN, Steffen Busk
    76 Lowbrook Lane
    Tidbury Green
    B90 1QS Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    76 Lowbrook Lane
    Tidbury Green
    B90 1QS Solihull
    West Midlands
    DanishManaging Director67846270002
    MOLLER, Jens
    Prices Havevej 41
    5600 Faaborg
    Denmark
    Amministratore
    Prices Havevej 41
    5600 Faaborg
    Denmark
    DanishFinance Director56169920001
    STIHOLT, Leif
    Knudsejevej 4
    Dk 9352 Dybvad
    Denmark
    Amministratore
    Knudsejevej 4
    Dk 9352 Dybvad
    Denmark
    DenmarkDanishManaging Director82065040001
    THORSENG, Mogens
    Strandparken 84
    Millinge
    5642
    Denmark
    Amministratore
    Strandparken 84
    Millinge
    5642
    Denmark
    DanishManaging Director62447630001
    EXPRESS DIRECTORS LIMITED
    4 Blackett Drive
    Heather
    LE67 2RL Coalville
    Leicestershire
    Amministratore delegato nominato
    4 Blackett Drive
    Heather
    LE67 2RL Coalville
    Leicestershire
    900006660001
    RUTLAND DIRECTORS LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    39157740001

    LUXURYTIME LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 22 gen 2001
    Consegnato il 30 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Merita Bank PLC
    Transazioni
    • 30 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 09 nov 2000
    Consegnato il 10 nov 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease
    Brevi particolari
    A rent deposit deed of £29,313.90 which the chargee as landlord may draw upon if the company fails to pay the rents reserved by the lease. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Im Properties (Whb) Limited
    Transazioni
    • 10 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 09 nov 2000
    Consegnato il 10 nov 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease
    Brevi particolari
    A rent deposit deed of £25,126.20 which the chargee as landlord may draw upon if the company fails to pay the rents reserved by the lease. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Im Properties (Whb) Limited
    Transazioni
    • 10 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 23 giu 1997
    Consegnato il 05 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All plant machinery chattels or other equipment described in the scheduleto the form 395 together with any part or parts thereof and all additions together with the benefit of all maintenance agreements and the proceeds of sale thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 mag 1995
    Consegnato il 16 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0