THE BRICK BUSINESS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | THE BRICK BUSINESS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Liquidazione |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03029861 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di THE BRICK BUSINESS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova THE BRICK BUSINESS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Wienerberger House Brooks Drive Cheadle Royal Business SK8 3SA Park Cheadle Cheshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di THE BRICK BUSINESS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| DENTON SANDOWN LIMITED | 01 mar 1995 | 01 mar 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di THE BRICK BUSINESS LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2017 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2018 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per THE BRICK BUSINESS LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 17 dic 2017 |
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 31 dic 2017 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 17 dic 2016 |
| Scaduto | Sì |
Quali sono le ultime deposizioni per THE BRICK BUSINESS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 ott 2024 | 8 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 ott 2023 | 8 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Stevenson come amministratore in data 02 mar 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 ott 2022 | 7 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Domanda di insolvenza INSOLVENCY:Secretary of state release of liquidator | 1 pagine | LIQ MISC | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 ott 2021 | 8 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale | 13 pagine | LIQ10 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 15 pagine | 600 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 ott 2020 | 7 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 ott 2019 | 7 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 ott 2018 | 7 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 6 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Keith Stuart Barker come amministratore in data 01 set 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Harald Anton Schwarzmayr come amministratore in data 01 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 dic 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Harald Anton Schwarzmayr il 01 feb 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 dic 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Harald Anton Schwarzmayr il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr Michael Grace come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di THE BRICK BUSINESS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRACE, Michael | Segretario | Wienerberger House Brooks Drive Cheadle Royal Business SK8 3SA Park Cheadle Cheshire | 188990920001 | |||||||
| BARKER, Keith Stuart | Amministratore | Wienerberger House Brooks Drive Cheadle Royal Business SK8 3SA Park Cheadle Cheshire | England | British | 110773520001 | |||||
| ALLY, Bibi Rahima | Segretario | 68 Ruskin Road SM5 3DH Carshalton Surrey | British | 38963210001 | ||||||
| FEW, Kaye Suzanne | Segretario | 14 Bean Leach Avenue Offerton SK2 5JA Stockport Cheshire | British | 119910110001 | ||||||
| RICHARDS, Wayne | Segretario | Spring Cottage Park Lane Boarshurst OL3 7DZ Greenfield Saddleworth | British | 27757990002 | ||||||
| ATTRILL, Christopher Richard | Amministratore | 9 The Chines Delamere Park CW8 2XA Cuddington Cheshire | England | British | 93024670001 | |||||
| BODDY, Martyn | Amministratore | Ladyswood 47 Woodside Lane Poynton SK12 1BB Stockport Cheshire | British | 108596990001 | ||||||
| BROWN, John Forster | Amministratore | 7 Hurst Avenue N6 5TX London | United Kingdom | British | 4183480002 | |||||
| COLLETT, Brian | Amministratore | 254 Old Church Road Chingford E4 8BT London | British | 32267100002 | ||||||
| FORBES, Gerard James | Amministratore | 22 Frampton Close Middleton M24 1PF Manchester | British | 42936480002 | ||||||
| FROST, Neil Ernest | Amministratore | 2 Eccles Close Whaley Bridge SK12 7RS Stockport Cheshire | British | 28520400002 | ||||||
| FURR, Patrick Charles | Amministratore | Edenbridge Close Weston CW2 5QU Crewe 8 Cheshire England | United Kingdom | British | 129981870001 | |||||
| HANNIDES, George Michael | Amministratore | 7 Great North Rd Brookmans Park AL96AB Hatfield Hertfordshire | United Kingdom | British | 127571820001 | |||||
| JACKSON, John Andrew | Amministratore | 17 Crossfield Road Hale WA15 8DU Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 24857510001 | |||||
| KIELY, Brian David | Amministratore | 17 Hawthorn Lane Ashton-On-Mersey M33 5WW Sale Cheshire | British | 99921060001 | ||||||
| KOEKOEK, Bert Jan | Amministratore | Bernhardstraat 11 4175 Ed Haaften The Netherlands | Netherlands | Dutch | 119912460001 | |||||
| LANGMUIR, Hugh Macgillivray | Amministratore | 14 Ashchurch Park Villas W12 9SP London | British | 42365820001 | ||||||
| MARGRAVE, Philip John | Amministratore | 9 Marquis Way Aldwick PO21 4AT Bognor Regis West Sussex | England | British | 51493580001 | |||||
| REDFERN, Stuart William | Amministratore | 49 Drummond Way SK10 4XJ Macclesfield Cheshire | British | 76159410002 | ||||||
| RICHARDS, Wayne | Amministratore | 9 Platting Road Lydgate OL4 4DL Oldham Lancashire | British | 27757990001 | ||||||
| RICHARDS, Wayne | Amministratore | 9 Platting Road Lydgate OL4 4DL Oldham Lancashire | British | 27757990001 | ||||||
| ROBERTS, Gareth Wynford Lewis | Amministratore | 7 Nene Lane NN12 6YN Towcester Northamptonshire | British | 81203280001 | ||||||
| SANDFORD, John Martin | Amministratore | 25 Newstead Close Poynton SK12 1ES Stockport Cheshire | British | 14927950001 | ||||||
| SCHEUCH, Heimo | Amministratore | Avenue Des Courses 20 FOREIGN Brussels 1050 Belgium | Austria | Austrian | 100521050001 | |||||
| SCHWARZMAYR, Harald Anton | Amministratore | Wienerberger House Brooks Drive Cheadle Royal Business SK8 3SA Park Cheadle Cheshire | United Kingdom | Austrian | 103815020002 | |||||
| STEVENSON, Paul | Amministratore | 10 Hill Top Grove West Ardsley WF3 1HP Wakefield West Yorkshire | England | British | 113293590001 | |||||
| VAN RIET, Willy Marie Jean | Amministratore | Leeuwerikenlaan 14 Dendermonde 9200 Belgium | Belgian | 100527520001 | ||||||
| WELHAM, John Harry | Amministratore | Mayfield Runshaw Lane Euxton PR7 6HB Chorley Lancashire | British | 27761560002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di THE BRICK BUSINESS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelwood Group | 06 apr 2016 | Brooks Drive Cheadle Royal Business Park SK8 3SA Cheadle Wienerberger House Cheshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
THE BRICK BUSINESS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 28 nov 2003 Consegnato il 05 dic 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Property being all the mineral beds of brickshale within an area of land containing 67.28 hectares or thereabouts situate at todhills brickworks, todhills, county durham comprised in a lease dated 28 november between (1) the church commissioners for endgland and (2) the company; for details of further property charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 28 ott 2003 Consegnato il 04 nov 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All money or liabilities due owing or incurred to any secured party by any charging company or any other obligor at present or in the future in any manner whether actual or contingent together with interest | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 28 mar 2002 Consegnato il 06 apr 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Amending deed (relating to a composite guarantee and debenture originally dated 20TH march 1995 "the guarantee and debenture") | Creato il 07 nov 1997 Consegnato il 20 nov 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the facility agreement, the finance documents (or any of them), the hedging agreements (or any of them) and the guarantee and debenture | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Amending deed | Creato il 22 set 1997 Consegnato il 08 ott 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the facility agreement, the finance documents, the hedging agreements and the guarantee & debenture or any of them | |
Brevi particolari All book and other debts all assets property goodwill and undertaking from time to time. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 20 mar 1995 Consegnato il 23 mar 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from brickbuilt limited and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the term loan and revolving credit agreement dated 20TH march 1995 pursuant to which the chargees agreed to make available a term loan of £28,000,000 and a revolving credit facility of up to £4,000,000 to the company (the "facility agreement"), the finance documents, the hedging agreements and this deed in any currency or currencies whether present or future | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 04 mar 1995 Consegnato il 06 mar 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or brickbuilt limited to the chargee under the terms of the facility agreement dated 3RD march 1995 or any collateral instrument | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
THE BRICK BUSINESS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0