THE BRICK BUSINESS LIMITED

THE BRICK BUSINESS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE BRICK BUSINESS LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03029861
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di THE BRICK BUSINESS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova THE BRICK BUSINESS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Wienerberger House Brooks
    Drive Cheadle Royal Business
    SK8 3SA Park Cheadle
    Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE BRICK BUSINESS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DENTON SANDOWN LIMITED01 mar 199501 mar 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE BRICK BUSINESS LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2017
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2018
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per THE BRICK BUSINESS LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al17 dic 2017
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma31 dic 2017
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al17 dic 2016
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per THE BRICK BUSINESS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 ott 2024

    8 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 ott 2023

    8 pagineLIQ03

    Cessazione della carica di Paul Stevenson come amministratore in data 02 mar 2023

    1 pagineTM01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 ott 2022

    7 pagineLIQ03

    Domanda di insolvenza

    INSOLVENCY:Secretary of state release of liquidator
    1 pagineLIQ MISC

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 ott 2021

    8 pagineLIQ03

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    13 pagineLIQ10

    Nomina di un liquidatore volontario

    15 pagine600

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 ott 2020

    7 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 ott 2019

    7 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 ott 2018

    7 pagineLIQ03

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 26 ott 2017

    LRESSP

    Nomina di Mr Keith Stuart Barker come amministratore in data 01 set 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Harald Anton Schwarzmayr come amministratore in data 01 set 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 gen 2016

    Stato del capitale al 12 gen 2016

    • Capitale: GBP 900,002
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Harald Anton Schwarzmayr il 01 feb 2011

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 gen 2015

    Stato del capitale al 14 gen 2015

    • Capitale: GBP 900,002
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Harald Anton Schwarzmayr il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Michael Grace come segretario

    2 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di THE BRICK BUSINESS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GRACE, Michael
    Wienerberger House Brooks
    Drive Cheadle Royal Business
    SK8 3SA Park Cheadle
    Cheshire
    Segretario
    Wienerberger House Brooks
    Drive Cheadle Royal Business
    SK8 3SA Park Cheadle
    Cheshire
    188990920001
    BARKER, Keith Stuart
    Wienerberger House Brooks
    Drive Cheadle Royal Business
    SK8 3SA Park Cheadle
    Cheshire
    Amministratore
    Wienerberger House Brooks
    Drive Cheadle Royal Business
    SK8 3SA Park Cheadle
    Cheshire
    EnglandBritish110773520001
    ALLY, Bibi Rahima
    68 Ruskin Road
    SM5 3DH Carshalton
    Surrey
    Segretario
    68 Ruskin Road
    SM5 3DH Carshalton
    Surrey
    British38963210001
    FEW, Kaye Suzanne
    14 Bean Leach Avenue
    Offerton
    SK2 5JA Stockport
    Cheshire
    Segretario
    14 Bean Leach Avenue
    Offerton
    SK2 5JA Stockport
    Cheshire
    British119910110001
    RICHARDS, Wayne
    Spring Cottage
    Park Lane Boarshurst
    OL3 7DZ Greenfield
    Saddleworth
    Segretario
    Spring Cottage
    Park Lane Boarshurst
    OL3 7DZ Greenfield
    Saddleworth
    British27757990002
    ATTRILL, Christopher Richard
    9 The Chines
    Delamere Park
    CW8 2XA Cuddington
    Cheshire
    Amministratore
    9 The Chines
    Delamere Park
    CW8 2XA Cuddington
    Cheshire
    EnglandBritish93024670001
    BODDY, Martyn
    Ladyswood 47 Woodside Lane
    Poynton
    SK12 1BB Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    Ladyswood 47 Woodside Lane
    Poynton
    SK12 1BB Stockport
    Cheshire
    British108596990001
    BROWN, John Forster
    7 Hurst Avenue
    N6 5TX London
    Amministratore
    7 Hurst Avenue
    N6 5TX London
    United KingdomBritish4183480002
    COLLETT, Brian
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    Amministratore
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    British32267100002
    FORBES, Gerard James
    22 Frampton Close
    Middleton
    M24 1PF Manchester
    Amministratore
    22 Frampton Close
    Middleton
    M24 1PF Manchester
    British42936480002
    FROST, Neil Ernest
    2 Eccles Close
    Whaley Bridge
    SK12 7RS Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    2 Eccles Close
    Whaley Bridge
    SK12 7RS Stockport
    Cheshire
    British28520400002
    FURR, Patrick Charles
    Edenbridge Close
    Weston
    CW2 5QU Crewe
    8
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Edenbridge Close
    Weston
    CW2 5QU Crewe
    8
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish129981870001
    HANNIDES, George Michael
    7 Great North Rd
    Brookmans Park
    AL96AB Hatfield
    Hertfordshire
    Amministratore
    7 Great North Rd
    Brookmans Park
    AL96AB Hatfield
    Hertfordshire
    United KingdomBritish127571820001
    JACKSON, John Andrew
    17 Crossfield Road
    Hale
    WA15 8DU Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    17 Crossfield Road
    Hale
    WA15 8DU Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish24857510001
    KIELY, Brian David
    17 Hawthorn Lane
    Ashton-On-Mersey
    M33 5WW Sale
    Cheshire
    Amministratore
    17 Hawthorn Lane
    Ashton-On-Mersey
    M33 5WW Sale
    Cheshire
    British99921060001
    KOEKOEK, Bert Jan
    Bernhardstraat 11
    4175 Ed Haaften
    The Netherlands
    Amministratore
    Bernhardstraat 11
    4175 Ed Haaften
    The Netherlands
    NetherlandsDutch119912460001
    LANGMUIR, Hugh Macgillivray
    14 Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    Amministratore
    14 Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    British42365820001
    MARGRAVE, Philip John
    9 Marquis Way
    Aldwick
    PO21 4AT Bognor Regis
    West Sussex
    Amministratore
    9 Marquis Way
    Aldwick
    PO21 4AT Bognor Regis
    West Sussex
    EnglandBritish51493580001
    REDFERN, Stuart William
    49 Drummond Way
    SK10 4XJ Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    49 Drummond Way
    SK10 4XJ Macclesfield
    Cheshire
    British76159410002
    RICHARDS, Wayne
    9 Platting Road
    Lydgate
    OL4 4DL Oldham
    Lancashire
    Amministratore
    9 Platting Road
    Lydgate
    OL4 4DL Oldham
    Lancashire
    British27757990001
    RICHARDS, Wayne
    9 Platting Road
    Lydgate
    OL4 4DL Oldham
    Lancashire
    Amministratore
    9 Platting Road
    Lydgate
    OL4 4DL Oldham
    Lancashire
    British27757990001
    ROBERTS, Gareth Wynford Lewis
    7 Nene Lane
    NN12 6YN Towcester
    Northamptonshire
    Amministratore
    7 Nene Lane
    NN12 6YN Towcester
    Northamptonshire
    British81203280001
    SANDFORD, John Martin
    25 Newstead Close
    Poynton
    SK12 1ES Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    25 Newstead Close
    Poynton
    SK12 1ES Stockport
    Cheshire
    British14927950001
    SCHEUCH, Heimo
    Avenue Des Courses 20
    FOREIGN Brussels
    1050
    Belgium
    Amministratore
    Avenue Des Courses 20
    FOREIGN Brussels
    1050
    Belgium
    AustriaAustrian100521050001
    SCHWARZMAYR, Harald Anton
    Wienerberger House Brooks
    Drive Cheadle Royal Business
    SK8 3SA Park Cheadle
    Cheshire
    Amministratore
    Wienerberger House Brooks
    Drive Cheadle Royal Business
    SK8 3SA Park Cheadle
    Cheshire
    United KingdomAustrian103815020002
    STEVENSON, Paul
    10 Hill Top Grove
    West Ardsley
    WF3 1HP Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    10 Hill Top Grove
    West Ardsley
    WF3 1HP Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish113293590001
    VAN RIET, Willy Marie Jean
    Leeuwerikenlaan 14
    Dendermonde
    9200
    Belgium
    Amministratore
    Leeuwerikenlaan 14
    Dendermonde
    9200
    Belgium
    Belgian100527520001
    WELHAM, John Harry
    Mayfield Runshaw Lane
    Euxton
    PR7 6HB Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    Mayfield Runshaw Lane
    Euxton
    PR7 6HB Chorley
    Lancashire
    British27761560002

    Chi sono le persone con controllo significativo di THE BRICK BUSINESS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Brooks Drive
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3SA Cheadle
    Wienerberger House
    Cheshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Brooks Drive
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3SA Cheadle
    Wienerberger House
    Cheshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaUnlimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3028184
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    THE BRICK BUSINESS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 28 nov 2003
    Consegnato il 05 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Property being all the mineral beds of brickshale within an area of land containing 67.28 hectares or thereabouts situate at todhills brickworks, todhills, county durham comprised in a lease dated 28 november between (1) the church commissioners for endgland and (2) the company; for details of further property charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 ott 2003
    Consegnato il 04 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money or liabilities due owing or incurred to any secured party by any charging company or any other obligor at present or in the future in any manner whether actual or contingent together with interest
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 mar 2002
    Consegnato il 06 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Plcas Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 06 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Amending deed (relating to a composite guarantee and debenture originally dated 20TH march 1995 "the guarantee and debenture")
    Creato il 07 nov 1997
    Consegnato il 20 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the facility agreement, the finance documents (or any of them), the hedging agreements (or any of them) and the guarantee and debenture
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trust Companyas Security Trustee for Itself and the Other Finance Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 20 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Amending deed
    Creato il 22 set 1997
    Consegnato il 08 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the facility agreement, the finance documents, the hedging agreements and the guarantee & debenture or any of them
    Brevi particolari
    All book and other debts all assets property goodwill and undertaking from time to time. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trust Company
    Transazioni
    • 08 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 20 mar 1995
    Consegnato il 23 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from brickbuilt limited and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the term loan and revolving credit agreement dated 20TH march 1995 pursuant to which the chargees agreed to make available a term loan of £28,000,000 and a revolving credit facility of up to £4,000,000 to the company (the "facility agreement"), the finance documents, the hedging agreements and this deed in any currency or currencies whether present or future
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trust Companyas Security Trustee for Itself and the Other Finance Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 23 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 04 mar 1995
    Consegnato il 06 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or brickbuilt limited to the chargee under the terms of the facility agreement dated 3RD march 1995 or any collateral instrument
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cinven Limited
    Transazioni
    • 06 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    THE BRICK BUSINESS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 ott 2017Inizio della liquidazione
    22 set 2017Data della dichiarazione di solvibilità giurata
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Emma Cray
    Central Square, 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Praticante
    Central Square, 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0