ST GEORGES NURSING HOMES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ST GEORGES NURSING HOMES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03032346 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ST GEORGES NURSING HOMES LIMITED?
- Strutture residenziali di assistenza infermieristica (87100) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
Dove si trova ST GEORGES NURSING HOMES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Asticus Building, 2nd Floor 21 Palmer Street SW1H 0AD London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ST GEORGES NURSING HOMES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BART 110 LIMITED | 13 mar 1995 | 13 mar 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ST GEORGES NURSING HOMES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per ST GEORGES NURSING HOMES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 mar 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Sanne Group Secretaries (Uk) Limited il 20 lug 2015 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Sanne Group 2nd Floor Pollen House 10 Cork Street London W1S 3NP a Asticus Building, 2nd Floor 21 Palmer Street London SW1H 0AD in data 05 ago 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Sanne Group Secretaries (Uk) Limited il 31 mar 2014 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Nomina di Jonathan David Farkas come amministratore in data 27 gen 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mathieu Streiff come amministratore in data 27 gen 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
legacy | 28 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Sanne Group 1 Berkeley Street London W1J 8DJ* in data 07 apr 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 mar 2014 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mathieu Streiff il 01 gen 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2014 al 31 dic 2013 | 3 pagine | AA01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Sanne Group Secretaries (Uk) Limited come segretario | 3 pagine | AP04 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ST GEORGES NURSING HOMES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED | Segretario | Palmer Street SW1H 0AD London 21 England |
| 175738460001 | ||||||||||
| FARKAS, Jonathan David | Amministratore | Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building, 2nd Floor 21 | Luxembourg | American | 193539990001 | |||||||||
| ALLEN, Andrew James | Segretario | 33 Canynge Square Clifton BS8 3LB Bristol | British | 91532420002 | ||||||||||
| SCHOFIELD, Nigel Bennett | Segretario | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | British | 52338530002 | ||||||||||
| BART SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | Third Floor Saint Bartholomews Lewins Mead Bristol | 900006550001 | |||||||||||
| ALLEN, Andrew James | Amministratore | 33 Canynge Square Clifton BS8 3LB Bristol | Britain | British | 91532420002 | |||||||||
| BERGMAN, Jan Edward Ernest | Amministratore | 11 Lindum Place AL3 4JJ St Albans Hertfordshire | British | 43998850001 | ||||||||||
| CORMACK, Derek George | Amministratore | Pillars Grantley Avenue, Wonersh GU5 0QN Guildford Surrey | England | Irish | 67400530015 | |||||||||
| DAVIES, Michael John | Amministratore | 5 Pitch Close Carlton NG4 1SL Nottingham | British | 43580600002 | ||||||||||
| HILL, Peter Martin | Amministratore | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | England | British | 130983750001 | |||||||||
| JEFFERY, Paul Anthony Keith | Amministratore | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | United Kingdom | British | 65609290003 | |||||||||
| KING, Garland Martin | Amministratore | 88 Knapp Road Thornbury BS35 2HJ Bristol Avon | British | 28468050001 | ||||||||||
| PRIESTHAL, Keith | Amministratore | 4 Ermine Street Broughton DN20 0DQ Brigg South Humberside | British | 43431730001 | ||||||||||
| SCHOFIELD, Nigel Bennett | Amministratore | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | United Kingdom | British | 148139420001 | |||||||||
| STREIFF, Mathieu Bernard | Amministratore | c/o Sanne Group 10 Cork Street W1S 3NP London 2nd Floor Pollen House | United States | American | 200529310001 | |||||||||
| WHITE, Ian James | Amministratore | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | England | British | 133383410003 | |||||||||
| BART MANAGEMENT LIMITED | Amministratore delegato nominato | Third Floor Saint Bartholomews Lewins Mead Bristol | 900006540001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ST GEORGES NURSING HOMES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga Hc Reit Ch Uk Senior Housing Portfolio Limited | 06 apr 2016 | 21 Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ST GEORGES NURSING HOMES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 28 lug 2010 Consegnato il 06 ago 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each chargor to the chargee and to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. For details of property charged please refer to form MG01. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 16 nov 2007 Consegnato il 27 nov 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to the chargee for the secured finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Ascot house 28 wingrove road fenham,34 and 36 wingrove road newcastle upon tynet/no's TY221509 and TY52154,bradbury house bradbury house new street braintree t/no ESX647090, cheshire house 22 st mary's road ashton on mersey t/no GM54543 (for details of further properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 24 lug 1995 Consegnato il 02 ago 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 24 lug 1995 Consegnato il 02 ago 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a land at kenn road st george bristol avon t/no: AV219115 and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0