MVM HOLDINGS LIMITED

MVM HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMVM HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03033447
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MVM HOLDINGS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova MVM HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MVM HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    OVAL (980) LIMITED15 mar 199515 mar 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di MVM HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per MVM HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Herts HP2 4NW a 15 Canada Square London E14 5GL in data 03 lug 2019

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 10 giu 2019

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2018

    2 pagineAA

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 apr 2019 al 31 mar 2019

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Ian Michael Noble come amministratore in data 06 ago 2018

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen James Callaghan il 06 ago 2018

    2 pagineCH01

    legacy

    5 pagineRP04CS01

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 15 mar 2016

    21 pagineRP04AR01

    Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 15 mar 2015

    21 pagineRP04AR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2017

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01
    Note
    DataNota
    16 apr 2018Clarification A second filed CS01 (statement of capital change) was registered on 16/04/2018.

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2016

    5 pagineAA

    Nomina di Ian Michael Noble come amministratore in data 06 dic 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Coll come amministratore in data 06 dic 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen James Callaghan come amministratore in data 10 ott 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David John Meaden come amministratore in data 10 ott 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 15 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 apr 2016

    Stato del capitale al 11 apr 2016

    • Capitale: GBP 2,524,850
    SH01
    Note
    DataNota
    16 apr 2018Clarification A second filed AR01 was registered on 16/04/2018.

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2015

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 mar 2015

    Stato del capitale al 16 mar 2015

    • Capitale: GBP 2,524,850
    SH01
    Note
    DataNota
    16 apr 2018Clarification A second filed AR01 was registered on 16/04/2018.

    Chi sono gli amministratori di MVM HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2318923
    76579530001
    CALLAGHAN, Stephen James
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish201347710052
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Segretario
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Segretario
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    MACHIN, Brian Roy
    6 Redland Green Road
    Redland
    BS6 7HE Bristol
    Segretario
    6 Redland Green Road
    Redland
    BS6 7HE Bristol
    British8982230001
    NUNN, Carol Jayne
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Segretario
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British101872040001
    RICHARDSON, John David
    High Street
    Burnham
    SL1 7JD Slough
    27
    Berks
    Segretario
    High Street
    Burnham
    SL1 7JD Slough
    27
    Berks
    British128558470001
    SCHENCK, Daniel William
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Usa181204960001
    SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    Segretario
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    British143104990001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Segretario
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Segretario nominato
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001
    AL-SALEH, Adel Bedry
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican165900220001
    CLIFTON, Philip John
    The Dovecote
    Church Street
    LE15 8JR North Luffenham
    Rutland
    Amministratore
    The Dovecote
    Church Street
    LE15 8JR North Luffenham
    Rutland
    British60585520003
    COLL, Andrew
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish237260100001
    ECKFORD, Alan Tony
    53 Temple Mill Island
    Bisham
    SL7 1SQ Marlow
    Berkshire
    Amministratore
    53 Temple Mill Island
    Bisham
    SL7 1SQ Marlow
    Berkshire
    United KingdomBritish49014470001
    GREENLAND, Martyn Geoffrey
    11 York Road
    GL20 5HX Tewkesbury
    Gloucestershire
    Amministratore
    11 York Road
    GL20 5HX Tewkesbury
    Gloucestershire
    British45440250001
    HARLEY, Donald Wilson George
    22 Saint Marys Park
    SG8 7XB Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    22 Saint Marys Park
    SG8 7XB Royston
    Hertfordshire
    British80358920001
    HOLDSWORTH, Roderick Antony
    Neale
    Lewes Road, Scaynes Hill
    RH17 7NG Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    Neale
    Lewes Road, Scaynes Hill
    RH17 7NG Haywards Heath
    West Sussex
    EnglandBritish98217960001
    MACHIN, Brian Roy
    Drylaw Cottage
    Cote Drive
    BS9 3UP Bristol
    Amministratore
    Drylaw Cottage
    Cote Drive
    BS9 3UP Bristol
    British8982230003
    MACHIN, Patricia Joan
    6 Redland Green Road
    BS6 7HE Bristol
    Avon
    Amministratore
    6 Redland Green Road
    BS6 7HE Bristol
    Avon
    British63856450001
    MARKHAM, Jill Anthea
    3 Ivywell Road
    BS9 1NX Bristol
    Avon
    Amministratore
    3 Ivywell Road
    BS9 1NX Bristol
    Avon
    British46788850002
    MARKHAM, Richard John
    Castle Cote 3 Ivywell Road
    Sneyd Park
    BS9 1NX Bristol
    Avon
    Amministratore
    Castle Cote 3 Ivywell Road
    Sneyd Park
    BS9 1NX Bristol
    Avon
    United KingdomBritish35544120002
    MARTIN, Joseph Michael
    8 Mill View School Lane
    Eaton Socon
    PE19 3HJ St Neots
    Cambridgeshire
    Amministratore
    8 Mill View School Lane
    Eaton Socon
    PE19 3HJ St Neots
    Cambridgeshire
    British1092550002
    MEADEN, David John
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish193740420001
    NOBLE, Ian Michael
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish199843940001
    PETTIFOR, Timothy John
    Treetops 47 Caxton End
    Eltisley
    PE19 4TJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Treetops 47 Caxton End
    Eltisley
    PE19 4TJ Huntingdon
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish40366940001
    RUDD, Jeremy George Winterton
    Manor Farm
    Lower Lemington
    GL56 9NP Moreton In Marsh
    Amministratore
    Manor Farm
    Lower Lemington
    GL56 9NP Moreton In Marsh
    United KingdomBritish74891640002
    STIER, John Robert
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish78901530003
    STONE, Christopher Michael Renwick
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish66955690003
    TYDEMAN, David Rolfe
    Burton Grange
    BA12 6BR Burton
    Wiltshire
    Amministratore
    Burton Grange
    BA12 6BR Burton
    Wiltshire
    United KingdomBritish123730690001
    VENN, Jon
    North Hill Cottage East Dundry Lane
    Dundry
    BS41 8NJ Bristol
    Amministratore
    North Hill Cottage East Dundry Lane
    Dundry
    BS41 8NJ Bristol
    British15778460001
    VENN, Vicki Caroline
    North Hill Cottage
    East Dundry Lane
    BS18 8NT Bristol
    Amministratore
    North Hill Cottage
    East Dundry Lane
    BS18 8NT Bristol
    British23230700001
    OVAL NOMINEES LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Amministratore delegato nominato
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002560001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Amministratore delegato nominato
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MVM HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00968498
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    MVM HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of accession
    Creato il 29 apr 2008
    Consegnato il 12 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from that charging company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 12 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 11 mag 2007
    Consegnato il 23 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares and the related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 set 1997
    Consegnato il 06 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MVM HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    10 giu 2019Inizio della liquidazione
    12 ago 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0