MVM HOLDINGS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MVM HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03033447 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MVM HOLDINGS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova MVM HOLDINGS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MVM HOLDINGS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| OVAL (980) LIMITED | 15 mar 1995 | 15 mar 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MVM HOLDINGS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 apr 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per MVM HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 6 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Herts HP2 4NW a 15 Canada Square London E14 5GL in data 03 lug 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2018 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 apr 2019 al 31 mar 2019 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian Michael Noble come amministratore in data 06 ago 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen James Callaghan il 06 ago 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
legacy | 5 pagine | RP04CS01 | ||||||||||
Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 15 mar 2016 | 21 pagine | RP04AR01 | ||||||||||
Seconda presentazione del bilancio annuale redatto al 15 mar 2015 | 21 pagine | RP04AR01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2017 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Ian Michael Noble come amministratore in data 06 dic 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Coll come amministratore in data 06 dic 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen James Callaghan come amministratore in data 10 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David John Meaden come amministratore in data 10 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di MVM HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Segretario | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom |
| 76579530001 | ||||||||||
| CALLAGHAN, Stephen James | Amministratore | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 201347710052 | |||||||||
| FOX, Jacqueline Elizabeth | Segretario | Little Dormers 3 Wicken Road CB11 3QD Newport Essex | British | 35460890004 | ||||||||||
| GILLEN, Seamus Joseph | Segretario | 20 Mountway EN6 1EP Potters Bar Hertfordshire | British | 66174560001 | ||||||||||
| MACHIN, Brian Roy | Segretario | 6 Redland Green Road Redland BS6 7HE Bristol | British | 8982230001 | ||||||||||
| NUNN, Carol Jayne | Segretario | Boundary Way HP2 7HU Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 101872040001 | ||||||||||
| RICHARDSON, John David | Segretario | High Street Burnham SL1 7JD Slough 27 Berks | British | 128558470001 | ||||||||||
| SCHENCK, Daniel William | Segretario | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Marylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead 3rd Floor Hertfordshire United Kingdom | Usa | 181204960001 | ||||||||||
| SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George | Segretario | Red Tiles 62 Park Road GU22 7DB Woking Surrey | British | 143104990001 | ||||||||||
| TURNER, David Charles | Segretario | 13 Thorndales St Johns Avenue CM14 5DE Brentwood Essex | Other | 84007940001 | ||||||||||
| OVALSEC LIMITED | Segretario nominato | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002570001 | |||||||||||
| AL-SALEH, Adel Bedry | Amministratore | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Marylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead 3rd Floor Hertfordshire United Kingdom | United States | American | 165900220001 | |||||||||
| CLIFTON, Philip John | Amministratore | The Dovecote Church Street LE15 8JR North Luffenham Rutland | British | 60585520003 | ||||||||||
| COLL, Andrew | Amministratore | Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 237260100001 | |||||||||
| ECKFORD, Alan Tony | Amministratore | 53 Temple Mill Island Bisham SL7 1SQ Marlow Berkshire | United Kingdom | British | 49014470001 | |||||||||
| GREENLAND, Martyn Geoffrey | Amministratore | 11 York Road GL20 5HX Tewkesbury Gloucestershire | British | 45440250001 | ||||||||||
| HARLEY, Donald Wilson George | Amministratore | 22 Saint Marys Park SG8 7XB Royston Hertfordshire | British | 80358920001 | ||||||||||
| HOLDSWORTH, Roderick Antony | Amministratore | Neale Lewes Road, Scaynes Hill RH17 7NG Haywards Heath West Sussex | England | British | 98217960001 | |||||||||
| MACHIN, Brian Roy | Amministratore | Drylaw Cottage Cote Drive BS9 3UP Bristol | British | 8982230003 | ||||||||||
| MACHIN, Patricia Joan | Amministratore | 6 Redland Green Road BS6 7HE Bristol Avon | British | 63856450001 | ||||||||||
| MARKHAM, Jill Anthea | Amministratore | 3 Ivywell Road BS9 1NX Bristol Avon | British | 46788850002 | ||||||||||
| MARKHAM, Richard John | Amministratore | Castle Cote 3 Ivywell Road Sneyd Park BS9 1NX Bristol Avon | United Kingdom | British | 35544120002 | |||||||||
| MARTIN, Joseph Michael | Amministratore | 8 Mill View School Lane Eaton Socon PE19 3HJ St Neots Cambridgeshire | British | 1092550002 | ||||||||||
| MEADEN, David John | Amministratore | Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 193740420001 | |||||||||
| NOBLE, Ian Michael | Amministratore | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 199843940001 | |||||||||
| PETTIFOR, Timothy John | Amministratore | Treetops 47 Caxton End Eltisley PE19 4TJ Huntingdon Cambridgeshire | United Kingdom | British | 40366940001 | |||||||||
| RUDD, Jeremy George Winterton | Amministratore | Manor Farm Lower Lemington GL56 9NP Moreton In Marsh | United Kingdom | British | 74891640002 | |||||||||
| STIER, John Robert | Amministratore | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 78901530003 | |||||||||
| STONE, Christopher Michael Renwick | Amministratore | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 66955690003 | |||||||||
| TYDEMAN, David Rolfe | Amministratore | Burton Grange BA12 6BR Burton Wiltshire | United Kingdom | British | 123730690001 | |||||||||
| VENN, Jon | Amministratore | North Hill Cottage East Dundry Lane Dundry BS41 8NJ Bristol | British | 15778460001 | ||||||||||
| VENN, Vicki Caroline | Amministratore | North Hill Cottage East Dundry Lane BS18 8NT Bristol | British | 23230700001 | ||||||||||
| OVAL NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002560001 | |||||||||||
| OVALSEC LIMITED | Amministratore delegato nominato | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002570001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MVM HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northgate Public Services (Uk) Limited | 06 apr 2016 | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
MVM HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of accession | Creato il 29 apr 2008 Consegnato il 12 mag 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from that charging company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 11 mag 2007 Consegnato il 23 mag 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The shares and the related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 30 set 1997 Consegnato il 06 ott 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
MVM HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0