LGL 1996 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLGL 1996 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03034136
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LGL 1996 LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova LGL 1996 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Lumns Lane
    M27 8LN Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LGL 1996 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LUXFER GROUP 1996 LIMITED03 lug 200003 lug 2000
    LUXFER GROUP LIMITED03 ott 199703 ott 1997
    BRITISH ALUMINIUM HOLDINGS LIMITED04 dic 199504 dic 1995
    DMWSL 159 LIMITED16 mar 199516 mar 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di LGL 1996 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per LGL 1996 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Memorandum e Statuto

    25 pagineMA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Indirizzo della sede legale modificato da Anchorage Gateway 5 Anchorage Quay Salford M50 3XE a Lumns Lane Manchester M27 8LN in data 19 mar 2018

    2 pagineAD01

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 22 feb 2018

    • Capitale: GBP 0.01
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Nomina di Mr Jamie Mark Savage come segretario in data 01 gen 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di David Nicholas Fletcher come segretario in data 01 gen 2018

    1 pagineTM02

    Dettagli del segretario cambiati per David Nicholas Fletcher il 15 dic 2017

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Brian Gordon Purves il 15 dic 2017

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    5 pagineAA

    Nomina di David Nicholas Fletcher come segretario in data 04 mar 2016

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di Linda Frances Seddon come segretario in data 04 mar 2016

    2 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 ott 2015

    Stato del capitale al 26 ott 2015

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 ott 2014

    Stato del capitale al 17 ott 2014

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di LGL 1996 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SAVAGE, Jamie Mark
    Lumns Lane
    M27 8LN Manchester
    Segretario
    Lumns Lane
    M27 8LN Manchester
    241848520001
    PURVES, Brian Gordon
    Lumns Lane
    M27 8LN Manchester
    Amministratore
    Lumns Lane
    M27 8LN Manchester
    EnglandBritish47456240002
    BURNS, Richard
    Scalebor House
    Moor Lane
    LS29 7AF Burley In Wharfedale
    Segretario
    Scalebor House
    Moor Lane
    LS29 7AF Burley In Wharfedale
    British60673970003
    DEMBLOWSKI, Denis Anthony
    15 Chemin De La Rochette
    FOREIGN Geneva
    1202
    Switzerland
    Segretario
    15 Chemin De La Rochette
    FOREIGN Geneva
    1202
    Switzerland
    American82569240001
    FLETCHER, David Nicholas
    5 Anchorage Quay
    M50 3XE Salford
    Anchorage Gateway
    Segretario
    5 Anchorage Quay
    M50 3XE Salford
    Anchorage Gateway
    206178230001
    SEDDON, Linda Frances
    Le Petit Bois 12 Park Drive
    Hale
    WA15 9DH Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    Le Petit Bois 12 Park Drive
    Hale
    WA15 9DH Altrincham
    Cheshire
    British14578300002
    SEDDON, Linda Frances
    Le Petit Bois 12 Park Drive
    Hale
    WA15 9DH Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    Le Petit Bois 12 Park Drive
    Hale
    WA15 9DH Altrincham
    Cheshire
    British14578300002
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Segretario nominato
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    15th Floor
    Moor House 119 London Wall
    EC2Y 5ET London
    Segretario
    15th Floor
    Moor House 119 London Wall
    EC2Y 5ET London
    67382580001
    BOYLE, Tobias Humphrey James
    67 Carlton Hill
    NW8 0EN London
    Amministratore
    67 Carlton Hill
    NW8 0EN London
    EnglandBritish141831310001
    COMFORT, William Twyman
    Flat 1
    38 Pont Street
    SW1 London
    Amministratore
    Flat 1
    38 Pont Street
    SW1 London
    British53760460001
    DEMBLOWSKI, Denis Anthony
    15 Chemin De La Rochette
    FOREIGN Geneva
    1202
    Switzerland
    Amministratore
    15 Chemin De La Rochette
    FOREIGN Geneva
    1202
    Switzerland
    American82569240001
    FARGAS MAS, Lluis Maria
    Rue De Lausanne 62
    Morges
    Vaud 1110
    Switzerland
    Amministratore
    Rue De Lausanne 62
    Morges
    Vaud 1110
    Switzerland
    SwitzerlandSpanish72852990001
    FAULL, Ian Trevor
    West Chalet Groves Avenue
    Langland
    SA3 4QF Swansea
    West Glamorgan
    Amministratore
    West Chalet Groves Avenue
    Langland
    SA3 4QF Swansea
    West Glamorgan
    United KingdomBritish12734690001
    JACOB, Frances Carol
    11 Augustus Court
    Augustus Road Southfields
    SW19 6NA London
    Amministratore
    11 Augustus Court
    Augustus Road Southfields
    SW19 6NA London
    British38154840001
    MACKENZIE, Alexander Donald
    Shalden Lodge
    Shalden Lane Shalden
    GU34 4DU Alton
    Hampshire
    Amministratore
    Shalden Lodge
    Shalden Lane Shalden
    GU34 4DU Alton
    Hampshire
    United KingdomBritish105120270001
    MCKAY, Francis John
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    Amministratore
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    British78787530001
    MCKINNON, Ian Bannochie
    219 Inner Promenade
    FY8 1EA Lytham St Annes
    Lancashire
    Amministratore
    219 Inner Promenade
    FY8 1EA Lytham St Annes
    Lancashire
    EnglandBritish980160001
    MCKINNON, Ian Bannochie
    219 Inner Promenade
    FY8 1EA Lytham St Annes
    Lancashire
    Amministratore
    219 Inner Promenade
    FY8 1EA Lytham St Annes
    Lancashire
    EnglandBritish980160001
    MITCHELL, Raymond Barnes
    Av De Florimont
    20 Bis 1006
    FOREIGN Lausanne
    Switzerland
    Amministratore
    Av De Florimont
    20 Bis 1006
    FOREIGN Lausanne
    Switzerland
    American72854970001
    MURRAY, Norman Loch
    8 Pentland Avenue
    EH13 0HZ Edinburgh
    Amministratore
    8 Pentland Avenue
    EH13 0HZ Edinburgh
    ScotlandBritish22920002
    MURRAY, Norman Loch
    8 Pentland Avenue
    EH13 0HZ Edinburgh
    Amministratore
    8 Pentland Avenue
    EH13 0HZ Edinburgh
    ScotlandBritish22920002
    PURVES, Brian Gordon
    72a Macclesfield Road
    SK10 4BH Prestbury
    Cheshire
    Amministratore
    72a Macclesfield Road
    SK10 4BH Prestbury
    Cheshire
    EnglandBritish47456240002
    WHALLEY, Jeffrey
    Broncroft Castle
    Broncroft
    SY7 9HL Craven Arms
    Shropshire
    Amministratore
    Broncroft Castle
    Broncroft
    SY7 9HL Craven Arms
    Shropshire
    United KingdomBritish1955430002
    25 NOMINEES LIMITED
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    Amministratore
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    42409900001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LGL 1996 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    5, Anchorage Quay
    M50 3XE Salford
    Anchorage Gateway
    England
    06 apr 2016
    5, Anchorage Quay
    M50 3XE Salford
    Anchorage Gateway
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleUk Companies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3944037
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    LGL 1996 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage of shares
    Creato il 09 apr 1999
    Consegnato il 28 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness and liabilities of any nature of each charging company (as defined) to the chargee (as security agent and trustee for itself and the other senior finance parties) and/or any of the senior finance parties (as defined) and/or any receiver under or in connection with the senior finance documents (as defined) including without limitation,under any amendments,supplements,or restatements of any of the senior finance documents including any containing provision for new or further advances)
    Brevi particolari
    Ordinary shares of 1 irish pound each in luxfer overseas holding limited and luxfer group limited all other securities rights and monies including without limitation dividends please refer to form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 apr 1999
    Consegnato il 27 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness and other liabilities of any nature of each charging company (as defined) to the chargee in it's capacity as security agent for itself and the other senior finance parties (as defined) and/or any of the senior finance parties and/or any receiver under or in connection with the senior finance documents (as defined) (including without limitation, under any amendments, supplements or restatements of any of the senior finance documents including any containing provision for new or further advances)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 23 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture subject to and with the benefit of the intercreditor agreement
    Creato il 09 feb 1996
    Consegnato il 14 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors (or any of them) to the chargee under the finance documents (or any of them)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Agent and Trustee for Itself and the Other Beneficiaries
    Transazioni
    • 14 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0