PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED

PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03035572
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED?

    • (7020) /

    Dove si trova PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PENN HOUSE (CHELTENHAM) LIMITED 17 nov 199917 nov 1999
    WOODSFORD PROPERTIES (CHELTENHAM) LIMITED16 gen 199616 gen 1996
    WOODSFORD PROPERTIES (EDINBURGH) LIMITED21 mar 199521 mar 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Christopher George White il 01 mag 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Maurice Moses Benady il 01 mag 2010

    3 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 21 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 mag 2010

    Stato del capitale al 11 mag 2010

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Trafalgar Officers Limited il 21 mar 2010

    2 pagineCH02

    Dettagli del segretario cambiati per Reit(Corporate Services) Limited il 09 dic 2009

    1 pagineCH04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009

    5 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    13 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    4 pagine288a

    legacy

    4 pagine288a

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Segretario
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3143222
    79571870006
    BENADY, Maurice Moses
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Amministratore
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Amministratore
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    Floor 5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor 5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione6745658
    135316290001
    DENHAM, Timothy Maurice
    Flat 12
    31 Inverness Terrace
    W2 3JR London
    Segretario
    Flat 12
    31 Inverness Terrace
    W2 3JR London
    British51492670001
    HOLLAND, Philip John
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    Segretario
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    British74688330002
    LEWIS, Richard Reginald
    19 Woodsford Square
    W14 8DP London
    Segretario
    19 Woodsford Square
    W14 8DP London
    British2942350001
    WHITE, Christine
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    British74900200002
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Segretario nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    BONAVERO, Yves Jean Marc
    54 St James`S Gardens
    W11 4RA London
    Amministratore
    54 St James`S Gardens
    W11 4RA London
    EnglandFrench29119190003
    CLEGG, Barry Stuart
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish11296610002
    DOSSETT, Roger John
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish116927100001
    DUMAS, Markham Cresswell
    Curtis Farm
    Curtis Lane Headley
    GU35 8SA Bordon
    Hampshire
    Amministratore
    Curtis Farm
    Curtis Lane Headley
    GU35 8SA Bordon
    Hampshire
    United KingdomBritish31098150001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritish163838050001
    LEWIS, Richard Reginald
    19 Woodsford Square
    W14 8DP London
    Amministratore
    19 Woodsford Square
    W14 8DP London
    United KingdomBritish2942350001
    MALONE, Kenneth Daniel
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British60687110001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    PENN HOUSE (RAVENSBANK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 15 set 2004
    Consegnato il 29 set 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge the real property other than the real property listed in part ii of schedule 2 of the debenture; all plant and machinery etc. and all related property rights; all debts; all of its securities and intellectual property rights; all goodwill and uncalled capital; and the insurance policies and the insurance proceeds. By way of assignment the insurance policies and the insurance proceeds; all rental income; any guarantee of rental income contained in or relating to any lease document; any hedging arrangements; each managing agent agreement; and each building contract and all related property rights. By way of first floating charge (I) the whole of its assets present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hypo Real Estate Bank International (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 29 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 29 set 2003
    Consegnato il 11 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a unit 1 ravensbank business park ravensbank drive redditch t/n WR58721. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 set 2003
    Consegnato il 11 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0