LANGSTONE LEISURE LIMITED

LANGSTONE LEISURE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLANGSTONE LEISURE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03037436
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LANGSTONE LEISURE LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova LANGSTONE LEISURE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Kroll Advisory Ltd. The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LANGSTONE LEISURE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TOTAL FITNESS UK LIMITED24 mar 199524 mar 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di LANGSTONE LEISURE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per LANGSTONE LEISURE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    13 pagineLIQ13

    Dichiarazione di solvibilità

    4 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da 3 Denmark Street Altrincham WA14 2SS England a Kroll Advisory Ltd. the Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG in data 23 set 2023

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 14 set 2023

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 mar 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Notifica di Albert Gubay Trustee Limited come persona con controllo significativo il 20 lug 2021

    2 paginePSC02

    Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 24 mar 2023

    2 paginePSC09

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 mar 2022

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Martyn Edward Quayle come segretario in data 05 ott 2022

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Martyn Edward Quayle come amministratore in data 05 ott 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Lukasz Weckwerth come segretario in data 04 ott 2022

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Robin Gardener Johnson come amministratore in data 04 ott 2022

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Lukasz Weckwerth come amministratore in data 04 ott 2022

    2 pagineAP01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di LANGSTONE LEISURE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WECKWERTH, Lukasz
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Kroll Advisory Ltd. The Shard
    Segretario
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Kroll Advisory Ltd. The Shard
    300828330001
    JOHNSON, Robin Gardener
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Kroll Advisory Ltd. The Shard
    Amministratore
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Kroll Advisory Ltd. The Shard
    EnglandBritishManaging Director285089530001
    WECKWERTH, Lukasz
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Kroll Advisory Ltd. The Shard
    Amministratore
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Kroll Advisory Ltd. The Shard
    Isle Of ManBritishFinance Director300827970001
    BARR, Christopher Stewart
    26 Woodbourne Court
    Woodbourne Court
    IM2 3AT Douglas
    Isle Of Man
    Segretario
    26 Woodbourne Court
    Woodbourne Court
    IM2 3AT Douglas
    Isle Of Man
    BritishIn House Solicitor91753940001
    HARVEY, Ben Desmond
    10 Heathfield Road
    Wavertree
    L15 9EZ Liverpool
    Merseyside
    Segretario
    10 Heathfield Road
    Wavertree
    L15 9EZ Liverpool
    Merseyside
    BritishCompany Secretary43404640002
    NEOH, Christopher
    20 Observatory Road
    East Sheen
    SW14 7QD London
    Segretario
    20 Observatory Road
    East Sheen
    SW14 7QD London
    BritishCompany Director42703230001
    PEERS, John Brian
    Springfield, 19 Chester Road
    Sutton Weaver
    WA7 3EE Runcorn
    Cheshire
    Segretario
    Springfield, 19 Chester Road
    Sutton Weaver
    WA7 3EE Runcorn
    Cheshire
    BritishChartered Accountant88448730001
    QUAYLE, Martyn Edward
    Old Castletown Road
    Douglas
    IM2 1QA Isle Of Man
    Nunnery Mills 1
    Isle Of Man
    Segretario
    Old Castletown Road
    Douglas
    IM2 1QA Isle Of Man
    Nunnery Mills 1
    Isle Of Man
    284792080001
    QUAYLE, Martyn Edward
    c/o C/O The Management Office
    Walkden
    M28 5BB Manchester
    Walkden Town Centre
    Segretario
    c/o C/O The Management Office
    Walkden
    M28 5BB Manchester
    Walkden Town Centre
    213577730001
    SPENCE, Susan Marilyn
    8 Rosse Field House
    BD9 4EF Bradford
    West Yorkshire
    Segretario
    8 Rosse Field House
    BD9 4EF Bradford
    West Yorkshire
    BritishPa25780410001
    SWEENEY, Sarah Jane
    Denmark Street
    WA14 2SS Altrincham
    3
    England
    Segretario
    Denmark Street
    WA14 2SS Altrincham
    3
    England
    233899450001
    WILLERS, Peter Alan
    Ballagawne Farm
    Garwick
    IM4 6EP Lonan
    Isle Of Man
    Segretario
    Ballagawne Farm
    Garwick
    IM4 6EP Lonan
    Isle Of Man
    BritishLawyer61606290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALKIN, Lawrence Michael
    Flat E101, Montevetro Building
    100 Battersea Church Road
    SW11 3YL London
    Amministratore
    Flat E101, Montevetro Building
    100 Battersea Church Road
    SW11 3YL London
    United KingdomBritishCompany Director104119320001
    BARR, Christopher Stewart
    26 Woodbourne Court
    Woodbourne Court
    IM2 3AT Douglas
    Isle Of Man
    Amministratore
    26 Woodbourne Court
    Woodbourne Court
    IM2 3AT Douglas
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritishIn House Solicitor91753940001
    BATH, Alan William
    Glen Garth
    IM4 1BE Port Soderick Glen
    Isle Of Man
    Amministratore
    Glen Garth
    IM4 1BE Port Soderick Glen
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritishChartered Accountant124856260002
    CARNEY, Gerard Paul
    The Ellesmere Centre
    Walkden
    M28 5BB Manchester
    C/O The Management Office
    Amministratore
    The Ellesmere Centre
    Walkden
    M28 5BB Manchester
    C/O The Management Office
    United KingdomBritishChartered Surveyor81390850002
    FISHER, Allan Brian Henry, Mr.
    52 Northgate
    Prince Albert Road
    NW8 7EH London
    Amministratore
    52 Northgate
    Prince Albert Road
    NW8 7EH London
    EnglandBritishCompany Director26461710001
    HERRING, Patrick Richard
    21 Westminster Terrace
    IM1 4EE Douglas
    Isle Of Man
    Amministratore
    21 Westminster Terrace
    IM1 4EE Douglas
    Isle Of Man
    BritishCompany Director91249230001
    JOHNSON, Robin Gardner
    Wellington Barn
    Mill Hill Road
    CH61 4XQ Irby
    Merseyside
    Amministratore
    Wellington Barn
    Mill Hill Road
    CH61 4XQ Irby
    Merseyside
    United KingdomBritishSurveyor99321940001
    LYONS, David John
    c/o C/O The Management Office
    Walkden
    M28 5BB Manchester
    Walkden Town Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o C/O The Management Office
    Walkden
    M28 5BB Manchester
    Walkden Town Centre
    United Kingdom
    Isle Of ManIrishCompany Director171101080002
    MASON, Geoffrey Owen
    Hilthorpe Kings Drive
    Caldy
    CH48 2JH Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    Hilthorpe Kings Drive
    Caldy
    CH48 2JH Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritishSurveyor6007920001
    PEERS, John Brian
    Springfield, 19 Chester Road
    Sutton Weaver
    WA7 3EE Runcorn
    Cheshire
    Amministratore
    Springfield, 19 Chester Road
    Sutton Weaver
    WA7 3EE Runcorn
    Cheshire
    United KingdomBritishChartered Accountant88448730001
    QUAYLE, Martyn Edward
    Denmark Street
    WA14 2SS Altrincham
    3
    England
    Amministratore
    Denmark Street
    WA14 2SS Altrincham
    3
    England
    Isle Of ManBritishBanker170381060001
    QUAYLE, Martyn Edward
    Thirlmere Avenue
    Lakeside Gardens
    IM3 2DP Onchan
    26
    Isle Of Man
    Isle Of Man
    Amministratore
    Thirlmere Avenue
    Lakeside Gardens
    IM3 2DP Onchan
    26
    Isle Of Man
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritishBanker170381060001
    SPENCE, Gary
    8 Rossefield House
    Park Drive
    BD9 4LF Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    8 Rossefield House
    Park Drive
    BD9 4LF Bradford
    West Yorkshire
    BritishProperty Manager55077200001
    SPENCE, Susan Marilyn
    8 Rosse Field House
    BD9 4EF Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    8 Rosse Field House
    BD9 4EF Bradford
    West Yorkshire
    BritishPa25780410001
    SUTTON, John Maurice
    c/o C/O The Management Office
    Walkden
    M28 5BB Manchester
    Walkden Town Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o C/O The Management Office
    Walkden
    M28 5BB Manchester
    Walkden Town Centre
    United Kingdom
    Isle Of ManBritishAccountant193015210001
    SWEENEY, Sarah Jane
    Denmark Street
    WA14 2SS Altrincham
    3
    England
    Amministratore
    Denmark Street
    WA14 2SS Altrincham
    3
    England
    United KingdomBritishSolicitor161270580001
    TAYLOR, John Edmund
    The Ellesmere Centre
    Walkden
    M28 5BB Manchester
    C/O The Management Office
    Amministratore
    The Ellesmere Centre
    Walkden
    M28 5BB Manchester
    C/O The Management Office
    United KingdomBritishChartered Surveyor35551550004
    TWIZELL, Krystina Louise
    The Ellesmere Centre
    Walkden
    M28 5BB Manchester
    C/O The Management Office
    Amministratore
    The Ellesmere Centre
    Walkden
    M28 5BB Manchester
    C/O The Management Office
    Isle Of ManBritishLawyer148789130001
    WILLERS, Peter Alan
    Ballagawne Farm
    IM4 6EP Baldrine
    Isle Of Man
    Amministratore
    Ballagawne Farm
    IM4 6EP Baldrine
    Isle Of Man
    BritishLawyer56266670001
    WILSON, Trevor Wallace
    The Ellesmere Centre
    Walkden
    M28 5BB Manchester
    C/O The Management Office
    Amministratore
    The Ellesmere Centre
    Walkden
    M28 5BB Manchester
    C/O The Management Office
    Isle Of ManBritishDirector155702590001
    WOOLLEY, Ian Lee
    Booilushag
    Ballajora
    IM7 1BD Maughold
    Seapoint
    Isle Of Man
    Isle Of Man
    Amministratore
    Booilushag
    Ballajora
    IM7 1BD Maughold
    Seapoint
    Isle Of Man
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritishCompany Secretary132278790001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LANGSTONE LEISURE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Denmark Street
    WA14 2SS Altrincham
    3
    England
    20 lug 2021
    Denmark Street
    WA14 2SS Altrincham
    3
    England
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Guarantee
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione13289300
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per LANGSTONE LEISURE LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    15 mar 201721 lug 2021La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    LANGSTONE LEISURE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 20 dic 2001
    Consegnato il 22 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £5,743,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage 6.3 acres of land being all that f/h land and buildings lying to the north of whisby road skellingthorpe north kesteven lincolnshire t/n LL205128.by way of floating charge all moveable plant machinery implements buildings materials of all kinds utensils furniture and equipment now or from time to time placed on or used in or about the property and belonging to the mortgagor.
    Persone aventi diritto
    • Celtic Bank Limited
    Transazioni
    • 22 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 18 set 2001
    Consegnato il 19 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £6,281,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the charge
    Brevi particolari
    L/H land and buildings on the north side of lloyd street altrincham t/no.GM860682 and by way of specific charge all the income from time to time arising from the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Celtic Bank Limited
    Transazioni
    • 19 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 18 set 2001
    Consegnato il 19 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £6,039,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee.
    Brevi particolari
    All that f/h property at prenton way, wirral being the land and buildings comprised in (1) part of the land on the west side of prenton way, prenton t/no MS414644. (2) part of the land lying to the west side of durley drive, landican, birkenhead t/no CH73727 and by way of specific charge all the income, and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Celtic Bank Limited
    Transazioni
    • 19 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 12 set 2001
    Consegnato il 13 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Five million and fifty five thousand pounds and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the legal mortgage
    Brevi particolari
    The land and/or property being the land lying to the south east of caton road and by way of specific charge all the income from time to time and the proceeds of any sale lease or other disposition thereof and all deeds and documents relating thereto and all insurance and compensation monies.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Celtic Bank Limited
    Transazioni
    • 13 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 25 apr 2001
    Consegnato il 26 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £5,679,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee in relation to this charge
    Brevi particolari
    3.987 acres of land being part of the land on and lying to the north of wares meeting road tonge bolton t/no: GM813581 .. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Celtic Bank Limited
    Transazioni
    • 26 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 08 gen 2001
    Consegnato il 10 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £4,930,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    (1) the land and/or property being part of units 6 and 8 ellesmere retail park, walkden, greater manchester t/n GM855292 and (2) the land and/or property being part of units 6 and 8 ellesmere retail park, walkden, greater manchester t/n GM839910 and by way of specific charge all the income from time to time arising and the proceeds of any sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Celtic Bank Limited
    Transazioni
    • 10 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 05 gen 2001
    Consegnato il 10 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £5,488,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    First legal charge the land between dunnings bridge road and sefton estate perimeter road bootle mersyside t/n MS437434 by way of specific charge all income, the proceeds of sale lease or other disposition, all deed and documents relating thereto and all insurance and compensation monies floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Celtic Bank Limited
    Transazioni
    • 10 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 02 gen 2001
    Consegnato il 03 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £5,525,000.00 and all other sums due from the company to the chargee in relation to this charge
    Brevi particolari
    First legal mortgage over land at the leisure centre,edge lane retail park,liverpool; t/no MS433293; all income payable thereon and all deeds/documents. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Celtic Bank Limited
    Transazioni
    • 03 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 21 set 2000
    Consegnato il 29 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £6,371,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The land lying to the north of kerfoot street warrington t/n CH207667 232WINWICK road warrington t/n CH108598 234 winwick road warrington t/NCH108601 236WINWICK road warrington t/n CH108599 and by way of specific charge all income from time to time arising or payable in relation to the property and the proceeds of sale lease or other disposition in respect there of and all deeds and documents.
    Persone aventi diritto
    • Celtic Bank Limited
    Transazioni
    • 29 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 21 set 2000
    Consegnato il 23 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £5,055,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H land at cumbrian works garden road wrexham t/no WA929756 and f/h land on the south west side of stansty road rhosddu wrexham t/no WA61695 and by way of specific charge all the income from time to time arising or payable in relation to the property and the proceeds of sale lease or other disposition in respect thereof and all deeds and documents from time to time relating thereto and all insurance and compensation monies and by way of. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Celtic Bank Limited
    Transazioni
    • 23 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 29 ago 2000
    Consegnato il 14 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The sum of £6,064,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The land on the south side of wakefield road, waterloo, kirkburton huddersfield t/n WYK96497 and by way of specific charge all income and the proceeds of sale lease or other disposition, all deeds and documents relating thereto and all insurance and compensation monies. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Celtic Bank Limited
    Transazioni
    • 14 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 29 ago 2000
    Consegnato il 14 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The sum of £5,959,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The property k/a land on the east side of warrington road, goose green, wigan t/n GM831213 and by way of specific charge all income, the proceeds of sale lease or other disposition, all deed and documents relating thereto and all insurance and compensation monies. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Celtic Bank Limited
    Transazioni
    • 14 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 29 ago 2000
    Consegnato il 14 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The sum of £5,537,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The land on the north east side of parkgate road chester t/n CH236318, and by way of specific charge all income, the proceeds of sale lease or other disposition, all deed and documents relating thereto and all insurance and compensation monies. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Celtic Bank Limited
    Transazioni
    • 14 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 29 ago 2000
    Consegnato il 14 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The sum of £5,537,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The property k/a land at parkland industrial, newcastle road trent vale t/n SF277327 SF372833 and SF327674, by way of specific charge all income and the proceeds of sale lease or other disposition, all deeds and documents relating thereto and all insurance and compensation monies. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Celtic Bank Limited
    Transazioni
    • 14 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 22 dic 1999
    Consegnato il 11 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £10,900,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Two parcels of lane off dairyhouse lane cheadle hulme cheadle cheshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Celtic Bank Limited
    Transazioni
    • 11 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 21 lug 1999
    Consegnato il 23 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £10,900,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the facility letter
    Brevi particolari
    The leasehold property being 8.326 acres of land at dairyhouse lane, cheadle hulme cheadle, cheshire title number CH210971.
    Persone aventi diritto
    • Celtic Bank Limited
    Transazioni
    • 23 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    LANGSTONE LEISURE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 set 2023Inizio della liquidazione
    10 lug 2024Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Edward Robert Bines
    Kroll Advisory Ltd The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praticante
    Kroll Advisory Ltd The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Paul David Williams
    The Shard, 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praticante
    The Shard, 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0