KMFM FOLKESTONE LIMITED

KMFM FOLKESTONE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKMFM FOLKESTONE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03038516
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KMFM FOLKESTONE LIMITED?

    • Radiodiffusione (60100) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova KMFM FOLKESTONE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Medway House Sir Thomas Longley Road
    Medway City Estate
    ME2 4DU Strood
    Kent
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KMFM FOLKESTONE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SOUTH EAST RADIO LIMITED28 mar 199528 mar 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di KMFM FOLKESTONE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per KMFM FOLKESTONE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2016

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 ago 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio annuale redatto al 28 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 apr 2016

    Stato del capitale al 13 apr 2016

    • Capitale: GBP 403,100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2015

    3 pagineAA

    Nomina di Mr Duncan Gray come segretario in data 30 gen 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Sarah Hill come segretario in data 30 gen 2016

    1 pagineTM02

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio annuale redatto al 28 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 apr 2015

    Stato del capitale al 15 apr 2015

    • Capitale: GBP 403,100
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 apr 2014

    Stato del capitale al 24 apr 2014

    • Capitale: GBP 403,100
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2013

    6 pagineAA

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2012 al 30 giu 2013

    1 pagineAA01

    Iscrizione dell'ipoteca 030385160004

    56 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 28 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Nomina di Sarah Hill come segretario

    3 pagineAP03

    Indirizzo della sede legale modificato da * Messenger House New Hythe Lane Larkfield Aylesford Kent ME20 6SG* in data 22 giu 2012

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Richard Elliot come segretario

    2 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 28 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di KMFM FOLKESTONE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GRAY, Duncan
    Old Road West
    DA11 0LJ Gravesend
    Oban Lodge
    Kent
    England
    Segretario
    Old Road West
    DA11 0LJ Gravesend
    Oban Lodge
    Kent
    England
    205278470001
    ALLINSON, Geraldine Ruth Pratt
    Stone Stile
    Hart Hill Charing
    TN27 0HW Ashford
    Kent
    Amministratore
    Stone Stile
    Hart Hill Charing
    TN27 0HW Ashford
    Kent
    EnglandBritish81172780001
    ELLIOT, Richard Emmerson
    Orchard House
    2 Richardson Close, Mill Drove
    PE10 9YN Bourne
    Lincolnshire
    Amministratore
    Orchard House
    2 Richardson Close, Mill Drove
    PE10 9YN Bourne
    Lincolnshire
    United KingdomBritish40591070005
    DEXTER, Roy
    9 Simon Avenue
    Cliftonville
    CT9 3DT Margate
    Kent
    Segretario
    9 Simon Avenue
    Cliftonville
    CT9 3DT Margate
    Kent
    British39850890001
    ELLIOT, Richard Emmerson
    Orchard House
    2 Richardson Close, Mill Drove
    PE10 9YN Bourne
    Lincolnshire
    Segretario
    Orchard House
    2 Richardson Close, Mill Drove
    PE10 9YN Bourne
    Lincolnshire
    British40591070005
    EMERY, Wendy Jill
    3 Warnford Gardens
    Loose
    ME15 6PH Maidstone
    Kent
    Segretario
    3 Warnford Gardens
    Loose
    ME15 6PH Maidstone
    Kent
    British57934630001
    HILL, Sarah
    Plough Wents Road
    Chart Sutton
    ME17 3RY Maidstone
    York House
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Plough Wents Road
    Chart Sutton
    ME17 3RY Maidstone
    York House
    Kent
    United Kingdom
    British170093610001
    HOLLIS, Jeremy William
    "Eachway"
    Slip Lane, Alkham
    CT15 7DA Dover
    Kent
    Segretario
    "Eachway"
    Slip Lane, Alkham
    CT15 7DA Dover
    Kent
    British16859350004
    SHIPLEY, Thomas John
    Brokers Cannongate Road
    CT21 5PJ Hythe
    Kent
    Segretario
    Brokers Cannongate Road
    CT21 5PJ Hythe
    Kent
    British42680440001
    SMITHERS, James Brian
    26 Grace Avenue
    DA7 4NN Bexleyheath
    Kent
    Segretario
    26 Grace Avenue
    DA7 4NN Bexleyheath
    Kent
    British16069770001
    WATERHOUSE, Ann Marguerite
    32 Warelands
    RH15 9QD Burgess Hill
    West Sussex
    Segretario
    32 Warelands
    RH15 9QD Burgess Hill
    West Sussex
    British67890250002
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    AUSTIN, Edward John
    14 Crabble Avenue
    CT17 0JD Dover
    Kent
    Amministratore
    14 Crabble Avenue
    CT17 0JD Dover
    Kent
    British42680530001
    BRIGGS, Mark Francis
    6 Cadogan Gardens
    TN1 2UL Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    6 Cadogan Gardens
    TN1 2UL Tunbridge Wells
    Kent
    British56901140003
    BROWNING, Mark David
    80 John Archer Way
    SW18 2TT London
    Amministratore
    80 John Archer Way
    SW18 2TT London
    British98542150001
    CLUBLEY, Simon
    Richmond House
    School Road Charing
    TN20 0HU Ashford
    Kent
    Amministratore
    Richmond House
    School Road Charing
    TN20 0HU Ashford
    Kent
    United KingdomBritish79409730001
    DE CARLE, Gavin
    32 Saint Josephs Vale
    SE3 0XF London
    Amministratore
    32 Saint Josephs Vale
    SE3 0XF London
    British81293630001
    DEXTER, Roy
    9 Simon Avenue
    Cliftonville
    CT9 3DT Margate
    Kent
    Amministratore
    9 Simon Avenue
    Cliftonville
    CT9 3DT Margate
    Kent
    British39850890001
    DICKENS, Charles Timothy Gordon
    29 Castle Avenue
    CT16 1HA Dover
    Kent
    Amministratore
    29 Castle Avenue
    CT16 1HA Dover
    Kent
    British53990710001
    DORRELL, William James
    Lane Farm Mill House Lane
    Addington
    ME19 5BA West Malling
    Kent
    Amministratore
    Lane Farm Mill House Lane
    Addington
    ME19 5BA West Malling
    Kent
    British16069820001
    FRAYNE, Roger
    10 Lorne Road
    CT16 2AA Dover
    Kent
    Amministratore
    10 Lorne Road
    CT16 2AA Dover
    Kent
    British46942120001
    GRANT, John Douglas
    Branscombe Greenbank
    Upper St Kingsdown
    CT14 8BJ Deal
    Kent
    Amministratore
    Branscombe Greenbank
    Upper St Kingsdown
    CT14 8BJ Deal
    Kent
    British42897480002
    HOLLIS, Jeremy William
    "Eachway"
    Slip Lane, Alkham
    CT15 7DA Dover
    Kent
    Amministratore
    "Eachway"
    Slip Lane, Alkham
    CT15 7DA Dover
    Kent
    United KingdomBritish16859350004
    KERR, Elisabeth Margaret
    1 Granville Villas Lees Road
    Brabourne Lees
    TN25 6QE Ashford
    Kent
    Amministratore
    1 Granville Villas Lees Road
    Brabourne Lees
    TN25 6QE Ashford
    Kent
    British46973580003
    LEUTNER, Peter Nicholas
    Mistletoe Cottage Maxted Street
    Stelling Minnis
    CT4 6DH Canterbury
    Kent
    Amministratore
    Mistletoe Cottage Maxted Street
    Stelling Minnis
    CT4 6DH Canterbury
    Kent
    EnglandBritish42897450001
    LEWIS, David Dean
    Old Caring
    Caring Road Leeds
    ME17 1TH Maidstone
    Kent
    Amministratore
    Old Caring
    Caring Road Leeds
    ME17 1TH Maidstone
    Kent
    British37803230003
    LINES, Phillip William Edward
    13 Saw Lodge Field
    Kingsnorth
    TN23 3PB Ashford
    Kent
    Amministratore
    13 Saw Lodge Field
    Kingsnorth
    TN23 3PB Ashford
    Kent
    United KingdomBritish147118190001
    LLOYD, Humphrey Alexander
    The Old Coach House
    Wycombe Road Studley Green
    HP14 3XB High Wycombe
    Amministratore
    The Old Coach House
    Wycombe Road Studley Green
    HP14 3XB High Wycombe
    British22345580004
    MALAN, Anthony Peter
    Ravencroft Cannongate Avenue
    CT21 5PS Hythe
    Kent
    Amministratore
    Ravencroft Cannongate Avenue
    CT21 5PS Hythe
    Kent
    British42897370001
    MCCARTNEY, Paul Robert
    7 Frinstead Walk
    Allington
    ME16 0NN Maidstone
    Kent
    Amministratore
    7 Frinstead Walk
    Allington
    ME16 0NN Maidstone
    Kent
    British72896880001
    MEREDITH, Derek
    Kestrels The Droveway
    St Margarets Bay
    CT15 6BZ Dover
    Kent
    Amministratore
    Kestrels The Droveway
    St Margarets Bay
    CT15 6BZ Dover
    Kent
    British31721520001
    SMITHERS, James Brian
    26 Grace Avenue
    DA7 4NN Bexleyheath
    Kent
    Amministratore
    26 Grace Avenue
    DA7 4NN Bexleyheath
    Kent
    EnglandBritish16069770001
    WEST, Christopher John
    25 Kings Road
    CT7 0DU Birchington
    Kent
    Amministratore
    25 Kings Road
    CT7 0DU Birchington
    Kent
    British42897400001
    WILLIAMS, Penelope Jane
    1 Royton Avenue
    ME17 2PS Lenham
    Kent
    Amministratore
    1 Royton Avenue
    ME17 2PS Lenham
    Kent
    United KingdomBritish222750600001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Amministratore delegato nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per KMFM FOLKESTONE LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    26 ago 2016La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società.

    KMFM FOLKESTONE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 30 giu 2013
    Consegnato il 05 lug 2013
    In corso
    Breve descrizione
    N/A. notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 13 gen 2010
    Consegnato il 26 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Geraldine Ruth Pratt Allinson Elizabeth Lawson Cecilia Buchanan and Henry Boorman
    Transazioni
    • 26 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 02 apr 2009
    Consegnato il 15 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 02 apr 2009
    Consegnato il 15 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0