GRIPPERRODS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | GRIPPERRODS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03041925 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GRIPPERRODS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova GRIPPERRODS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Pearl Assurance House 319 Ballards Lane N12 8LY London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GRIPPERRODS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ARLESHAW LIMITED | 04 apr 1995 | 04 apr 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GRIPPERRODS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per GRIPPERRODS LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per GRIPPERRODS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 8 pagine | 4.71 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 ago 2015 | 8 pagine | 4.68 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 ago 2014 | 8 pagine | 4.68 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Pinnacle House First Floor 17-25 Hartfield Road Wimbledon London SW19 3SE United Kingdom* in data 30 ago 2013 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 dic 2012 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 21 pagine | CC04 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 23 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 dic 2011 con elenco completo degli azionisti | 9 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Hopster come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Elizabeth Honor Lewzey come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael John Hopster come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Elizabeth Honor Lewzey il 04 lug 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Nicolas Paul Wilkinson come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Thomas C. Reeve come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Elizabeth Honor Lewzey come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Flanagan come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * East Putney House 84 Upper Richmond Road London SW15 2ST* in data 07 lug 2011 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Denise Burton come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Michael John Hopster come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di GRIPPERRODS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWZEY, Elizabeth Honor | Segretario | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | 165833030001 | |||||||
| LEWZEY, Elizabeth Honor | Amministratore | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | England | British | 59381700003 | |||||
| REEVE, Thomas C. | Amministratore | Wewatta Street 80202 Denver 1551 Colorado Usa | United States | American | 161822390001 | |||||
| WILKINSON, Nicolas Paul | Amministratore | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | England | British | 48808690001 | |||||
| BURTON, Denise Patricia | Segretario | Warren Close Coombe Hill Road KT2 7DY Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570004 | ||||||
| HOPSTER, Michael John | Segretario | 40 Brooksbys Walk E9 6DF London Flat B United Kingdom | 157103010001 | |||||||
| LAU, Cheong Koon | Segretario | 40 Strongbow Road Eltham SE9 1DT London | Malaysian | 16337610001 | ||||||
| PAUL, Simon George | Segretario | Spinney Cottage Station Road CV13 0NP Market Bosworth Warwickshire | British | 154423590001 | ||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario nominato | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||
| BURTON, Denise Patricia | Amministratore | Warren Close Coombe Hill Road KT2 7DY Kingston Upon Thames Surrey | United Kingdom | British | 47432570004 | |||||
| DUNCAN, Ian Alexander | Amministratore | Durham House Durham Place SW3 4ET London | United Kingdom | British | 27300002 | |||||
| FARRELL, William Michael | Amministratore | 7 Craigvale Court DG1 4QH Dumfries | British | 62063670001 | ||||||
| FLANAGAN, Paul Edward | Amministratore | Flat 9 19 Holland Park W11 3TD London | United Kingdom | British | 69281780002 | |||||
| HAZARD, George Anthony | Amministratore | 46 Broad Oaks Road B91 1JB Solihull West Midlands | British | 6369950001 | ||||||
| HOPSTER, Michael John | Amministratore | Flat B 40 Brooksbys Walk E9 6DF London | United Kingdom | British | 77921850004 | |||||
| HOUGHTON, Paul David | Amministratore | 2 Mayfield Court Formby L37 7JL Liverpool Merseyside | British | 95097460001 | ||||||
| JACKSON, Pearse | Amministratore | 3 Woodside Parkgate DG1 3LY Dumfries | Irish | 61362400001 | ||||||
| LEES, Peter Bryce | Amministratore | 6 Jerviswood ML1 4AJ Motherwell Lanarkshire | British | 26615220001 | ||||||
| MARCHANT, Richard Norman | Amministratore | 60 The Mount Curdworth B76 9HR Sutton Coldfield West Midlands | British | 26880001 | ||||||
| MOULDS, Peter John | Amministratore | 2 Millside Slitting Mill WS15 2FG Rugeley Staffordshire | British | 31029500002 | ||||||
| OWEN, David Evan Penrhyn | Amministratore | The Old Barn Church Lane S81 9EH Carlton In Lindrick Nottinghamshire | British | 73849580001 | ||||||
| PAUL, Simon George | Amministratore | Spinney Cottage Station Road CV13 0NP Market Bosworth Warwickshire | England | British | 154423590001 | |||||
| PERSSON, Jan Allan | Amministratore | 3 Wayside SW14 7LN London | Swedish | 6650000001 | ||||||
| PORTER, Norman Charles | Amministratore | Farnham House 2 Beedingwood Drive Forest Road Colgate RH12 4TE Horsham West Sussex | England | British | 445360034 | |||||
| ROBB, Kenneth | Amministratore | 2 Glentruim View KA2 0LL Kilmarnock Ayrshire | British | 61362350001 | ||||||
| SACK, Adam David | Amministratore | 115 Broadhurst Gardens NW6 3BJ London | British | 32459700002 | ||||||
| STANSFIELD, Neil Andrew | Amministratore | The Laurels, Poets Way Newnham NN11 3HQ Daventry Northamptonshire | British | 79347560001 | ||||||
| WIEGMAN, Albert Edward Bernard | Amministratore | 17 Hills Avenue CB1 7UY Cambridge | British | 7466220002 | ||||||
| COMBINED NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
GRIPPERRODS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over credit balances | Creato il 24 apr 1998 Consegnato il 07 mag 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The sum of £33,000 together with interest accrued now or to be held by national westmister bank PLC on an account numbered 94897077 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 13 gen 1998 Consegnato il 21 gen 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under this mortgage debenture or in connection with a counter indemnity of even date | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over credit balances | Creato il 10 nov 1997 Consegnato il 24 nov 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The sum of £41,300 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 94897077 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed charge on discounted debts and a floating charge on the receipts of other debts | Creato il 23 ott 1997 Consegnato il 30 ott 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an invoice discounting agreement (as therein defined) or otherwise | |
Brevi particolari Fixed equitable charge (I) all debts the subject of an invoice discounting agreement between the company and the chargee that fail to vest in the chargee and all rights in favour of the company related to such debts and (ii) all other amounts owing and all rights relating to such amounts, floating charge such of the moneys received in respect of amounts referred to in (ii) above as shall stand released from the fixed equitable charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattels mortgage | Creato il 05 giu 1995 Consegnato il 17 giu 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company (formerly known as arleshaw limited) to the chargee under the terms of a credit sale agreement dated 12TH september 1991 and a novation agreement dated 5TH june 1995 | |
Brevi particolari The sponge rubber underlay production line situated at the company's premises at walkmill lane, cannock, staffordshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 05 giu 1995 Consegnato il 15 giu 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company (formerly known as arleshaw limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Factory warehouse and office premises forming part of the industrial estate at walkmill lane cannock staffordshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
GRIPPERRODS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0