GRIPPERRODS LIMITED

GRIPPERRODS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGRIPPERRODS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03041925
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GRIPPERRODS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova GRIPPERRODS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Pearl Assurance House
    319 Ballards Lane
    N12 8LY London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GRIPPERRODS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ARLESHAW LIMITED04 apr 199504 apr 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di GRIPPERRODS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per GRIPPERRODS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per GRIPPERRODS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 ago 2015

    8 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 ago 2014

    8 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da * Pinnacle House First Floor 17-25 Hartfield Road Wimbledon London SW19 3SE United Kingdom* in data 30 ago 2013

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 dic 2012

    Stato del capitale al 17 dic 2012

    • Capitale: GBP 9,806,459
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    21 pagineCC04

    Risoluzioni

    Resolutions
    23 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01

    Cessazione della carica di Michael Hopster come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Elizabeth Honor Lewzey come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Michael John Hopster come segretario

    1 pagineTM02

    Dettagli del direttore cambiati per Elizabeth Honor Lewzey il 04 lug 2011

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Nomina di Nicolas Paul Wilkinson come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Thomas C. Reeve come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Elizabeth Honor Lewzey come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Paul Flanagan come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * East Putney House 84 Upper Richmond Road London SW15 2ST* in data 07 lug 2011

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Denise Burton come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Michael John Hopster come segretario

    2 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di GRIPPERRODS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LEWZEY, Elizabeth Honor
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    Segretario
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    165833030001
    LEWZEY, Elizabeth Honor
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    Amministratore
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish59381700003
    REEVE, Thomas C.
    Wewatta Street
    80202 Denver
    1551
    Colorado
    Usa
    Amministratore
    Wewatta Street
    80202 Denver
    1551
    Colorado
    Usa
    United StatesAmerican161822390001
    WILKINSON, Nicolas Paul
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    Amministratore
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish48808690001
    BURTON, Denise Patricia
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570004
    HOPSTER, Michael John
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Flat B
    United Kingdom
    Segretario
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Flat B
    United Kingdom
    157103010001
    LAU, Cheong Koon
    40 Strongbow Road
    Eltham
    SE9 1DT London
    Segretario
    40 Strongbow Road
    Eltham
    SE9 1DT London
    Malaysian16337610001
    PAUL, Simon George
    Spinney Cottage
    Station Road
    CV13 0NP Market Bosworth
    Warwickshire
    Segretario
    Spinney Cottage
    Station Road
    CV13 0NP Market Bosworth
    Warwickshire
    British154423590001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Segretario nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    BURTON, Denise Patricia
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritish47432570004
    DUNCAN, Ian Alexander
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    Amministratore
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    United KingdomBritish27300002
    FARRELL, William Michael
    7 Craigvale Court
    DG1 4QH Dumfries
    Amministratore
    7 Craigvale Court
    DG1 4QH Dumfries
    British62063670001
    FLANAGAN, Paul Edward
    Flat 9
    19 Holland Park
    W11 3TD London
    Amministratore
    Flat 9
    19 Holland Park
    W11 3TD London
    United KingdomBritish69281780002
    HAZARD, George Anthony
    46 Broad Oaks Road
    B91 1JB Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    46 Broad Oaks Road
    B91 1JB Solihull
    West Midlands
    British6369950001
    HOPSTER, Michael John
    Flat B
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Amministratore
    Flat B
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    United KingdomBritish77921850004
    HOUGHTON, Paul David
    2 Mayfield Court
    Formby
    L37 7JL Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    2 Mayfield Court
    Formby
    L37 7JL Liverpool
    Merseyside
    British95097460001
    JACKSON, Pearse
    3 Woodside
    Parkgate
    DG1 3LY Dumfries
    Amministratore
    3 Woodside
    Parkgate
    DG1 3LY Dumfries
    Irish61362400001
    LEES, Peter Bryce
    6 Jerviswood
    ML1 4AJ Motherwell
    Lanarkshire
    Amministratore
    6 Jerviswood
    ML1 4AJ Motherwell
    Lanarkshire
    British26615220001
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    MOULDS, Peter John
    2 Millside
    Slitting Mill
    WS15 2FG Rugeley
    Staffordshire
    Amministratore
    2 Millside
    Slitting Mill
    WS15 2FG Rugeley
    Staffordshire
    British31029500002
    OWEN, David Evan Penrhyn
    The Old Barn
    Church Lane
    S81 9EH Carlton In Lindrick
    Nottinghamshire
    Amministratore
    The Old Barn
    Church Lane
    S81 9EH Carlton In Lindrick
    Nottinghamshire
    British73849580001
    PAUL, Simon George
    Spinney Cottage
    Station Road
    CV13 0NP Market Bosworth
    Warwickshire
    Amministratore
    Spinney Cottage
    Station Road
    CV13 0NP Market Bosworth
    Warwickshire
    EnglandBritish154423590001
    PERSSON, Jan Allan
    3 Wayside
    SW14 7LN London
    Amministratore
    3 Wayside
    SW14 7LN London
    Swedish6650000001
    PORTER, Norman Charles
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish445360034
    ROBB, Kenneth
    2 Glentruim View
    KA2 0LL Kilmarnock
    Ayrshire
    Amministratore
    2 Glentruim View
    KA2 0LL Kilmarnock
    Ayrshire
    British61362350001
    SACK, Adam David
    115 Broadhurst Gardens
    NW6 3BJ London
    Amministratore
    115 Broadhurst Gardens
    NW6 3BJ London
    British32459700002
    STANSFIELD, Neil Andrew
    The Laurels, Poets Way
    Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    Amministratore
    The Laurels, Poets Way
    Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    British79347560001
    WIEGMAN, Albert Edward Bernard
    17 Hills Avenue
    CB1 7UY Cambridge
    Amministratore
    17 Hills Avenue
    CB1 7UY Cambridge
    British7466220002
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    GRIPPERRODS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over credit balances
    Creato il 24 apr 1998
    Consegnato il 07 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The sum of £33,000 together with interest accrued now or to be held by national westmister bank PLC on an account numbered 94897077 and earmarked or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 13 gen 1998
    Consegnato il 21 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under this mortgage debenture or in connection with a counter indemnity of even date
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Eac Fund I Gp Limited
    Transazioni
    • 21 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 10 nov 1997
    Consegnato il 24 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The sum of £41,300 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 94897077 and earmarked or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge on discounted debts and a floating charge on the receipts of other debts
    Creato il 23 ott 1997
    Consegnato il 30 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an invoice discounting agreement (as therein defined) or otherwise
    Brevi particolari
    Fixed equitable charge (I) all debts the subject of an invoice discounting agreement between the company and the chargee that fail to vest in the chargee and all rights in favour of the company related to such debts and (ii) all other amounts owing and all rights relating to such amounts, floating charge such of the moneys received in respect of amounts referred to in (ii) above as shall stand released from the fixed equitable charge.
    Persone aventi diritto
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transazioni
    • 30 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 05 giu 1995
    Consegnato il 17 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as arleshaw limited) to the chargee under the terms of a credit sale agreement dated 12TH september 1991 and a novation agreement dated 5TH june 1995
    Brevi particolari
    The sponge rubber underlay production line situated at the company's premises at walkmill lane, cannock, staffordshire.
    Persone aventi diritto
    • Mercat Industrial Limited
    Transazioni
    • 17 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 21 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 giu 1995
    Consegnato il 15 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as arleshaw limited) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Factory warehouse and office premises forming part of the industrial estate at walkmill lane cannock staffordshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GRIPPERRODS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 ago 2013Inizio della liquidazione
    06 feb 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Asher Miller
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London
    Praticante
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0